INBIS TECHNOLOGY LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামINBIS TECHNOLOGY LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00710001
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    INBIS TECHNOLOGY LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    INBIS TECHNOLOGY LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    1 The Brooms
    Emersons Green
    BS16 7FD Bristol
    Avon
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    INBIS TECHNOLOGY LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    RICARDO AEROSPACE LIMITED২০ জানু, ১৯৯২২০ জানু, ১৯৯২
    SAC TECHNOLOGY LIMITED২০ সেপ, ১৯৮৫২০ সেপ, ১৯৮৫
    S.A.C. TECHNOLOGY GROUP LIMITED ১৫ ডিসে, ১৯৮২১৫ ডিসে, ১৯৮২
    S.A.C.BRISTOL LIMITED০৭ ডিসে, ১৯৬১০৭ ডিসে, ১৯৬১

    INBIS TECHNOLOGY LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৬

    INBIS TECHNOLOGY LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    ১৮ ফেব, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৮ ফেব, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১০ মার্চ, ২০১৬

    ১০ মার্চ, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 500,000
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৮ ফেব, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২০ ফেব, ২০১৫

    ২০ ফেব, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 500,000
    SH01

    ১৬ আগ, ২০১৩ তারিখে David Richard Bradley-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৮ ফেব, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৭ ফেব, ২০১৪

    ২৭ ফেব, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 500,000
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Christopher Pearce এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৮ ফেব, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৮ ফেব, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৮ ফেব, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৮ ফেব, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    ০১ জানু, ২০১০ তারিখে Eur Ing Christopher Michael Pearce-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ জানু, ২০১০ তারিখে Michael John Sheehan-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    INBIS TECHNOLOGY LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    CAUNCE, David Christopher
    Sunnyside
    Cottage Lane Croston
    PR26 9JJ Preston
    সচিব
    Sunnyside
    Cottage Lane Croston
    PR26 9JJ Preston
    British58394380003
    BRADLEY, David Richard
    Hall Lane
    Wrightington
    WN6 9EN Wigan
    Four Acres
    Lancashire
    England
    পরিচালক
    Hall Lane
    Wrightington
    WN6 9EN Wigan
    Four Acres
    Lancashire
    England
    United KingdomBritishDept Managing Director24337370003
    CAUNCE, David Christopher
    Sunnyside
    Cottage Lane Croston
    PR26 9JJ Preston
    পরিচালক
    Sunnyside
    Cottage Lane Croston
    PR26 9JJ Preston
    United KingdomBritishFinance Director58394380003
    SHEEHAN, Michael John
    Sunnybank 4a Province Lane
    Long Ashton
    BS41 9DG Bristol
    Avon
    পরিচালক
    Sunnybank 4a Province Lane
    Long Ashton
    BS41 9DG Bristol
    Avon
    EnglandBritishDirector108094890001
    EDE, Helen Lesley
    84 Aubrey Road
    Bedminster
    BS3 3EU Bristol
    Avon
    সচিব
    84 Aubrey Road
    Bedminster
    BS3 3EU Bristol
    Avon
    British31688980002
    GOODBURN, Andrew Robert
    Deacons Hay
    Beaconsfield Road Chelwood Gate
    RH17 7LG Redhill
    Sussex
    সচিব
    Deacons Hay
    Beaconsfield Road Chelwood Gate
    RH17 7LG Redhill
    Sussex
    BritishFinance Director38653170001
    PATEL, Bipin
    58 Colebridge Avenue
    GL2 0RH Longlevens
    Gloucestershire
    সচিব
    58 Colebridge Avenue
    GL2 0RH Longlevens
    Gloucestershire
    British97984440001
    WILKINSON, Terry
    4 Red House Lane
    BS9 3RY Westbury On Trym
    Avon
    সচিব
    4 Red House Lane
    BS9 3RY Westbury On Trym
    Avon
    British33959840001
    BAKER, John Barrie
    Walsall Road
    B74 4QA Sutton Coldfield
    219
    West Midlands
    পরিচালক
    Walsall Road
    B74 4QA Sutton Coldfield
    219
    West Midlands
    United KingdomBritishManaging Director42982690001
    BELL, John Maclean
    Tower House
    Charlton Road, Holcombe
    BA3 5EW Bath
    Avonmouth
    পরিচালক
    Tower House
    Charlton Road, Holcombe
    BA3 5EW Bath
    Avonmouth
    BritishCommercial Director34179480001
    BODNAR, Adam Antal
    Tanners House
    Tanners Hill
    SN16 0NB Sherston
    Wiltshire
    পরিচালক
    Tanners House
    Tanners Hill
    SN16 0NB Sherston
    Wiltshire
    BritishManaging Director88233670001
    DAVIES, Richard Thomas
    11 Sydney Place
    BA2 6NF Bath
    Avon
    পরিচালক
    11 Sydney Place
    BA2 6NF Bath
    Avon
    BritishDirector37079410001
    EVANS, Douglas Herbert
    Portelet 25 Foley Avenue
    Tettenhall Wood
    WV6 8LX Wolverhampton
    Staffordshire
    পরিচালক
    Portelet 25 Foley Avenue
    Tettenhall Wood
    WV6 8LX Wolverhampton
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector36973820001
    GOODBURN, Andrew Robert
    Deacons Hay
    Beaconsfield Road Chelwood Gate
    RH17 7LG Redhill
    Sussex
    পরিচালক
    Deacons Hay
    Beaconsfield Road Chelwood Gate
    RH17 7LG Redhill
    Sussex
    EnglandBritishFinance Director38653170001
    HEAMAN, Jennifer Anne
    Beta
    Beta Post Office Lane, Flax Bourton
    BS48 3PZ Bristol
    পরিচালক
    Beta
    Beta Post Office Lane, Flax Bourton
    BS48 3PZ Bristol
    United KingdomBritishManaging Director1034220003
    IVES, Anthony Reginald
    Drovers Cottage
    Valley Road
    DT11 9JE Tarrant Keyneystone
    Dorset
    পরিচালক
    Drovers Cottage
    Valley Road
    DT11 9JE Tarrant Keyneystone
    Dorset
    BritishEngineer33959810001
    LAWTON, Robert William
    West Hayes
    Sandlea Close
    SN14 7JR Yatton Keynell
    পরিচালক
    West Hayes
    Sandlea Close
    SN14 7JR Yatton Keynell
    United KingdomBritishDirector86369990001
    LEIGH, Ian
    6 Penrice Fold
    Ellenbrook
    M28 1ZB Worsley
    পরিচালক
    6 Penrice Fold
    Ellenbrook
    M28 1ZB Worsley
    EnglandBritishAccountant58629350001
    OAKES, Andrew Thomas
    83 Lakewood Road
    Chandlers Ford
    SO53 5AD Eastleigh
    Hampshire
    পরিচালক
    83 Lakewood Road
    Chandlers Ford
    SO53 5AD Eastleigh
    Hampshire
    BritishCompany Director67816220001
    PEARCE, Christopher Michael, Eur Ing
    4 High Meadow
    The Wheatridge
    GL4 4DG Gloucester
    Gloucestershire
    পরিচালক
    4 High Meadow
    The Wheatridge
    GL4 4DG Gloucester
    Gloucestershire
    EnglandBritishTechnical Director37897850002
    TORKINGTON, Peter
    10 Stokefield Close
    Thornbury
    BS12 1HE Bristol
    Avon
    পরিচালক
    10 Stokefield Close
    Thornbury
    BS12 1HE Bristol
    Avon
    BritishEngineer18016580001
    WELLS, Philip Henry
    188 Stoke Lane
    Westbury On Trym
    BS9 3RU Bristol
    Avon
    পরিচালক
    188 Stoke Lane
    Westbury On Trym
    BS9 3RU Bristol
    Avon
    BritishEngineer2401320001
    WILKINSON, Terry
    4 Red House Lane
    BS9 3RY Westbury On Trym
    Avon
    পরিচালক
    4 Red House Lane
    BS9 3RY Westbury On Trym
    Avon
    BritishAccountant33959840001

    INBIS TECHNOLOGY LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Assystem Uk Ltd
    Club Street
    Bamber Bridge
    PR5 6FN Preston
    Club Street
    England
    ৩০ জুন, ২০১৬
    Club Street
    Bamber Bridge
    PR5 6FN Preston
    Club Street
    England
    না
    আইনি ফর্মLimited Company
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষLimited Company
    নিবন্ধিত স্থানEngland And Wales
    নিবন্ধন নম্বর1147167
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।

    INBIS TECHNOLOGY LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    All assets debenture deed
    তৈরি করা হয়েছে ২১ আগ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ আগ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ২২ আগ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ জুল, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ ডিসে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ ডিসে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ ডিসে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ জুল, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    General assignment agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ মে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ জুন, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company (formerly known as ricardo aerospace limited) to the chargee under or in connection with the loan (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All their present and future receivables (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Banque Indosuez
    ব্যবসায়
    • ০৩ জুন, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ অক্টো, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Share pledge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ মার্চ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ মার্চ, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The company's obligations to the chargee under the terms of a facility agreement and a guarantee and debenture both dated 6TH february 1997
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    In particular including bearer shares of 1,000 swiss francs which the pledgor owns in ricardo consultants ag all claims documents and title holdings coins bank notes and other objects of value. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Banque Indosuez
    ব্যবসায়
    • ২৫ মার্চ, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ অক্টো, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee and debenture, made between inbis group limited (as principal borrower) (1), the other companies listed in part ii of the attached schedule (as borrowers) (2) and banque indosuez (the "bank") (3), issued by the company
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ ফেব, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ ফেব, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or by any other group company (including any other company) to the chargee in any currency, and whether or not the chargee shall have been an original party to the relevant transaction, under the terms and contiditions contained in this guarantee and debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Registered property - f/h- club street works club street bamber bridge preston PR5 5FN, t/n-LA578544, proprietor - ricardo properties limited. L/h-part of the lower ground floor st john's house st john's square wolverhampton WV2 4LS t/n-SF38751, proprietor - ricardo aerospace limited. Unregistered property - part of ground floor norman house heritage gate derby, proprietor - ricardo aerospace limited.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Banque Indosuez
    ব্যবসায়
    • ১২ ফেব, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ অক্টো, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deposit agreement
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ মার্চ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ এপ্রি, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to becoem due from the company to lloyds bank PLC under the terms of the deposit agreement.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the rights to the repayment of the deposit as the company then had under the terms upon which the deposit was made and the provisions contained in the agreement. Please see doc for further details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ এপ্রি, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ ফেব, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Letter of set-off
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ জুল, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জুল, ১৯৮৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with lloyds bank PLC.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ জুল, ১৯৮৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১১ ফেব, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ আগ, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ সেপ, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Leasehold brunswick house upper york street bristol.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ সেপ, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    Letter of set-off
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ মার্চ, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ মার্চ, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or s a c consultants limited to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sums standing to the credit of any present or future accounts of the company.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ মার্চ, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১১ ফেব, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Letter of set-off
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ ডিসে, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ ডিসে, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with lloyds bank PLC.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ ডিসে, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0