ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00712831
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7011) /
    • (7415) /

    ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    c/o BEGBIES TRAYNOR (CENTRAL) LLP
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    E & G ESTATES LIMITED২২ জানু, ১৯৯০২২ জানু, ১৯৯০
    ESTATES AND GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED৩১ ডিসে, ১৯৭৮৩১ ডিসে, ১৯৭৮
    S.E.E.DEVELOPMENTS(BEDFORD)LIMITED১২ জানু, ১৯৬২১২ জানু, ১৯৬২

    ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০০৯

    ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    20 পৃষ্ঠাLIQ14

    ১০ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    ২০ জানু, ২০১৮ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    22 পৃষ্ঠাLIQ03

    ১০ সেপ, ২০১৭ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    ০৮ আগ, ২০১৭ তারিখে সচিব হিসাবে F & C Reit (Corporate Services) Limited এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    ১০ মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    ২০ জানু, ২০১৭ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    19 পৃষ্ঠা4.68

    ১০ সেপ, ২০১৬ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    1 পৃষ্ঠা3.6

    ১১ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Christopher George White এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    ১০ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    ২০ জানু, ২০১৬ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    19 পৃষ্ঠা4.68

    ১০ সেপ, ২০১৫ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    ১০ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    ২০ জানু, ২০১৫ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    18 পৃষ্ঠা4.68

    ১০ সেপ, ২০১৪ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    3 পৃষ্ঠা3.6

    ২৬ সেপ, ২০১৪ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা C/O Begbies Traynor 32 Cornhill London EC3V 3BT England থেকে C/O Begbies Traynor (Central) Llp 31St Floor 40 Bank Street London E14 5NRপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    রিসিভার বা ম্যানেজারের নিযুক্তি

    4 পৃষ্ঠাRM01

    রিসিভার বা ম্যানেজার হিসাবে কাজ করা বন্ধ করার নোটিশ

    4 পৃষ্ঠাRM02

    ১০ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    ২০ জানু, ২০১৪ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    18 পৃষ্ঠা4.68

    ১০ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    3 পৃষ্ঠা3.6

    ২০ জানু, ২০১৩ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    19 পৃষ্ঠা4.68

    ১০ সেপ, ২০১২ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    3 পৃষ্ঠা3.6

    ১০ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    3 পৃষ্ঠা3.6

    ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BENADY, Maurice Moses
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    পরিচালক
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    GibraltarBritish69435160001
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    কর্পোরেট পরিচালক
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর6745658
    135316290001
    HOLLAND, Philip John
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    সচিব
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    British74688330002
    ROBERTS, Geoffrey Michael
    Brenchley 8 Hamilton Road
    DA15 7HB Sidcup
    Kent
    সচিব
    Brenchley 8 Hamilton Road
    DA15 7HB Sidcup
    Kent
    British29217560001
    WHITE, Christine
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    সচিব
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    British74900200002
    F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    কর্পোরেট সচিব
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর3143222
    79571870006
    BLOOMFIELD, David William
    Hillcroft
    The Drive Harefield Place
    UB10 8AQ Ickenham
    Middlesex
    পরিচালক
    Hillcroft
    The Drive Harefield Place
    UB10 8AQ Ickenham
    Middlesex
    British7927670001
    CLEGG, Barry Stuart
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    পরিচালক
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish11296610002
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    পরিচালক
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    British84076630001
    DOSSETT, Roger John
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish116927100001
    HOLLAND, Philip John
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    পরিচালক
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritish163838050001
    MALONE, Kenneth Daniel
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British60687110001
    TAYLOR, Robert Patrick
    Lanreath Ditton Hill
    KT6 5EH Surbiton
    Surrey
    পরিচালক
    Lanreath Ditton Hill
    KT6 5EH Surbiton
    Surrey
    EnglandBritish7862560003
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    পরিচালক
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish80132540006
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    কর্পোরেট পরিচালক
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Tenth supplemental trust deed
    তৈরি করা হয়েছে ১২ মে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ মে, ২০০৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Certain houses and shops bearing the numbers 17 and a half, 19 and 21 ''beresford street'' in the parish of st helier vingtaine de haut de la ville in the island of jersey by way of floating charge its undertaking and all its property and assets present and future wheresoever including any uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Capita Irg Trustees Limited
    ব্যবসায়
    • ১৫ মে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • 2১৫ মার্চ, ২০১১একজন প্রাপক বা ম্যানেজার নিয়োগ (LQ01)
    • 2১০ জুন, ২০১৪একজন প্রাপক বা ম্যানেজার হিসাবে কাজ করা বন্ধ করার নোটিশ (RM02)
    • 2১০ জুন, ২০১৪একজন প্রাপক বা ম্যানেজার নিয়োগ (RM01)
      • মামলা নম্বর 2
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ সেপ, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ সেপ, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of fixed charge the real property other than the real property listed in part ii of schedule 2 of the debenture; all plant and machinery etc. and all related property rights; all debts; all of its securities and intellectual property rights; all goodwill and uncalled capital; and the insurance policies and the insurance proceeds. By way of assignment the insurance policies and the insurance proceeds; all rental income; any guarantee of rental income contained in or relating to any lease document; any hedging arrangements; each managing agent agreement; and each building contract and all related property rights. By way of first floating charge (I) the whole of its assets present and future and (ii) the whole of its assets situated in scotland.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hypo Real Estate Bank International (The "Security Trustee")
    ব্যবসায়
    • ২৯ সেপ, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Supplemental debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ আগ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ আগ, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties (as defined in the composite guarantee and mortgage debenture), the payment and discharge of which are the subject of covenants, undertakings, guarnatees, and agreements contained in the composite guarantee and mortgage debenture and the supplemental debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H hayle business park and land adjoining marsh lane hayle cornwall t/n-CL65486 and all property k/a bluebell estate acklam middlesborough cleveland being all that f/h land being 5 to 15A medina gardens 2 to 10A romanby gardens and 13 to 11A lowlane acklam t/n-CE70014 (see form 395 for full details of property charged).. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ আগ, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ অক্টো, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১২ আগ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ আগ, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from estates & general PLC and/or the company to the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a or being 1-12A hillel walk,7-21 otterburn gardens and other properties (see form 395 for full details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৪ আগ, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ মে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১২ আগ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ আগ, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and by estates & general PLC to the governor and company of the bank of scotland
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property k/a plots 87-94 (inclusive) 100 102 104 and 110-113 (inclusive) the croft water lane cornwall.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৭ আগ, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ মে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১২ আগ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ আগ, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and estates & general PLC to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The property k/a hayle industrial park and hayle retail park marsh lane hayle cornwall other than plots 3 9 15 and 16 hayle industrial park and an area of 7. 92 square metres.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৭ আগ, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ মে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ আগ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ আগ, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to national westminster bank PLC as "security trustee" for itself and the secured parties (all as defined therein) and to the secured parties (all as defined therein)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ আগ, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Equitable mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জানু, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ ফেব, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from estates & general PLC to the chargee on anyaccount whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Freehold property at marsh lane,hayle,cornwall and k/a hayle ind' park & retail park see doc M284C for details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৪ ফেব, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ মে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Equitable mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জানু, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ ফেব, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from estates & general PLC to the chargee on anyaccount whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a 1-12A hillel walk,7-21 otterburn gdns',and 2-30A samaria gdns',acklam,middlesborough.t/n CE70053 5-15A medina gdns',2-10A romanby gdns' & 3-11 low lane,acklam,middlesborough.t/n CR70014.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৪ ফেব, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ মে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Equitable mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জানু, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ ফেব, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from estates & general PLC to the chargee on anyaccount whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land k/a plots 87-94,100,102,104,and 110-113 the croft,water lane,hayle,cornwall.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৪ ফেব, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ জুল, ১৯৯৮বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১০ মে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ ডিসে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ ডিসে, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a 53-56 bartholomew street, land at 1 st. Nicholas street and st. Michaels road, newbury, berkshire title nos. BK260821 and BK280608.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩১ ডিসে, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ জুল, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ মার্চ, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ মার্চ, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys due or to become due from estates & general PLC to the chargee on any account whatsoever.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    16,18 and 20 bridge street, leatherhead and land adjoining 20 bridge street leatherhead and/or the proceeds of sale thereof t/n sy 336363, sy 485260, sy 357147 and sy 446734. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ মার্চ, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ মে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Letter confirming deposit of deeds by way of equitable charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ জুল, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ আগ, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from estates and general PLC to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Prestwood house high wycombe.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ আগ, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৩ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Equitable charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ জুল, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ জুল, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from estates and general investments PLC to the chargee on any account whatsoever.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a ward house, corporation street and castle street, high wycombe.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৭ জুল, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৩ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২২ জানু, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ জানু, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys due or to become due from estates and general investments public limited company to the chargee on any account whatsoever.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a 54/56 high street alfreton derbyshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ জানু, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৩ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১০ নভে, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ নভে, ১৯৮৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H 14,20,22,24 & 26 south street, dorking in the district of mole valley, surrey title no sy 485678 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ নভে, ১৯৮৩একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৩ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ আগ, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ আগ, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property known as blocks a and b, second way avonmouth industrial estate, avonmouth title no av 90348 and av 90349 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩১ আগ, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৩ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ আগ, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ আগ, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H mccelland house, (formerly the power house) headstone lane, harrow. Title no ngl 248936 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩১ আগ, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৩ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ জুন, ১৯৮৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ জুন, ১৯৮৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a little horwood manor nr bletchley, bucks and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৮ জুন, ১৯৮৩একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ মে, ১৯৮৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জুন, ১৯৮৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Second third, and fourth floors 18, 18A and 18B white lion street, norwich, norfolk.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Allied Irish Investment Bank Limited
    ব্যবসায়
    • ০৬ জুন, ১৯৮৩একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৩ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ মে, ১৯৮৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ মে, ১৯৮৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Castle hotel, castle meadow, norwich, norfolk title no:- nk 42785. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Allied Irish Investment Bank Limited
    ব্যবসায়
    • ১৬ মে, ১৯৮৩একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৩ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ জুল, ১৯৮১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ মে, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H k/a brook way leatherhead surrey title nos sy 327047 and sy 357185.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৮ মে, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৩ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২১ জানু, ২০১১ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ০৪ জানু, ২০১৯ভেঙে গেছে
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Kirstie Jane Provan
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    অভ্যাসকারী
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Mark Robert Fry
    Begbies Traynor Central Llp
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    অভ্যাসকারী
    Begbies Traynor Central Llp
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    2রিসিভার/ম্যানেজার নিযুক্ত
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Nicholas Guy Edwards
    Deloitte Llp Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    রিসিভার ম্যানেজার
    Deloitte Llp Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Louise Mary Brittain
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    রিসিভার ম্যানেজার
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Lee Antony Manning
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    রিসিভার ম্যানেজার
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0