D.J. SMITH LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামD.J. SMITH LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00713493
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    D.J. SMITH LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নতুন গাড়ি এবং হালকা মোটরযান বিক্রয় (45111) / হোলসেল এবং খুচরা বিক্রয়; মোটর গাড়ি এবং মোটরসাইকেল মেরামত

    D.J. SMITH LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    First Floor Unit 3140 Park Square Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    D.J. SMITH LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৯

    D.J. SMITH LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    1 পৃষ্ঠাDS01

    ০৭ ডিসে, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    ২৯ জানু, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Thomas Andrew Dale এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৭ ডিসে, ২০১৯ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    ২০ সেপ, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Elizabeth Louise Hancox এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৪ জুল, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Thomas Andrew Dale-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০৪ জুল, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Anton Clive Jeary এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৭ ডিসে, ২০১৮ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ০১ নভে, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Dr Elizabeth Louise Hancox-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২১ সেপ, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Claire Louise Catlin এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ সেপ, ২০১৮ তারিখে Mrs Claire Louise Catlin-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    ০১ এপ্রি, ২০১৮ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Smith Knight Fay (Holdings) Limited এর বিবরণের পরিবর্তন

    5 পৃষ্ঠাPSC05

    ০১ এপ্রি, ২০১৮ তারিখে Inchcape Uk Corporate Management Limited-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH04

    ০৯ এপ্রি, ২০১৮ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Inchcape House Langford Lane Kidlington Oxford OX5 1HT থেকে First Floor Unit 3140 Park Square Solihull Parkway Birmingham Business Park Birmingham B37 7YNপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    ০৭ ডিসে, ২০১৭ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    ০৭ ডিসে, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    ২৩ সেপ, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mrs Claire Louise Catlin-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৯ জানু, ২০১৬ তারিখে Mr Martin Peter Wheatley-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH01

    D.J. SMITH LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    INCHCAPE UK CORPORATE MANAGEMENT LIMITED
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইউকে লিমিটেড কোম্পানি
    নিবন্ধন নম্বর5200589
    100307260071
    WHEATLEY, Martin Peter
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    পরিচালক
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    EnglandBritishCompany Secretary55180460002
    BEACHAM, Mark Derrick
    Austwick Lane
    Emerson Valley
    MK4 2DR Milton Keynes
    11
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    সচিব
    Austwick Lane
    Emerson Valley
    MK4 2DR Milton Keynes
    11
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British135313320001
    BROOKES, Jane Mary
    Roseleigh
    218 Buxton Road
    SK10 1NF Macclesfield
    Cheshire
    সচিব
    Roseleigh
    218 Buxton Road
    SK10 1NF Macclesfield
    Cheshire
    British82015160002
    HARRIS, John Laurence
    42 Lakelands Close
    SK10 1RF Macclesfield
    Cheshire
    সচিব
    42 Lakelands Close
    SK10 1RF Macclesfield
    Cheshire
    BritishAccountant2536390002
    PERRING, James Stephen
    Holly Tree House 55 Grimshaw Lane
    Bollington
    SK10 5NB Macclesfield
    Cheshire
    সচিব
    Holly Tree House 55 Grimshaw Lane
    Bollington
    SK10 5NB Macclesfield
    Cheshire
    BritishSales Executive48879120001
    SMITH, Donald James
    Birch Hall
    New Mills Road Birch Vale
    SK12 5BT Via Stockport
    Cheshire
    সচিব
    Birch Hall
    New Mills Road Birch Vale
    SK12 5BT Via Stockport
    Cheshire
    British11978860001
    CATLIN, Claire Louise
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    পরিচালক
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    EnglandBritishCompany Director214958450002
    DALE, Thomas Andrew
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    পরিচালক
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    United KingdomBritishCompany Director260286850001
    GASCOYNE, William Owen
    12 Alms Hill Drive
    S11 9QY Sheffield
    South Yorkshire
    পরিচালক
    12 Alms Hill Drive
    S11 9QY Sheffield
    South Yorkshire
    BritishCompany Sales Director23310670001
    HANCOX, Elizabeth Louise, Dr
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    পরিচালক
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    United KingdomBritishCompany Director210216760001
    HARRIS, John Laurence
    42 Lakelands Close
    SK10 1RF Macclesfield
    Cheshire
    পরিচালক
    42 Lakelands Close
    SK10 1RF Macclesfield
    Cheshire
    United KingdomBritishAccountant2536390002
    JEARY, Anton Clive
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    পরিচালক
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    EnglandBritishAccountant169892630001
    KNIGHT, Graham George
    Blake Hall
    Briargrove Road Thornsett
    SK22 1AY High Peak
    Derbyshire
    পরিচালক
    Blake Hall
    Briargrove Road Thornsett
    SK22 1AY High Peak
    Derbyshire
    EnglandBritishGarage Proprietor141593430001
    MCCLUSKEY, Ross
    Langford Lane
    Kidlington
    OX5 1HT Oxford
    Inchcape House
    পরিচালক
    Langford Lane
    Kidlington
    OX5 1HT Oxford
    Inchcape House
    United KingdomBritishCompany Director165677350002
    MCCORMACK, Connor
    New College House
    Alchester Road
    OX26 1UN Chesterton
    Oxfordshire
    পরিচালক
    New College House
    Alchester Road
    OX26 1UN Chesterton
    Oxfordshire
    United KingdomBritishFinance Director108832810002
    PALMER, Richard Terence
    Littlethorpe
    Cleeve Road
    RG8 9BJ Goring
    পরিচালক
    Littlethorpe
    Cleeve Road
    RG8 9BJ Goring
    EnglandBritishChief Executive16571890002
    PERRING, James Stephen
    Holly Tree House 55 Grimshaw Lane
    Bollington
    SK10 5NB Macclesfield
    Cheshire
    পরিচালক
    Holly Tree House 55 Grimshaw Lane
    Bollington
    SK10 5NB Macclesfield
    Cheshire
    BritishSales Executive48879120001
    RONCHETTI, Marc Arthur
    New Road
    Croxley Green
    WD3 3EP Rickmansworth
    22
    Hertfordshire
    পরিচালক
    New Road
    Croxley Green
    WD3 3EP Rickmansworth
    22
    Hertfordshire
    EnglandBritishAccountant123180830001
    SMITH, Beryl
    Ravenslack House
    Hayfield Road Birch Vale
    SK12 Via Stockport
    Cheshire
    পরিচালক
    Ravenslack House
    Hayfield Road Birch Vale
    SK12 Via Stockport
    Cheshire
    BritishVehicle Sales Executive11978870001
    SMITH, Christopher Donald
    Ravensworth
    Carlisle Road
    SK17 6XE Buxton
    Derbyshire
    পরিচালক
    Ravensworth
    Carlisle Road
    SK17 6XE Buxton
    Derbyshire
    EnglandBritishVehicle Sales Executive11978880002
    SMITH, Donald James
    Birch Hall
    New Mills Road Birch Vale
    SK12 5BT Via Stockport
    Cheshire
    পরিচালক
    Birch Hall
    New Mills Road Birch Vale
    SK12 5BT Via Stockport
    Cheshire
    BritishGarage Proprietor11978860001
    WILSON, Ann Chrisette
    The Kingswood Ridgemount Road
    SL5 9RW Sunningdale
    Berkshire
    পরিচালক
    The Kingswood Ridgemount Road
    SL5 9RW Sunningdale
    Berkshire
    EnglandBritishFinance Director14811650002

    D.J. SMITH LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Smith Knight Fay (Holdings) Limited
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    United Kingdom
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    United Kingdom
    না
    আইনি ফর্মLimited By Shares
    নিবন্ধিত দেশEngland And Wales
    আইনি কর্তৃপক্ষUnited Kingdom
    নিবন্ধিত স্থানUnited Kingdom Companies House
    নিবন্ধন নম্বর1286316
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    D.J. SMITH LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ অক্টো, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ অক্টো, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land at the west side of beech lane macclesfield cheshire t/n CH370846. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ অক্টো, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ অক্টো, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ অক্টো, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ অক্টো, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ অক্টো, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ অক্টো, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ অক্টো, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    General charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ মে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ মে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the assets of the company of whatsoever nature both present and future (including uncalled capital).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Volkswagen Financial Services (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ১৪ মে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ ফেব, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ জুন, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জুল, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All f/h land situated and k/a links garage beech bank beech lane macclesfield cheshire t/no:- CH370783 and t/no:- CH370846. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Volkswagen Financial Services (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ০৯ জুল, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ ফেব, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ আগ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ আগ, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All present and future stock of new and used motor vehicles and all rights,title and interest therein; all moneys payable under any insurance and all goods given in exchange for motor vehicles. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Volkswagen Financial Services (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ০৫ আগ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ ফেব, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ আগ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ আগ, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/Hold known as links garage,fairfield,buxton,derbyshire. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Volkswagen Financial Services (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ০৫ আগ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ মে, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ মার্চ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All those monies which may from time to time be owing to the company by V.A.G. (united kingdom) limited in respect of refunds of monies paid by or by the direction of the company to V.A.G. (united kingdom) limited by way of deposit on the acquisition of motor vehicles on a consignment basis.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Volkswagen Financial Services (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ২৬ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ ফেব, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ডিসে, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ জানু, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land on the south of the river east of the main railway line from macclesfield to stockport west of beech lane and north of beech bank macclesfield cheshire and proceeds of sale thereof together with. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ জানু, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ ফেব, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ এপ্রি, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ এপ্রি, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land at lightwood road buxton derbyshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Shell U.K. Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ এপ্রি, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ মার্চ, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১২ এপ্রি, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ এপ্রি, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ এপ্রি, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৭ ফেব, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জানু, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ ফেব, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    1 darkin avenue fairfield buxton derbyshire fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    ব্যবসায়
    • ০৫ ফেব, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৮ সেপ, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ জানু, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জানু, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H-land and premises in tongue lane buxton, derbyshire and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ জানু, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৫ সেপ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ জুন, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জুন, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Present & future stock of used motor vehicles & the chargor's rights title & interest therein (for full details see form 395).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bowmaker Limited
    ব্যবসায়
    • ০৯ জুন, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৩ ফেব, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ নভে, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ নভে, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £125,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee and any other company in the lloyds bowmaker finance group under the terms of the charge.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    0.5 acres of f/h land off tongue lane, fairfield, buxton, derbyshire. And land at the rear of property described in a conveyance dated 17.2.85.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bowmaker Limited.
    ব্যবসায়
    • ০৭ নভে, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৩ জুন, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১২ মার্চ, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ মার্চ, ১৯৮৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Ravenslack house, hayfield road, birch vale, derbyshire and or the proceeds of sale.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ মার্চ, ১৯৮৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৩ জুন, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১২ মার্চ, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ মার্চ, ১৯৮৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The police house, dakin avenue, buxton derbyshire & the proceeds of sale.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ মার্চ, ১৯৮৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৩ জুন, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ নভে, ১৯৮৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ ডিসে, ১৯৮৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H shire hill service station high street east glossop, derbyshire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ ডিসে, ১৯৮৩একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ ডিসে, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ জানু, ১৯৮৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H links garage, fairfield buxton, derbyshire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ জানু, ১৯৮৩একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৮ সেপ, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ ফেব, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ মার্চ, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Freehold links garage, fairfield, buxton, derby and garage premises formerly known as links garage, 36-40 (even nos) high street, east glossop, derby.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds & Scottish Trust Limited
    ব্যবসায়
    • ০১ মার্চ, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৩ জুন, ১৯৯৩বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২৮ মার্চ, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ মার্চ, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All those monies which may from time to time owing to the company by V.A.G. (united kingdom) limited in respect of refunds of monies paid by or by the direction of the company to V. A. G. (united kingdom) limited by way of deposit (see doc M42).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds and Scottish Trust Limited
    ব্যবসায়
    • ১০ মার্চ, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৩ ফেব, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ জুন, ১৯৮০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জুল, ১৯৮০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Leasehold land and buildings known as shire hill service station high street east, glossop derby. Together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Williams & Glyns Bank Limited
    ব্যবসায়
    • ০৪ জুল, ১৯৮০একটি চার্জের নিবন্ধন
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ ফেব, ১৯৭৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ ফেব, ১৯৭৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of fixed & floating charge (see doc M38). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ ফেব, ১৯৭৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৮ মার্চ, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জানু, ১৯৭৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ ফেব, ১৯৭৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £50,000
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Charge on monies deposited all those monies which may from time to time be owing to the company by volkswagen (GB) LTD in respect of the monies paid by or by the direction of the company to volkswagen (GB) LTD by way of a deposit on the acquisition of motor vehicles on a sale or returns basis.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Scottish Trust LTD
    ব্যবসায়
    • ০২ ফেব, ১৯৭৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৩ জুন, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0