PRECISION AIR CONTROL LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামPRECISION AIR CONTROL LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00779273
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    PRECISION AIR CONTROL LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য উৎপাদন (বিস্তারিত নির্দিষ্ট নয়) (32990) / উৎপাদন

    PRECISION AIR CONTROL LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    79 Caroline Street
    B3 1UP Birmingham
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    PRECISION AIR CONTROL LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৮

    PRECISION AIR CONTROL LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    8 পৃষ্ঠাLIQ13

    ১১ ডিসে, ২০১৯ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 11th Floor the Colmore Building 20 Colmore Circus Queensway Birmingham B4 6AT United Kingdom থেকে 79 Caroline Street Birmingham B3 1UPপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ০৪ ডিসে, ২০১৯ তারিখে

    LRESSP

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    6 পৃষ্ঠাLIQ01

    ১২ সেপ, ২০১৯ তারিখে Garry Elliot Barnes-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    59 পৃষ্ঠাAA

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত পরিদর্শন স্থান C/O Tmf Group 8th Floor, 20 Farringdon Street London EC4A 4AB এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD03

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা C/O Tmf Group 8th Floor, 20 Farringdon Street London EC4A 4AB এ পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    ২৫ জানু, ২০১৯ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    ১৯ জানু, ২০১৮ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    ২১ মার্চ, ২০১৭ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা The Colemore Building Colmore Circus Queensway Birmingham B4 6AT England থেকে 11th Floor the Colmore Building 20 Colmore Circus Queensway Birmingham B4 6ATপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ১৭ ডিসে, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    ০১ নভে, ২০১৬ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 5 Fleet Place London EC4M 7rd England থেকে The Colemore Building Colmore Circus Queensway Birmingham B4 6ATপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    ০৩ অক্টো, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Garry Elliot Barnes-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১২ সেপ, ২০১৬ তারিখে Jonathon Colin Fyfe Morgan-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    ১২ সেপ, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Matthew William Hughes এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১২ সেপ, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে Kevin William Donnelly এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ১২ সেপ, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Kevin William Donnelly এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১২ সেপ, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে Jonathon Colin Fyfe Morgan-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    ১২ সেপ, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Geoffrey Damien Morgan-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    PRECISION AIR CONTROL LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    CRAWFORD, Jonathon Colin Fyfe
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    Leconfield House
    United Kingdom
    সচিব
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    Leconfield House
    United Kingdom
    214012530002
    BARNES, Garry Elliot
    Caroline Street
    B3 1UP Birmingham
    79
    পরিচালক
    Caroline Street
    B3 1UP Birmingham
    79
    United KingdomBritishTreasurer215490920001
    CRAWFORD, Jonathon Colin Fyfe
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    Leconfield House
    United Kingdom
    পরিচালক
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    Leconfield House
    United Kingdom
    United KingdomAustralianLawyer214009850001
    MORGAN, Geoffrey Damien
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    Leconfield House
    United Kingdom
    পরিচালক
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    Leconfield House
    United Kingdom
    United KingdomBritishGroup Head Of Tax214010060001
    DONNELLY, Kevin William
    123 Abbott Road
    Wellesley
    Massachusetts 02481
    Usa
    সচিব
    123 Abbott Road
    Wellesley
    Massachusetts 02481
    Usa
    UsaVice-President General Counsel73249300002
    FORREST, Arthur Thomas
    Lawley
    Highlands Road
    GU9 0LX Farnham
    Surrey
    সচিব
    Lawley
    Highlands Road
    GU9 0LX Farnham
    Surrey
    British8427680001
    TRANTER, John
    11 Dickins Way
    RH13 6BQ Horsham
    West Sussex
    সচিব
    11 Dickins Way
    RH13 6BQ Horsham
    West Sussex
    British34350840002
    BEESON, Richard
    Percuil 24 Robins Grove
    CV34 6RF Warwick
    Warwickshire
    পরিচালক
    Percuil 24 Robins Grove
    CV34 6RF Warwick
    Warwickshire
    BritishFinance Director44855910004
    BREADY, Richard Lawrence
    166 President Avenue
    Providence
    Rhode Island 02906
    Usa
    পরিচালক
    166 President Avenue
    Providence
    Rhode Island 02906
    Usa
    UsaAmericanChairman And Chief Executive70952970001
    COONEY, Edward Joseph
    Kennedy Plaza
    02903 Providence
    50
    Ri
    Usa
    পরিচালক
    Kennedy Plaza
    02903 Providence
    50
    Ri
    Usa
    UsaUnited StatesVice President And Treasurer161515520001
    DONNELLY, Kevin William
    123 Abbott Road
    Wellesley
    Massachusetts 02481
    Usa
    পরিচালক
    123 Abbott Road
    Wellesley
    Massachusetts 02481
    Usa
    Massachusetts UsaUsaGeneral Counsel73249300002
    DONNELLY, Kevin William
    11 Foxhunt Trail
    Walpole
    Massachusetts
    02081
    Usa
    পরিচালক
    11 Foxhunt Trail
    Walpole
    Massachusetts
    02081
    Usa
    AmericanVice-President General Counsel73249300001
    FITTON, Andrew Charles
    The Cedars Scholards Lane
    Ramsbury
    SN8 2PL Marlborough
    Wiltshire
    পরিচালক
    The Cedars Scholards Lane
    Ramsbury
    SN8 2PL Marlborough
    Wiltshire
    BritishCompany Director7527160002
    FORREST, Arthur Thomas
    Lawley
    Highlands Road
    GU9 0LX Farnham
    Surrey
    পরিচালক
    Lawley
    Highlands Road
    GU9 0LX Farnham
    Surrey
    EnglandBritishManaging Director8427680001
    HALL, Almon Charles
    50 Kennedy Plaza
    02903 Providence
    Nortek Inc.
    Rhode Island
    Usa
    পরিচালক
    50 Kennedy Plaza
    02903 Providence
    Nortek Inc.
    Rhode Island
    Usa
    United States Of AmericaAmericanSenior Vice President And Cfo177890560001
    HUGHES, Matthew William, Mr.
    Exchange Street
    02903 Providence
    500
    Ri
    Usa
    পরিচালক
    Exchange Street
    02903 Providence
    500
    Ri
    Usa
    UsaAmericanTreasurer203597150001
    MARTIN, Gary Trevor
    34 Beauport Home Farm Close
    TN37 7BW St Leonards-On-Sea
    East Sussex
    পরিচালক
    34 Beauport Home Farm Close
    TN37 7BW St Leonards-On-Sea
    East Sussex
    United KingdomBritishManaging Director7625370002
    SAMS, Ian James
    Fircroft Way
    TN8 6EZ Edenbridge
    C/O Eaton-Williams Group Limited
    Kent
    England
    পরিচালক
    Fircroft Way
    TN8 6EZ Edenbridge
    C/O Eaton-Williams Group Limited
    Kent
    England
    EnglandBritishManaging Director141142710002
    STAPLEY, Gerald Charles
    Huntersgay Stables Mill Lane Cottage
    Petworth Road Witley
    GU8 5LZ Godalming
    Surrey
    পরিচালক
    Huntersgay Stables Mill Lane Cottage
    Petworth Road Witley
    GU8 5LZ Godalming
    Surrey
    EnglandBritishManaging Director57940460001
    TRANTER, John
    11 Dickins Way
    RH13 6BQ Horsham
    West Sussex
    পরিচালক
    11 Dickins Way
    RH13 6BQ Horsham
    West Sussex
    EnglandBritishFinance Director34350840002

    PRECISION AIR CONTROL LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Eaton-Williams Group Limited
    Colmore Circus Queensway
    B4 6AT Birmingham
    11th Floor, The Colmore Building
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Colmore Circus Queensway
    B4 6AT Birmingham
    11th Floor, The Colmore Building
    England
    না
    আইনি ফর্মLimited Company
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।

    PRECISION AIR CONTROL LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ জুন, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ জুন, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২০ জুন, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ জুন, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ আগ, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ আগ, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee of the credit agreement or any of the other financing document
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All companys, rights title benefit and interest to and in the deed of indemnity, see form 395 (ref 124) for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Canadian Imperial Bank of Commerceas Agent and Trustee for Each of the Beneficiaries
    ব্যবসায়
    • ১৫ আগ, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৭ জুন, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ ফেব, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ মার্চ, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    Collateral debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ ফেব, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ মার্চ, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from eaton-williams group limited to the chargee on any account whatsoever.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Investors in Industry PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ মার্চ, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ ফেব, ১৯৮৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ ফেব, ১৯৮৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over the company's estate or interest an all f/h or l/h properties and the proceeds of sale thereof. Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ ফেব, ১৯৮৩একটি চার্জের নিবন্ধন
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২২ জুন, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ জুল, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All moneys standing to the credit of the account at national bank of abu dhabi designated 'nbad bond margin account for PAC LTD' no 525832-3010 together with all interest due or to become due.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Bank of Abu Dhabi
    ব্যবসায়
    • ১২ জুল, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৭ জুন, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    PRECISION AIR CONTROL LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০৪ ডিসে, ২০১৯ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ১৭ নভে, ২০২০ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Roderick Graham Butcher
    79 Caroline Street
    B3 1UP Birmingham
    অভ্যাসকারী
    79 Caroline Street
    B3 1UP Birmingham

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0