SINDALL LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামSINDALL LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00779704
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    SINDALL LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ (41201) / নির্মাণ

    SINDALL LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    C/O Mazars Llp Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    SINDALL LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    SINDALL CONSTRUCTION LIMITED০৪ নভে, ১৯৬৩০৪ নভে, ১৯৬৩

    SINDALL LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৮

    SINDALL LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    13 পৃষ্ঠাLIQ13

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা Kent House 14-17 Market Place London W1W 8AJ এ পরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD02

    ২১ অক্টো, ২০১৯ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Kent House 14 - 17 Market Place London W1W 8AJ থেকে C/O Mazars Llp Tower Bridge House St Katharines Way London E1W 1DDপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    5 পৃষ্ঠাLIQ01

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ০৭ অক্টো, ২০১৯ তারিখে

    LRESSP

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    ১৭ জুন, ২০১৯ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    ১৭ জুন, ২০১৮ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    ১৭ জুন, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৭ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৭ জুন, ২০১৬

    ১৭ জুন, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2,900,000
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৯ জুল, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৮ আগ, ২০১৫

    ২৮ আগ, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2,900,000
    SH01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    36 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ গৃহীত করার রেজুলেশন

    RES01

    কোম্পানির উদ্দেশ্যের বিবৃতি

    2 পৃষ্ঠাCC04

    বার্ষিক রিটার্ন ১৯ জুল, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    সচিব হিসাবে Isobel Nettleship এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    পরিচালক হিসাবে Mr John Christopher Morgan-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Paul Whitmore এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৯ জুল, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৫ জুল, ২০১৩

    ২৫ জুল, ২০১৩ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    SH01

    SINDALL LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    SHERIDAN, Clare
    Kent House
    14 - 17 Market Place
    W1W 8AJ London
    সচিব
    Kent House
    14 - 17 Market Place
    W1W 8AJ London
    British74216410002
    CRUMMETT, Stephen Paul
    14-17 Market Place
    W1W 8AJ London
    Kent House
    United Kingdom
    পরিচালক
    14-17 Market Place
    W1W 8AJ London
    Kent House
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director177741840001
    MORGAN, John Christopher
    Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    C/O Mazars Llp
    পরিচালক
    Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    C/O Mazars Llp
    EnglandBritishDirector7146080002
    JOHNSTON, William Raymond
    9 Beverley Court
    59 Fairfax Road
    NW6 4EG London
    সচিব
    9 Beverley Court
    59 Fairfax Road
    NW6 4EG London
    British37227240001
    NETTLESHIP, Isobel Mary
    Kent House
    14 - 17 Market Place
    W1W 8AJ London
    সচিব
    Kent House
    14 - 17 Market Place
    W1W 8AJ London
    British147086990001
    AHEARN, Paul John
    The Croft
    Anglefield Road
    HP4 3JA Berkhamsted
    Hertfordshire
    পরিচালক
    The Croft
    Anglefield Road
    HP4 3JA Berkhamsted
    Hertfordshire
    BritishCompany Director39260100001
    ALDRIDGE, Walter John
    37 North Drive
    HP9 1TZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    37 North Drive
    HP9 1TZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishSenior Executive13576410001
    BENNETT, Arthur Haddon
    53 The Brambles Limes Park Road
    Hemingford Grey
    PE17 4NJ St Ives
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    53 The Brambles Limes Park Road
    Hemingford Grey
    PE17 4NJ St Ives
    Cambridgeshire
    BritishConstruction Executive13576420001
    BISHOP, John Michael
    Orchard View
    Tintells Lane
    KT24 6JD West Horsley
    Surrey
    পরিচালক
    Orchard View
    Tintells Lane
    KT24 6JD West Horsley
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director116243840001
    BRANDON, Julian Andrew
    Barnbrook Hall
    Barnardiston
    CB9 7TF Haverhill
    Suffolk
    পরিচালক
    Barnbrook Hall
    Barnardiston
    CB9 7TF Haverhill
    Suffolk
    United KingdomBritishCompany Director36014650002
    CARR, Ian
    8 Sheering Lower Road
    CM21 9LF Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    পরিচালক
    8 Sheering Lower Road
    CM21 9LF Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    EnglandBritishFinance Director41545670001
    CATHCART, Lyle, Mr.
    Windy Croft Bimbury Lane
    Detling
    ME14 3HY Maidstone
    Kent
    পরিচালক
    Windy Croft Bimbury Lane
    Detling
    ME14 3HY Maidstone
    Kent
    United KingdomBritishDirector13762940001
    CHAMBERS, Brian Peter
    Brookbridge Lane
    Datchworth
    SG3 6SU Knebworth
    9
    Hertfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Brookbridge Lane
    Datchworth
    SG3 6SU Knebworth
    9
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director128655490001
    COWAN, Peter
    10 Queen Anne Close
    Stotfold
    SG5 4LP Hitchin
    Hertfordshire
    পরিচালক
    10 Queen Anne Close
    Stotfold
    SG5 4LP Hitchin
    Hertfordshire
    BritishCommercial Director51118490001
    ELLIOTT, Stephen
    Flat 4
    26 Sloane Gardens
    SW1W 8DJ London
    পরিচালক
    Flat 4
    26 Sloane Gardens
    SW1W 8DJ London
    BritishJoint Managing Director74567130001
    ELSDEN, Terence John
    32 Cherry Orchard
    Fulbourn
    CB1 5EH Cambridge
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    32 Cherry Orchard
    Fulbourn
    CB1 5EH Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishSenior Executive90531810001
    FLETCHER, Charles
    2 Orchard Street
    Stow-Cum-Quy
    CB5 9AE Cambridge
    পরিচালক
    2 Orchard Street
    Stow-Cum-Quy
    CB5 9AE Cambridge
    BritishCompany Director34622420001
    FOSTER, Kevin
    63 Russet Drive
    Little Billing
    NN3 9TU Northampton
    পরিচালক
    63 Russet Drive
    Little Billing
    NN3 9TU Northampton
    BritishCompany Director80478330001
    GRIEVE, Marr
    24 Caxton Lane
    Foxton
    CB2 6SR Cambridge
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    24 Caxton Lane
    Foxton
    CB2 6SR Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishSenior Executive13538540001
    HALLIWELL, Brian Eric
    12 Park Lane
    Little Downham
    CB6 2TF Ely
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    12 Park Lane
    Little Downham
    CB6 2TF Ely
    Cambridgeshire
    BritishConstruction Executive13576400001
    HIBBERT, Matthew
    Kent House
    14 - 17 Market Place
    W1W 8AJ London
    পরিচালক
    Kent House
    14 - 17 Market Place
    W1W 8AJ London
    United KingdomBritishFinancial Controller138698110002
    HUGHES, Richard Anthony
    Newnham Hall Cottage
    Ashwell Road
    SG7 5JX Baldock
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Newnham Hall Cottage
    Ashwell Road
    SG7 5JX Baldock
    Hertfordshire
    BritishDirector103141730001
    JACKSON, Peter Raymond
    10 Dairy Lane
    Chainhurst
    TN12 9SP Marden
    Kent
    পরিচালক
    10 Dairy Lane
    Chainhurst
    TN12 9SP Marden
    Kent
    BritishDirector78532680001
    JOHNSTON, William Raymond
    9 Beverley Court
    59 Fairfax Road
    NW6 4EG London
    পরিচালক
    9 Beverley Court
    59 Fairfax Road
    NW6 4EG London
    BritishChartered Secretary37227240001
    MOORHOUSE, Barbara Jane
    Stoney Cross Lodge Ringwood Road
    Stoney Cross
    SO43 7GN Lyndhurst
    Hampshire
    পরিচালক
    Stoney Cross Lodge Ringwood Road
    Stoney Cross
    SO43 7GN Lyndhurst
    Hampshire
    EnglandBritishFinance Director42765940002
    MORGAN, John Christopher
    2 Fishermans Bank
    Mudeford
    BH23 3NP Christchurch
    Dorset
    পরিচালক
    2 Fishermans Bank
    Mudeford
    BH23 3NP Christchurch
    Dorset
    United KingdomBritishCompany Director7146080001
    MULLIGAN, David Kevin
    Kent House
    14 - 17 Market Place
    W1W 8AJ London
    পরিচালক
    Kent House
    14 - 17 Market Place
    W1W 8AJ London
    EnglandBritishDirector74215210003
    PETERS, John Neville
    40 Longstanton Road
    Oakington
    CB4 5AB Cambridge
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    40 Longstanton Road
    Oakington
    CB4 5AB Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishBuilding Estimator13576360001
    RUSSELL, John Charles Frederick
    2 Pease Way
    Histon
    CB4 9YZ Cambridge
    পরিচালক
    2 Pease Way
    Histon
    CB4 9YZ Cambridge
    BritishProperty Manager91411170001
    SAXTON, Christopher Anthony
    11 Warwick Drive
    WA15 9EA Hale
    Cheshire
    পরিচালক
    11 Warwick Drive
    WA15 9EA Hale
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director122948080001
    SKELDING, Neil
    14-17 Market Place
    W1W 8AJ London
    Kent House
    United Kingdom
    পরিচালক
    14-17 Market Place
    W1W 8AJ London
    Kent House
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director153156100001
    SLOAN, Alistair Thomas
    Tytherley
    Snowhill
    RH10 3EY Copthorne
    West Sussex
    পরিচালক
    Tytherley
    Snowhill
    RH10 3EY Copthorne
    West Sussex
    BritishChartered Accountant88523480003
    STODDART, Andrew Michael
    Old Place
    Tower Hill
    WD4 9LN Chipperfield
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Old Place
    Tower Hill
    WD4 9LN Chipperfield
    Hertfordshire
    BritishCompany Director5515420002
    TAIT, John Neville
    120 Boxworth End
    Swavesey
    CB4 5RA Cambridge
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    120 Boxworth End
    Swavesey
    CB4 5RA Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishSenior Executive13576370001
    WALTON, David
    5 Brookvale
    Hillside Road Upper Stondon
    SG16 6LL Henlow
    Bedfordshire
    পরিচালক
    5 Brookvale
    Hillside Road Upper Stondon
    SG16 6LL Henlow
    Bedfordshire
    CanadianMarketing Dir87218460003

    SINDALL LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    14-17 Market Place
    W1W 8AJ London
    Kent House
    United Kingdom
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    14-17 Market Place
    W1W 8AJ London
    Kent House
    United Kingdom
    না
    আইনি ফর্মPublic Limited Company (Listed)
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষUnited Kingdom (England)
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর00521970
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    SINDALL LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 29 april 1996 and
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ নভে, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ নভে, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ নভে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ সেপ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 29TH april 1996 and
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ ডিসে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ ডিসে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ সেপ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ অক্টো, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank Plcefined)(As Agent and Trustee for the Beneficiaries So D
    ব্যবসায়
    • ০৬ অক্টো, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ মে, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ অক্টো, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of floating charge all of the company's undertaking property assets and revenues both present and future.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • William Sindall Public Limited Company
    ব্যবসায়
    • ০৬ অক্টো, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ মে, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১০ জুন, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ জুন, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys due or to become due from william sindall PLC to the chargee on any account whatsoever.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of legal mortgage the f/h property k/as 53 norland square, london.t/no. 401410 together with all buildings and fixtures thereon. By way of assignment the goodwill of the business (if any) carried on by the company at the above premises.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ জুন, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ মে, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১০ জুন, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ জুন, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys due or to become due from william sindall PLC to the chargee on any account whatsoever.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of legal mortgage the f/h property k/as 152 holland park avenue, london. T/no. 269380 together with all buildings and fixtures thereon. By way of assignment the goodwill of the business (if any) carried on by the company at the above premises.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ জুন, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ মে, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ জানু, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ জানু, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from william sindall PLC to the chargee on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings on the west side of thornton road girton cambridge t/n CB650.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ জানু, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ সেপ, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ জানু, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ জানু, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from william sindall PLC to the chargee on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land having a frontage to trumpington road cambridge on which has been erected flats and garages known as gilmerton court.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ জানু, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ সেপ, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ এপ্রি, ১৯৭৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ এপ্রি, ১৯৭৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land having a frontage to trumpington rd., Cambridge on which have been erected flats garages now known as gilmerton court, together with all fixtures.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ এপ্রি, ১৯৭৩একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৪ জুল, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ ফেব, ১৯৭৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ মার্চ, ১৯৭৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due etc
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings on west side of thornton road, girton, cambridgeshire together with all fixtures.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ মার্চ, ১৯৭৩একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৮ জুল, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    SINDALL LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০৭ অক্টো, ২০১৯ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ১৬ সেপ, ২০২০ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Guy Robert Thomas Hollander
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    অভ্যাসকারী
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Simon David Chandler
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    অভ্যাসকারী
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0