PAYLESS DIY LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামPAYLESS DIY LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00783953
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    PAYLESS DIY LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7499) /

    PAYLESS DIY LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Greater Manchester
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    PAYLESS DIY LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    W.H. SMITH DO IT ALL LIMITED৩১ ডিসে, ১৯৭৮৩১ ডিসে, ১৯৭৮
    L.C.P. HOME IMPROVEMENTS LIMITED০৯ ডিসে, ১৯৬৩০৯ ডিসে, ১৯৬৩

    PAYLESS DIY LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে২১ ফেব, ২০১০

    PAYLESS DIY LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    খালি সম্পত্তি দাবিত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাBONA

    খালি সম্পত্তি দাবিত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাBONA

    খালি সম্পত্তি দাবিত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাBONA

    খালি সম্পত্তি দাবিত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাBONA

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ০১ মে, ২০১২ তারিখে প্রশাসন থেকে দ্রবণে স্থানান্তরের নোটিশ

    27 পৃষ্ঠা2.35B

    ০৪ নভে, ২০১১ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    38 পৃষ্ঠা2.24B

    প্রস্তাবগুলির অনুমোদিত অনুমোদনের নোটিশ

    96 পৃষ্ঠাF2.18

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    95 পৃষ্ঠা2.17B

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ 2.14B/2.15B

    9 পৃষ্ঠা2.16B

    ১৩ মে, ২০১১ তারিখে Mr William Grimsey-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH01

    প্রশাসক নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা2.12B

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    পরিচালক হিসাবে Brian Robbins এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    ১১ অক্টো, ২০১০ তারিখে Dawn Michelle Wilkinson-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH03

    ১১ অক্টো, ২০১০ তারিখে Thomas Christopher Morgan-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH01

    পরিচালক হিসাবে Richard Bird এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    ১১ অক্টো, ২০১০ তারিখে Mr Robert Patrick Gladwin-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH01

    ১১ অক্টো, ২০১০ তারিখে Brian Keith Robbins-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২১ ফেব, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Brian Keith Robbins-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    ০৩ জুন, ২০১০ পর্যন্ত রসিদ এবং অর্থপ্রদানের স্বেচ্ছাসেবী ব্যবস্থার সুপারভাইজারের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা1.3

    স্বেচ্ছাসেবী ব্যবস্থার সমাপ্তির নোটিশ

    2 পৃষ্ঠা1.4

    পরিচালক হিসাবে Thomas Christopher Morgan-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Andrew Unitt এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    PAYLESS DIY LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    WILKINSON, Dawn Michelle
    Westmere Drive
    CW1 6XB Crewe
    Gawsworth House
    Cheshire
    United Kingdom
    সচিব
    Westmere Drive
    CW1 6XB Crewe
    Gawsworth House
    Cheshire
    United Kingdom
    British105435010001
    GLADWIN, Robert Patrick
    Westmere Drive
    CW1 6XB Crewe
    Gawsworth House
    Cheshire
    পরিচালক
    Westmere Drive
    CW1 6XB Crewe
    Gawsworth House
    Cheshire
    United KingdomBritish130288970001
    GRIMSEY, William
    9 The Avenue
    WD7 7DG Radlett
    Tall Timbers
    Hertfordshire
    পরিচালক
    9 The Avenue
    WD7 7DG Radlett
    Tall Timbers
    Hertfordshire
    United KingdomBritish50647840004
    MORGAN, Thomas Christopher
    Westmere Drive
    CW1 6XB Crewe
    Gawsworth House
    Cheshire
    পরিচালক
    Westmere Drive
    CW1 6XB Crewe
    Gawsworth House
    Cheshire
    United KingdomBritish152428250002
    FENNELL, Sonia
    Gilliver Cottage Gilliver Lane
    Clipston On The Wolds
    NG12 5PD Nottingham
    সচিব
    Gilliver Cottage Gilliver Lane
    Clipston On The Wolds
    NG12 5PD Nottingham
    British9591230004
    HOSKINS, William
    11 Grange Court Road
    AL5 1BY Harpenden
    Hertfordshire
    সচিব
    11 Grange Court Road
    AL5 1BY Harpenden
    Hertfordshire
    British121893830001
    HUGHES, Gerard Maxwell
    53 Chesilton Road
    Fulham
    SW6 5AA London
    সচিব
    53 Chesilton Road
    Fulham
    SW6 5AA London
    British70698270002
    RIMMER, Barbara
    28 Chapel Lane
    Hale Barns
    WA15 0HN Altrincham
    Cheshire
    সচিব
    28 Chapel Lane
    Hale Barns
    WA15 0HN Altrincham
    Cheshire
    British76973560002
    STEVENS, Philip Alan
    31 Summit Drive
    IG8 8QW Woodford Green
    Essex
    সচিব
    31 Summit Drive
    IG8 8QW Woodford Green
    Essex
    British9581300001
    WILLIAMS, David Robert
    15 St Stephens Road
    CH42 8PP Prenton
    Merseyside
    সচিব
    15 St Stephens Road
    CH42 8PP Prenton
    Merseyside
    British157062220001
    WILSON, Geoffrey Charles
    Broadoaks
    237 Seabridge Lane
    ST5 3TB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    সচিব
    Broadoaks
    237 Seabridge Lane
    ST5 3TB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British72996700001
    ACKROYD, Keith
    32 Far Street
    Bradmore
    NG11 6PF Nottingham
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    32 Far Street
    Bradmore
    NG11 6PF Nottingham
    Nottinghamshire
    British9261020001
    ARCHER, William Ernest
    The Priory
    2 Astley Close
    WA16 8GJ Knutsford
    Cheshire
    পরিচালক
    The Priory
    2 Astley Close
    WA16 8GJ Knutsford
    Cheshire
    British15170380004
    BIRD, Richard Sidney
    80 Wolsey Road
    HA6 2EH Northwood
    Middlesex
    পরিচালক
    80 Wolsey Road
    HA6 2EH Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish111500210002
    BOWE, Alan Laurence
    Church View Farmhouse
    Church Lane, Osgathorpe
    LE12 9SY Loughborough
    Leicestershire
    পরিচালক
    Church View Farmhouse
    Church Lane, Osgathorpe
    LE12 9SY Loughborough
    Leicestershire
    British64241650002
    COHEN, John Alexander
    7 Rectory Gardens
    Wollaton
    NG8 2AR Nottingham
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    7 Rectory Gardens
    Wollaton
    NG8 2AR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish25406220001
    FIELD, Malcolm, Sir
    15 Eaton Terrace
    SW1W 9DD London
    পরিচালক
    15 Eaton Terrace
    SW1W 9DD London
    British74857040001
    FOSTER, David Charles Geoffrey
    3 Cottage Farm Close
    Osgathorpe
    LE12 9UE Loughborough
    Leicestershire
    পরিচালক
    3 Cottage Farm Close
    Osgathorpe
    LE12 9UE Loughborough
    Leicestershire
    British52040210002
    FURNISS, Ronald William
    30 Marlock Close
    Fiskerton
    NG25 0UB Southwell
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    30 Marlock Close
    Fiskerton
    NG25 0UB Southwell
    Nottinghamshire
    British24556400001
    GILES, Alan James
    Tanglewood
    Crowsley Road
    RG9 3LE Shiplake
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Tanglewood
    Crowsley Road
    RG9 3LE Shiplake
    Oxfordshire
    EnglandBritish156046020001
    HOOD, John
    Briarwood
    15 Twatling Road Barnt Green
    B45 8HX Birmingham
    West Midlands
    পরিচালক
    Briarwood
    15 Twatling Road Barnt Green
    B45 8HX Birmingham
    West Midlands
    British39644740001
    HOSKINS, William
    11 Grange Court Road
    AL5 1BY Harpenden
    Hertfordshire
    পরিচালক
    11 Grange Court Road
    AL5 1BY Harpenden
    Hertfordshire
    British121893830001
    JOHNSON, Stephen Richard
    The Old Vicarage
    Lower Dunsforth
    YO26 9SA York
    পরিচালক
    The Old Vicarage
    Lower Dunsforth
    YO26 9SA York
    EnglandBritish87398750001
    KIDD, Geoffrey David
    Orchard House Grey Green Lane
    Wribbenhall
    DY12 1LT Bewdley
    Worcestershire
    পরিচালক
    Orchard House Grey Green Lane
    Wribbenhall
    DY12 1LT Bewdley
    Worcestershire
    British21889890002
    MCDOUGAL, Robert Hugh
    41 Tensing Close Great Sankey
    WA5 5AN Warrington
    Cheshire
    পরিচালক
    41 Tensing Close Great Sankey
    WA5 5AN Warrington
    Cheshire
    British15170390002
    MORTON, Ivor Malcolm
    Lysander
    8 Pine Close Shottery
    CV37 9FB Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    পরিচালক
    Lysander
    8 Pine Close Shottery
    CV37 9FB Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    British30725390003
    MURRAY, Stephan Peter
    Red Brick Barn
    Caythorpe
    NG14 7EB Nottingham
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    Red Brick Barn
    Caythorpe
    NG14 7EB Nottingham
    Nottinghamshire
    British53490630001
    NAPIER, John Alexander
    Rocks Stud Farm
    Brantridge Lane
    RH17 6JR Balcombe
    West Sussex
    পরিচালক
    Rocks Stud Farm
    Brantridge Lane
    RH17 6JR Balcombe
    West Sussex
    British14311010002
    PIGGOTT, Kenneth Stanton
    172 Loughborough Road
    NG11 6LF Ruddington
    Nottingham
    পরিচালক
    172 Loughborough Road
    NG11 6LF Ruddington
    Nottingham
    United KingdomBritish144061950001
    RADFORD, Kenneth Thomas
    21 Melton Road
    Tollerton
    NG12 4EL Nottingham
    পরিচালক
    21 Melton Road
    Tollerton
    NG12 4EL Nottingham
    British47191400001
    RICE, John Michael
    Wayside Cottage
    Street Lane Rodeheath
    ST7 3SN Cheshire
    পরিচালক
    Wayside Cottage
    Street Lane Rodeheath
    ST7 3SN Cheshire
    British72718070001
    ROBBINS, Brian Keith
    Westmere Drive
    CW1 6XB Crewe
    Gawsworth House
    Cheshire
    পরিচালক
    Westmere Drive
    CW1 6XB Crewe
    Gawsworth House
    Cheshire
    United KingdomAmerican153559370002
    RUSSELL, Stephen George
    The Manor Barn
    19b Far Street Wymeswold
    LE12 6TZ Loughborough
    Leicestershire
    পরিচালক
    The Manor Barn
    19b Far Street Wymeswold
    LE12 6TZ Loughborough
    Leicestershire
    British145267530001
    SCRIBBINS, Rodney Martin
    The Hemploe
    Hemploe Road
    NN6 6HF Welford
    Northampton
    পরিচালক
    The Hemploe
    Hemploe Road
    NN6 6HF Welford
    Northampton
    EnglandBritish98160250001
    SINCLAIR, Jonathan Stuart
    57 Hallfields
    Edwalton
    NG12 4AA Nottingham
    পরিচালক
    57 Hallfields
    Edwalton
    NG12 4AA Nottingham
    British45080280003

    PAYLESS DIY LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Security accession deed
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ফেব, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ing Bank N.V. London Branch (The Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ০৬ মার্চ, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ আগ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ সেপ, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due by any group company (as therein defined) to the chargee (as security trustee for the security beneficiaries, as therein defined) under the banking documents and the mezzanine loan agreement (both as therein defined) whether pursuant to the guarantee (as therein defined) or otherwise and in each case under the working capital facility letter
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property known as bonehill road tamworth t/n SF319160, fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৩ সেপ, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    PAYLESS DIY LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২৪ আগ, ২০০৯সিভিএ অনুমোদনের সভার তারিখ
    ০৩ জুন, ২০১০সিভিএ সম্পন্ন বা সমাপ্তির তারিখ
    কর্পোরেট স্বেচ্ছাসেবী ব্যবস্থা (সিভিএ)
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    James Joseph Bannon
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    অভ্যাসকারী
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    2
    তারিখপ্রকার
    ০১ মে, ২০১২প্রশাসন শেষ
    ০৫ মে, ২০১১প্রশাসন শুরু
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Simon Allport
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    অভ্যাসকারী
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Thomas Andrew Jack
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    অভ্যাসকারী
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Alan Michael Hudson
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    অভ্যাসকারী
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0