GS REALISATIONS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামGS REALISATIONS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00788228
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    GS REALISATIONS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • বিশেষায়িত স্টোরগুলিতে জুতার খুচরা বিক্রয় (47721) / হোলসেল এবং খুচরা বিক্রয়; মোটর গাড়ি এবং মোটরসাইকেল মেরামত

    GS REALISATIONS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    C/O Kpmg Llp
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    GS REALISATIONS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    GORDON SCOTT LIMITED২৪ আগ, ১৯৮৩২৪ আগ, ১৯৮৩
    GORDON SCOTT FOOT FITTER LIMITED৩১ ডিসে, ১৯৭৬৩১ ডিসে, ১৯৭৬
    GORDON SCOTT FOOT FITTER (WATFORD) LIMITED১৬ জানু, ১৯৬৪১৬ জানু, ১৯৬৪

    GS REALISATIONS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৪

    GS REALISATIONS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    29 পৃষ্ঠাAM10

    প্রশাসন থেকে দ্রবণে স্থানান্তরের নোটিশ

    29 পৃষ্ঠাAM23

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    24 পৃষ্ঠাAM10

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    27 পৃষ্ঠাAM10

    প্রশাসনের সময় বর্ধনের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাAM19

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    27 পৃষ্ঠাAM10

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ AM02SOA

    9 পৃষ্ঠাAM02

    প্রস্তাবগুলির অনুমোদিত অনুমোদনের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাAM06

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ১৩ এপ্রি, ২০১৭

    RES15

    নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাCONNOT

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    43 পৃষ্ঠা2.17B

    ০৪ এপ্রি, ২০১৭ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Outersole House Wheatfield Way Hinckley Leicestershire LE10 1YG England থেকে C/O Kpmg Llp 15 Canada Square London E14 5GLপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    প্রশাসক নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা2.12B

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩১ ডিসে, ২০১৬ থেকে ২৮ ফেব, ২০১৭ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    ১৯ ডিসে, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr David John Riddiford-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০৬ অক্টো, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে David Robert Short এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    চার্জ নিবন্ধন 007882280022, ২২ সেপ, ২০১৬ তারিখে তৈরি করা হয়েছে

    70 পৃষ্ঠাMR01

    ০৮ আগ, ২০১৬ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা C/O a Jones & Sons Limited Interlink Way West Interlink Business Park Bardon, Coalville Leicestershire LE67 1LD England থেকে Outersole House Wheatfield Way Hinckley Leicestershire LE10 1YGপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    অডিটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাAUD

    বার্ষিক রিটার্ন ১৮ মে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital৩১ মে, ২০১৬

    ৩১ মে, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2,251,519
    SH01

    ১৪ মার্চ, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Michael David Killick-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৪ মার্চ, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Terry Michael Boot এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    চার্জ নিবন্ধন 007882280021, ১৫ ফেব, ২০১৬ তারিখে তৈরি করা হয়েছে

    69 পৃষ্ঠাMR01

    দ্বিতীয় দায়ের TM01 এর যা পূর্বে কোম্পানিজ হাউসে জমা দেওয়া হয়েছিল

    4 পৃষ্ঠাRP04
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ১৪ ডিসে, ২০১৫Clarification A second filed TM01 for Andrew Robert White

    GS REALISATIONS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    KILLICK, Michael David
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    C/O Kpmg Llp
    পরিচালক
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    C/O Kpmg Llp
    WalesBritishCfo75927820002
    RIDDIFORD, David John
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    C/O Kpmg Llp
    পরিচালক
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    C/O Kpmg Llp
    EnglandBritishExecutive Chairman220918310001
    BARTLE, Kenneth
    77 The Piazza
    Sovereign Harbour
    BN23 5TQ Eastbourne
    East Sussex
    সচিব
    77 The Piazza
    Sovereign Harbour
    BN23 5TQ Eastbourne
    East Sussex
    BritishRetail Consultant73909180005
    GREASLEY, William Derek
    1 Chertsey Road
    Silverhill Estate, Mickleover
    DE3 0RA Derby
    Derbyshire
    সচিব
    1 Chertsey Road
    Silverhill Estate, Mickleover
    DE3 0RA Derby
    Derbyshire
    BritishFinancial Controller96709640001
    JOHNSON, David Edward
    20 Great Footway
    Langton Green
    TN3 0DT Tunbridge Wells
    Kent
    সচিব
    20 Great Footway
    Langton Green
    TN3 0DT Tunbridge Wells
    Kent
    BritishChartered Accountant10571470001
    SCOTT, Valli Lily
    70 Sandy Lane
    Beeston
    NG9 3GS Nottingham
    Nottinghamshire
    সচিব
    70 Sandy Lane
    Beeston
    NG9 3GS Nottingham
    Nottinghamshire
    British13838350001
    TODD, Jeremy
    West Street
    TN20 6DS Mayfield
    Knowle Way
    East Sussex
    United Kingdom
    সচিব
    West Street
    TN20 6DS Mayfield
    Knowle Way
    East Sussex
    United Kingdom
    BritishFinance Director109143970003
    WHITE, Andrew Robert
    18 Maple Road
    Eastbourne
    BN23 6NZ East Sussex
    সচিব
    18 Maple Road
    Eastbourne
    BN23 6NZ East Sussex
    British159790830001
    BALL, David Howard
    Courtfield
    Fenay Hall Fenay Bridge
    HD8 0LJ Huddersfield
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Courtfield
    Fenay Hall Fenay Bridge
    HD8 0LJ Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishInsurance Broker1165850004
    BARTLE, Kenneth
    Mill Hill
    Rattlesden
    IP30 0SQ Bury St Edmunds
    The Smock Mill, Hitchcocks Mill
    Suffolk
    United Kingdom
    পরিচালক
    Mill Hill
    Rattlesden
    IP30 0SQ Bury St Edmunds
    The Smock Mill, Hitchcocks Mill
    Suffolk
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector73909180007
    BARTLE, Kenneth
    The Smock Mill Hitchcocks Mill
    Mill Hill Rattlesden
    IP30 0SQ Bury St Edmunds
    Suffolk
    পরিচালক
    The Smock Mill Hitchcocks Mill
    Mill Hill Rattlesden
    IP30 0SQ Bury St Edmunds
    Suffolk
    EnglandBritishRetail Consultant73909180007
    BELL, John
    Timbers
    Main Street
    NG25 0UL Fiskerton
    Nottinghamshisre
    পরিচালক
    Timbers
    Main Street
    NG25 0UL Fiskerton
    Nottinghamshisre
    EnglandBritishRetired86085720001
    BOOT, Terry Michael
    Interlink Way West
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    C/O A Jones & Sons Limited
    Leicestershire
    England
    পরিচালক
    Interlink Way West
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    C/O A Jones & Sons Limited
    Leicestershire
    England
    EnglandBritishCfo67041160001
    CLARK, Lancelot Pease
    Apartment 142
    Archie Street
    SE1 London
    পরিচালক
    Apartment 142
    Archie Street
    SE1 London
    BritishManager28161570002
    COORENS, Eric Maria
    Interlink Way West
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Interlink Way West
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    NetherlandsDutchChief Operating Officer159761060001
    DE MOOR, Frank Karel
    Interlink Way West
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Interlink Way West
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    BelgiumBelgianChief Executive Officer159745220001
    FOX, Philip Alan
    8 Barnet Road
    NG3 7AQ Nottingham
    পরিচালক
    8 Barnet Road
    NG3 7AQ Nottingham
    BritishIt Manager61902010001
    GILLIVER, Malcolm Lidbury
    9 Bonser Close
    Carlton
    NG4 1DP Nottingham
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    9 Bonser Close
    Carlton
    NG4 1DP Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishFoot Fitter13838410001
    GREASLEY, William Derek
    1 Chertsey Road
    Silverhill Estate, Mickleover
    DE3 0RA Derby
    Derbyshire
    পরিচালক
    1 Chertsey Road
    Silverhill Estate, Mickleover
    DE3 0RA Derby
    Derbyshire
    EnglandBritishFinancial Director96709640001
    GUERBI, Boualem
    SE9
    পরিচালক
    SE9
    BritishRetail Footwear37380510001
    HUNEN, Peter Therese Antoon
    Interlink Way West
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Interlink Way West
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    NetherlandsDutchCompany Secretary159761180001
    JELINEK, Vaclav
    2 Avenue Place, Avenue Lane
    BN21 3RB Eastbourne
    East Sussex
    পরিচালক
    2 Avenue Place, Avenue Lane
    BN21 3RB Eastbourne
    East Sussex
    BritishRetail Executive109139210002
    JOHNSON, David Edward
    20 Great Footway
    Langton Green
    TN3 0DT Tunbridge Wells
    Kent
    পরিচালক
    20 Great Footway
    Langton Green
    TN3 0DT Tunbridge Wells
    Kent
    BritishChartered Accountant10571470001
    NOBLE, Alison Jane Bennett
    82 Gayville Road
    SW11 6JP London
    পরিচালক
    82 Gayville Road
    SW11 6JP London
    United KingdomBritishRetail Buyer103289830002
    PHILLIPS, Peter John
    Gibraltar Lane
    Cookham
    SL6 9TR Maidenhead
    Gibraltar House
    Berkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Gibraltar Lane
    Cookham
    SL6 9TR Maidenhead
    Gibraltar House
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector51075400001
    PHILLIPS, Peter John
    St. Peter Street
    SL7 1NQ Marlow
    The Minnows
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    St. Peter Street
    SL7 1NQ Marlow
    The Minnows
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    BritishCompany Director51075400002
    RYAN, Michael James
    25 North Riding
    Bricket Wood
    AL2 3LH St Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    25 North Riding
    Bricket Wood
    AL2 3LH St Albans
    Hertfordshire
    BritishRetailer13838380001
    RYAN, Michael James
    25 North Riding
    Bricket Wood
    AL2 3LH St Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    25 North Riding
    Bricket Wood
    AL2 3LH St Albans
    Hertfordshire
    BritishFoot Fitter13838380001
    SCOTT, Andrew Leslie
    2 Hollinwell Court
    Edwalton
    NG12 4DW Nottingham
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    2 Hollinwell Court
    Edwalton
    NG12 4DW Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishFoot Fitter13838370001
    SCOTT, Gordon Leslie
    70 Sandy Lane
    Beeston
    NG9 3GS Nottingham
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    70 Sandy Lane
    Beeston
    NG9 3GS Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishFoot Fitter13838360001
    SCOTT, Valli Lily
    70 Sandy Lane
    Beeston
    NG9 3GS Nottingham
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    70 Sandy Lane
    Beeston
    NG9 3GS Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishFoot Fitter13838350001
    SHORT, David Robert
    Wheatfield Way
    LE10 1YG Hinckley
    Outersole House
    Leicestershire
    England
    পরিচালক
    Wheatfield Way
    LE10 1YG Hinckley
    Outersole House
    Leicestershire
    England
    EnglandBritishCeo38957690003
    STRIJBOS, Theodorus Leonardus
    Interlink Way West
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Interlink Way West
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    NetherlandsDutchChief Financial Officer159760930001
    TODD, Jeremy
    West Street
    TN20 6DS Mayfield
    Knowle Way
    East Sussex
    United Kingdom
    পরিচালক
    West Street
    TN20 6DS Mayfield
    Knowle Way
    East Sussex
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director109143970003
    WATKINSON, John Dudley
    Glebe Farm
    Old Weston Road
    PE28 5AG Brington
    Cambs
    পরিচালক
    Glebe Farm
    Old Weston Road
    PE28 5AG Brington
    Cambs
    EnglandBritishDirector66949520004

    GS REALISATIONS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ সেপ, ২০১৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ সেপ, ২০১৬
    বকেয়া
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Alteri Europe, L.P.
    ব্যবসায়
    • ২৮ সেপ, ২০১৬একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ ফেব, ২০১৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ ফেব, ২০১৬
    বকেয়া
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Alteri Europe, L.P. (The Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ১৭ ফেব, ২০১৬একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ অক্টো, ২০১৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ নভে, ২০১৫
    বকেয়া
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Alteri Europe L.P. (As Secuirty Agent)
    ব্যবসায়
    • ০২ নভে, ২০১৫একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ অক্টো, ২০১৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ নভে, ২০১৫
    বকেয়া
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Alteri Europe, L.P. (As Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ০২ নভে, ২০১৫একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ নভে, ২০১৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ নভে, ২০১৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ing Bank N.V. (The "Security Agent") as Trustee for Each of the Secured Parties
    ব্যবসায়
    • ২৫ নভে, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ৩০ অক্টো, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ সেপ, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ সেপ, ২০১০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ সেপ, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ২০ মে, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ নভে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ নভে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ নভে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ জানু, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Memorandum of deposit of stocks and shares and other marketable securities
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ নভে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ নভে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    900 ordinary shares of £1.00 each in the share capital of gordan scott of london limited and 900 ordinary shares of £1.00 each in the share capital of gordon scott of london (international) limited and all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ নভে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ জানু, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ডিসে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ জানু, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ জানু, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ ডিসে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ অক্টো, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ অক্টো, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Premises adjoining no.42 (Formerly unit A14) the harlequin centre watford. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ অক্টো, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ জানু, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ এপ্রি, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ মে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The l/h property k/a ground floor and lower ground floor premises forming part of 119/121 cannon street london. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ মে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ জানু, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ নভে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ নভে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/Hold premises- 1ST floor level known as 143/145 upper broad walk broad marsh centre nottingham....................with all covenants/rights and the goodwill of business; proceeds of any insurance.........see form 395. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ নভে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ জানু, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ নভে, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ নভে, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H premises k/a ground floor and basement 29 new bond street london .. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ নভে, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ জানু, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১০ আগ, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ আগ, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The l/h property k/a no 42 the harlequin centre watford. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ আগ, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ জানু, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ মার্চ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ মার্চ, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Shop unit 3 new broad street 81/89 old broad street london described in an underlease dated 6 march 1992 fixed charge over plant machinery fixtures and fittings.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ মার্চ, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ জানু, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ অক্টো, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ অক্টো, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property ground floor and basement of the building k/a 29 new bond street london borough of city of westminster greater london. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ অক্টো, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৯ জানু, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ মার্চ, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ মার্চ, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 1.3.88
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Floating charge over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • G L Scott
    • D H Ball
    • Mrs V L Scott
    • A L Scott
    ব্যবসায়
    • ০৩ মার্চ, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৩ এপ্রি, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ১০ মার্চ, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ মার্চ, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 10.3.87
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • D H Ball
    • Mrs V L Scott
    • A L Scott
    • G L Scott Directors Special Pension Schemeas Managing Trustees of the Gordon Scott Limited
    ব্যবসায়
    • ১৬ মার্চ, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৩ এপ্রি, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২১ মার্চ, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ মার্চ, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H shop premises known as nos 45 and 47 high street solihull w midlands title no wm 300884 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Williams & Glyn's Bank Limited
    ব্যবসায়
    • ৩০ মার্চ, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৯ জানু, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ ফেব, ১৯৮১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ ফেব, ১৯৮১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    143/145 upper broad walk, broad marsh centre, nottingham nottinghamshire together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or atttached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878 together with plant machinery fixtures implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Williams & Glyn's Bank Limited
    ব্যবসায়
    • ২৬ ফেব, ১৯৮১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৩ জানু, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ মার্চ, ১৯৭৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ এপ্রি, ১৯৭৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land & shop premises of abington street northampton northamptonshire together with plant macninery fixtures implements and utensils. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Williams & Glyn's Bank Limited
    ব্যবসায়
    • ০৪ এপ্রি, ১৯৭৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৯ জানু, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ অক্টো, ১৯৭৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ অক্টো, ১৯৭৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & uncalled capital, all fixtures & fittings and all fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Williams & Glyn's Bank Limited
    ব্যবসায়
    • ১৪ অক্টো, ১৯৭৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৯ জানু, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    GS REALISATIONS LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২৩ মার্চ, ২০১৭প্রশাসন শুরু
    ০৫ এপ্রি, ২০১৯প্রশাসন শেষ
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Blair Carnegie Nimmo
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    অভ্যাসকারী
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    William James Wright
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    অভ্যাসকারী
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Stephen John Absolom
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    অভ্যাসকারী
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0