00803368 LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • নিশ্চয়তা বিবৃতি
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নাম00803368 LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিলিকুইডেশন
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00803368
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    00803368 LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (3615) /

    00803368 LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    00803368 LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    A.SYKES(DORLUX)LIMITED৩০ এপ্রি, ১৯৬৪৩০ এপ্রি, ১৯৬৪

    00803368 LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়২৮ ফেব, ২০০৫
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়২৮ ডিসে, ২০০৫
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে২৯ ফেব, ২০০৪

    00803368 LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে০২ ডিসে, ২০১৬
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে১৬ ডিসে, ২০১৬
    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ

    00803368 LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন
    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ

    00803368 LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    আদালতের আদেশে পুনরুদ্ধার

    4 পৃষ্ঠাAC92
    R2NJ2KZV

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed dorlux beds\certificate issued on 20/12/13
    CERTNM

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ১৫ মার্চ, ২০১০ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68
    ASRYSIGH

    ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    3 পৃষ্ঠা4.72
    ASRYIIG7

    ২৫ অক্টো, ২০০৯ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68
    AE0HIEPQ

    ২৫ এপ্রি, ২০০৯ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    9 পৃষ্ঠা4.68
    CZ3GG9SB

    ২৫ অক্টো, ২০০৮ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68
    AKFEZ4MC

    ২৫ অক্টো, ২০০৮ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68
    AIAGBZJB

    লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    6 পৃষ্ঠা4.68

    দ্রবণ কমিটির সংবিধানের নোটিশ

    5 পৃষ্ঠা4.48

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    9 পৃষ্ঠা2.24B

    প্রশাসন থেকে ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছাসেবক লিকুইডেশনে স্থানান্তরের নোটিশ

    9 পৃষ্ঠা2.34B

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    7 পৃষ্ঠা2.24B

    ক্রেডিটরদের সভার ফলাফল

    3 পৃষ্ঠা2.23B

    বিবৃতির বিবৃতি

    12 পৃষ্ঠা2.16B

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    33 পৃষ্ঠা2.17B

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    প্রশাসক নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা2.12B

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    2 পৃষ্ঠা403a

    00803368 LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BUTTERFIELD, Paul Matthew
    6 Meadowcroft
    Off Stainland Road
    HX4 0FB Barkisland
    Halifax
    সচিব
    6 Meadowcroft
    Off Stainland Road
    HX4 0FB Barkisland
    Halifax
    BritishAccountant12704310002
    BUTTERFIELD, Paul Matthew
    6 Meadowcroft
    Off Stainland Road
    HX4 0FB Barkisland
    Halifax
    পরিচালক
    6 Meadowcroft
    Off Stainland Road
    HX4 0FB Barkisland
    Halifax
    United KingdomBritishAccountant12704310002
    MCCARTHY, Morgan
    22 Cromwell Place
    GU6 7LF Cranleigh
    Surrey
    পরিচালক
    22 Cromwell Place
    GU6 7LF Cranleigh
    Surrey
    United KingdomBritishManaging Director18581210003
    ROOK, Stuart James
    19 Robin Drive
    Steeton
    BD20 6TF Keighley
    West Yorkshire
    সচিব
    19 Robin Drive
    Steeton
    BD20 6TF Keighley
    West Yorkshire
    British74273190001
    WHITELEY, Jonathan Walton
    8 Norwood
    Carleton
    WF8 3SD Pontefract
    West Yorkshire
    সচিব
    8 Norwood
    Carleton
    WF8 3SD Pontefract
    West Yorkshire
    BritishAccountant51216120002
    WILCOX, Brian John
    18 Latham Court
    Gomersal
    BD19 4DE Cleckheaton
    West Yorkshire
    সচিব
    18 Latham Court
    Gomersal
    BD19 4DE Cleckheaton
    West Yorkshire
    British90568370001
    BRITTON, Anthony Eric
    Sunnyside
    Main Street Birlby
    YO42 4JL York
    Yorkshire
    পরিচালক
    Sunnyside
    Main Street Birlby
    YO42 4JL York
    Yorkshire
    EnglandBritishSales & Marketing Director83454910001
    GRANT, Anthony Ernest
    63 Old Park Road
    LS8 1JB Leeds
    পরিচালক
    63 Old Park Road
    LS8 1JB Leeds
    United KingdomBritishDirector9952930001
    HEWITT, Peter Graham
    24 Melton Road
    HU14 3ET North Ferriby
    North Humberside
    পরিচালক
    24 Melton Road
    HU14 3ET North Ferriby
    North Humberside
    United KingdomBritishManaging Director10707750001
    MARTIN, Robert William
    Canterbury Gate
    31a Carrwood Road
    SK7 3LR Bramhall
    Cheshire
    পরিচালক
    Canterbury Gate
    31a Carrwood Road
    SK7 3LR Bramhall
    Cheshire
    BritishStockbroker62431440002
    MCCORMACK, William James
    1 South Lane
    Shelf
    HX3 7PN Halifax
    West Yorkshire
    পরিচালক
    1 South Lane
    Shelf
    HX3 7PN Halifax
    West Yorkshire
    BritishProduction Director21270750002
    PETTY, Nigel George William
    6 The Copse
    Burley In Wharfedale
    LS29 7QY Ilkley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    6 The Copse
    Burley In Wharfedale
    LS29 7QY Ilkley
    West Yorkshire
    BritishOperations Director46334910002
    ROBERTS, John Philip
    Myrefield Cottage
    Lee Lane, Millhouse Green
    S36 9NN Penistone
    পরিচালক
    Myrefield Cottage
    Lee Lane, Millhouse Green
    S36 9NN Penistone
    EnglandBritishSales And Marketing Director86715450001
    SUGDEN, Christopher John
    33 Broompark Road
    DN14 6YF Goole
    East Yorkshire
    পরিচালক
    33 Broompark Road
    DN14 6YF Goole
    East Yorkshire
    BritishProduction Manager85564800001
    SYKES, Arthur Ian
    Orchard Cottage
    Outgate
    LA22 0NH Ambleside
    Cumbria
    পরিচালক
    Orchard Cottage
    Outgate
    LA22 0NH Ambleside
    Cumbria
    BritishBedding Manufacturer10707770001
    TRUEMAN, Reginald Thomas
    Vista 8 Sherburn Grove
    Birkenshaw
    BD11 2JH Bradford
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Vista 8 Sherburn Grove
    Birkenshaw
    BD11 2JH Bradford
    West Yorkshire
    BritishPurchasing Director21270760001
    WHITELEY, Jonathan Walton
    8 Norwood
    Carleton
    WF8 3SD Pontefract
    West Yorkshire
    পরিচালক
    8 Norwood
    Carleton
    WF8 3SD Pontefract
    West Yorkshire
    BritishAccountant51216120002
    WILLIAMS, Colin Martin
    Croft Barn
    Kildwick Grange Kildwick
    BD20 9AD Keighley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Croft Barn
    Kildwick Grange Kildwick
    BD20 9AD Keighley
    West Yorkshire
    BritishSales Director100845380001

    00803368 LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Chattel mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ ডিসে, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ ডিসে, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Spuhl spring making machine and decoiler f-65SW serial no 16514, spuhl spring transfer machine fta-72SW serial no 15934, spuhl mattress assembly machine am-115 sw serial no 16253. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ ডিসে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ জুল, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattel mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ জানু, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ জানু, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Gribetz 90IN micro quilting machine serial no. 43428P.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ জানু, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ জুল, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattels mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১০ অক্টো, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ অক্টো, ২০০১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule to the form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ১০ অক্টো, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    তৈরি করা হয়েছে ১২ জুল, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ জুল, ২০০১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever whether arising under an agreement for the purchase of debts or otherwise
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ১৩ জুল, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ মার্চ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ এপ্রি, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property k/a forest mills club lane halifax. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ এপ্রি, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ জুল, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ অক্টো, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company (formerly known as A. sykes (dorlux) limited) to the chargee under the terms of this legal mortgage
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Barden works and beechwood works club lane ovenden halifax t/nos: WYK491450 WYK491451 WYK604584 WYK563252 WYK567833 WYK605218. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ অক্টো, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ জুল, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ ডিসে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ ডিসে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ জুল, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    A credit agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ অক্টো, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ অক্টো, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £73,699.60 due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All its right title and interest in and to all sums payable under the insurance for full details see form 395.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Close Brothers Limited
    ব্যবসায়
    • ১৭ অক্টো, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ সেপ, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Series of debentures
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ মে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ মে, ১৯৯১
    বকেয়া
    ব্যবসায়
    • ০৮ মে, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ এপ্রি, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ মে, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • John Cotton (Mirfield) Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ মে, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৯ ডিসে, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ নভে, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ নভে, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book & other debts. Uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ নভে, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ আগ, ১৯৮৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ আগ, ১৯৮৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land and buildings on the south side of albert road halifax west yorkshire title no wyk 278934.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ আগ, ১৯৮৩একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০২ জুল, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ জুল, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land & buildings on the site of spring hall mills halifax w yorks title no wyk 180087.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ জুল, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২২ জানু, ১৯৬৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ ফেব, ১৯৬৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due etc.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Sabroan works, club lane, overden, halifax, york. Together with plant machinery fixtures implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Martins Bank LTD
    ব্যবসায়
    • ০৫ ফেব, ১৯৬৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৯ জুল, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    00803368 LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২৬ এপ্রি, ২০০৬প্রশাসন শেষ
    ২৯ জুল, ২০০৫প্রশাসন শুরু
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Ian David Green
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    অভ্যাসকারী
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Roger Marsh
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    অভ্যাসকারী
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    2
    তারিখপ্রকার
    ২৫ জুন, ২০১০ভেঙে গেছে
    ২৬ এপ্রি, ২০০৬ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Ian David Green
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    অভ্যাসকারী
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Roger Marsh
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    অভ্যাসকারী
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0