STOAKES SYSTEMS (CONTRACTS) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামSTOAKES SYSTEMS (CONTRACTS) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00836726
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    STOAKES SYSTEMS (CONTRACTS) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (9999) /

    STOAKES SYSTEMS (CONTRACTS) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    1 Banstead Road
    Purley
    CR8 3EB Surrey
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    STOAKES SYSTEMS (CONTRACTS) LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    STOAKES SYSTEMS LIMITED২৮ এপ্রি, ১৯৮৩২৮ এপ্রি, ১৯৮৩
    ASTRAVENT LIMITED০৫ ফেব, ১৯৬৫০৫ ফেব, ১৯৬৫

    STOAKES SYSTEMS (CONTRACTS) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০০৮

    STOAKES SYSTEMS (CONTRACTS) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৭ জানু, ২০১০

    ০৭ জানু, ২০১০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,000
    SH01

    ১৩ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Mr Richard Timothy Stoakes-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১৩ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Mrs Evelyn Porter-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ স্থগিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাSOAS(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    legacy

    1 পৃষ্ঠা652a

    হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    1 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৫ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৪ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    8 পৃষ্ঠা363s

    legacy

    8 পৃষ্ঠা363s

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৩ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    8 পৃষ্ঠা363s

    STOAKES SYSTEMS (CONTRACTS) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    PORTER, Evelyn
    1 Banstead Road
    Purley
    CR8 3EB Surrey
    সচিব
    1 Banstead Road
    Purley
    CR8 3EB Surrey
    British56383440001
    STOAKES, Richard Timothy
    1 Banstead Road
    Purley
    CR8 3EB Surrey
    পরিচালক
    1 Banstead Road
    Purley
    CR8 3EB Surrey
    United KingdomBritishManaging Director8447620002
    KENT, James Leslie
    25 Mandeville Road
    SG13 8JQ Hertford
    Hertfordshire
    সচিব
    25 Mandeville Road
    SG13 8JQ Hertford
    Hertfordshire
    British4860290001
    REVEL, Francis Duncan
    120 Northwood Avenue
    CR8 2EQ Purley
    Surrey
    সচিব
    120 Northwood Avenue
    CR8 2EQ Purley
    Surrey
    British35531270002
    DAY, Martin Edward
    Chalkpit Cottage Pilgrims Way
    Kemsing
    TN15 6TE Sevenoaks
    Kent
    পরিচালক
    Chalkpit Cottage Pilgrims Way
    Kemsing
    TN15 6TE Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritishSales & Marketing Director23199540001
    MAGUIRE, Stephen James
    10 Overton Shaw
    RH19 2HN East Grinstead
    West Sussex
    পরিচালক
    10 Overton Shaw
    RH19 2HN East Grinstead
    West Sussex
    United KingdomBritishCompany Director56382810001
    REVEL, Francis Duncan
    120 Northwood Avenue
    CR8 2EQ Purley
    Surrey
    পরিচালক
    120 Northwood Avenue
    CR8 2EQ Purley
    Surrey
    BritishFinancial Director35531270002
    STOAKES, Elizabeth Ann
    Willowmere Farm Mapleton Road
    Four Elms
    TN8 6PN Edenbridge
    Kent
    পরিচালক
    Willowmere Farm Mapleton Road
    Four Elms
    TN8 6PN Edenbridge
    Kent
    United KingdomBritishDirector33506700001
    STOAKES, Lewis Richard
    Willowmere Farm Mapleton Road
    Four Elms
    TN8 6PN Edenbridge
    Kent
    পরিচালক
    Willowmere Farm Mapleton Road
    Four Elms
    TN8 6PN Edenbridge
    Kent
    BritishChairman23371390001

    STOAKES SYSTEMS (CONTRACTS) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Charge over credit balances
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ মার্চ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ এপ্রি, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a performance bond in favour of blackburn borough council for £22,399
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The sum of £22,399 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 18333699 and earmarked or designated by reference to the company.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ এপ্রি, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ জানু, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over credit balances
    তৈরি করা হয়েছে ১২ অক্টো, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ অক্টো, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a performance bond in favour of the scottish life assurance company for £56387.00 dated 12/10/92
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The sum of £56,387 together with interest accrued now or held by national westminster bank PLC on an account no. 18241611 and designated by reference to the company.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ অক্টো, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ মার্চ, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over credit balances
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ এপ্রি, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ এপ্রি, ১৯৮৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a tender bon dated 24/3/86 in the sum of £8,000,000 drochmas in favour of olympic airways
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The sum of £40,000 together with interest accrued held by the bank on an account in the name of the bank and earmarked re the company.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ এপ্রি, ১৯৮৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১২ মার্চ, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over credit balance
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ সেপ, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ সেপ, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a bond dated 29.7.85 for £40,000 in favour of humphreys and glasgow limited
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The sum of £40,000 together with interest accrued held by the bank on an account in the name of the bank an earmerked re the company.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ সেপ, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0