CHESHIRE HOTELS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বিবৃতি
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCHESHIRE HOTELS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00881168
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    CHESHIRE HOTELS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    CHESHIRE HOTELS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    RESOLVE PARTNERS LIMITED
    22 York Buildings John Adam Street
    WC2N 6JU London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    CHESHIRE HOTELS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে২২ আগ, ২০১৫

    CHESHIRE HOTELS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    10 পৃষ্ঠাLIQ13

    ১১ জানু, ২০১৮ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    9 পৃষ্ঠাLIQ03

    ১২ সেপ, ২০১৭ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NL থেকে 22 York Buildings John Adam Street London WC2N 6JUপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    ০১ মার্চ, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    ১০ ফেব, ২০১৭ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom থেকে Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NLপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ১২ জানু, ২০১৭ তারিখে

    LRESSP

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    9 পৃষ্ঠা4.70

    ২৫ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে Lindsay Anne Keswick-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    ২৫ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে Claire Susan Stewart এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ০৭ মার্চ, ২০১৬ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Sunrise House Ninth Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 3JZ থেকে Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QTপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০১ মার্চ, ২০১৬

    ০১ মার্চ, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 10,000
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২২ আগ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    ২৬ জানু, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Jonathan Robert Langford এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৬ জানু, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Daryl Antony Kelly এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৬ জানু, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Lucy Jane Bell এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২১ ডিসে, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Kirk Dyson Davis-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০৪ ডিসে, ২০১৫ তারিখে সচিব হিসাবে Henry Jones এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর সংক্ষিপ্ত ২৪ আগ, ২০১৬ থেকে ৩০ এপ্রি, ২০১৬ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    ২৩ জুন, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Patrick James Gallagher এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    8 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০২ মার্চ, ২০১৫

    ০২ মার্চ, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 10,000
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২৩ আগ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    8 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৩ মার্চ, ২০১৪

    ০৩ মার্চ, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 10,000
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ১৭ আগ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    CHESHIRE HOTELS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    KESWICK, Lindsay Anne
    York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    22
    সচিব
    York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    22
    207523880001
    DAVIS, Kirk Dyson
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish158484730001
    CUTHBERTSON, Colin
    5 Hill Gardens
    LE16 9EB Market Harborough
    Leicestershire
    সচিব
    5 Hill Gardens
    LE16 9EB Market Harborough
    Leicestershire
    British26369940001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    সচিব
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    JONES, Henry
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    সচিব
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    180591990001
    KENDALL, Timothy James
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    সচিব
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    British117397470002
    RUDD, Susan Clare
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    সচিব
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    172445110001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    সচিব
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEVENS, Mark
    5 Lyon Drive
    Murieston
    EH54 9HF Livingston
    West Lothian
    সচিব
    5 Lyon Drive
    Murieston
    EH54 9HF Livingston
    West Lothian
    British80951870001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    সচিব
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    181022050001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    সচিব
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Other130369890001
    WALMSLEY, Derek Kerr
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    সচিব
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    British135181230001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    BELL, Lucy Jane
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish164754670001
    BUBB, Stewart Edmund Conyers
    Clare Cottage
    42 Lammas Lane
    KT10 8PD Esher
    Surrey
    পরিচালক
    Clare Cottage
    42 Lammas Lane
    KT10 8PD Esher
    Surrey
    British36779040001
    CUMMING, Johanna Louise
    18 Prospect Quay
    98 Point Pleasant
    SW18 1PR London
    পরিচালক
    18 Prospect Quay
    98 Point Pleasant
    SW18 1PR London
    United KingdomBritish111108910001
    CUTHBERTSON, Colin
    5 Hill Gardens
    LE16 9EB Market Harborough
    Leicestershire
    পরিচালক
    5 Hill Gardens
    LE16 9EB Market Harborough
    Leicestershire
    EnglandBritish26369940001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141395280001
    GALLAGHER, Patrick James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish205366190001
    GODWIN-BRATT, Robert James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish170184800001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    পরিচালক
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    পরিচালক
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    JACOBS, David Michael
    Riverside House
    Hall Cottages Lodden Drive
    RG10 8ND Reading
    Berkshire
    পরিচালক
    Riverside House
    Hall Cottages Lodden Drive
    RG10 8ND Reading
    Berkshire
    British47141160001
    JONES, Karen Elisabeth Dind
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    পরিচালক
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    United KingdomBritish47793260007
    KELLY, Daryl Antony
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish86246470001
    KNIGHT, Andrew Ronald
    89 Main Street
    DE13 7ED Alrewas
    Staffordshire
    পরিচালক
    89 Main Street
    DE13 7ED Alrewas
    Staffordshire
    British81555100002
    LANGFORD, Jonathan Robert
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish135408140001
    MARGERRISON, Russell John
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish170590800001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    পরিচালক
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    British42019620001
    MILLER, Louise
    13 Traquair Park West
    EH12 7AN Edinburgh
    Midlothian
    পরিচালক
    13 Traquair Park West
    EH12 7AN Edinburgh
    Midlothian
    British63895470001
    PEAREY, Michael John
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    পরিচালক
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    British46305030001
    PEAREY, Michael John
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    পরিচালক
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    British46305030001
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish63043630002
    RIKLIN, Cornel Carl
    103 Barrow Gate Road
    Chiswick
    W4 4QS London
    পরিচালক
    103 Barrow Gate Road
    Chiswick
    W4 4QS London
    EnglandSwiss78412270001

    CHESHIRE HOTELS LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিদের বিষয়ে সর্বশেষ বিবৃতিগুলি কী কী?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বিবৃতি
    জানানো হয়েছেবন্ধ হয়েছেবিবৃতি
    ০১ মার্চ, ২০১৭কোম্পানি জানে বা বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে যে কোম্পানির সাথে সম্পর্কিত কোন নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি বা নিবন্ধনযোগ্য প্রাসঙ্গিক আইনি সত্তা নেই

    CHESHIRE HOTELS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ ডিসে, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ ডিসে, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent) as Agent and Trustee for the Financeparties
    ব্যবসায়
    • ৩১ ডিসে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ ডিসে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ ফেব, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ ফেব, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The repayment loan (as defined) of sterling pounds 295,000 and the discount loan (as defined) of sterling pounds 5,000 and all monies due or to become due from the company to bass north limited (bass) under the terms of the charge including moneys due from the company to bass and/or the bass trading companies (as defined) in respect of goods sold and/or supplied and services rendered
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property klo hill house mount avenueheswall wirral merseyside and all the fixed & moveable plant equipment furniture fixtures & fittings and the goodwill of the business.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bass North Limited
    ব্যবসায়
    • ১৯ ফেব, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৯ ফেব, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ নভে, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ নভে, ১৯৮৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the bass north trading companies (as defined) including moneys due for goods sold & delivered on any account whatsoever under the terms of the charge.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H premises k/a sam's bar tithebarn street liverpool and the fixed and movable plant furniture and equipment. Fixtures and fittings and the goodwill.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bass North Limited
    ব্যবসায়
    • ১৮ নভে, ১৯৮৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৯ ফেব, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০২ আগ, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ আগ, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    9, station approach, meols, wirral, merseyside.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ আগ, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৯ ফেব, ২০০৪বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২৬ অক্টো, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ ডিসে, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ ডিসে, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    Sterling pounds 210,000 & all other monies due or to become due from the company to the chargee including money due for goods sold money lent or on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Cheshire cat neston road, thorton hough wirral merseyside.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Whitbread and Company Public Limited Company
    ব্যবসায়
    • ২৮ ডিসে, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৯ ফেব, ২০০৪বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২৬ অক্টো, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ এপ্রি, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ মে, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/Hold thornton hall, thornton hough, wirral merseyside title no ms 37830.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ মে, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৯ ফেব, ২০০৪বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২৬ অক্টো, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ অক্টো, ১৯৮৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ অক্টো, ১৯৮৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    Sterling pounds 35000 together with monies due for goods supplied
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Dibbinsdale hotel dibbinsdale road, bromborough, merseyside.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Greenhall Whitley Public Limited Company
    ব্যবসায়
    • ০৬ অক্টো, ১৯৮৩একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৯ ফেব, ২০০৪বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২৬ অক্টো, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ জুল, ১৯৭৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ জুল, ১৯৭৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    For securing the monies advanced to be or advanced to the company by the chargee under the terms of an agreement dated 15TH july 1976 and all other monies due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A first fixed charge on property known as thornton hall hotel, thonton haigh, wirral, cheshire together with all buildings and fixtures in the nature of landlords fixtures thereon.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Industrial and Commercial Finance Corporation LTD
    ব্যবসায়
    • ২১ জুল, ১৯৭৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৯ ফেব, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মার্চ, ১৯৭৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ মার্চ, ১৯৭৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    Sterling pounds 45,000 and all other monies due or to become due from thecompany to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Argyll and southerland highlander hotel,plymyard, avenue, branborough, wirral,merseyside together with all buildings and fixtures in the nature of landlords fixtures.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Industrial and Commercial Finance Corporation LTD
    ব্যবসায়
    • ১৬ মার্চ, ১৯৭৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৮ নভে, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ অক্টো, ১৯৭৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ অক্টো, ১৯৭৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Load at plymyard avenue bromborough merseyside.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩১ অক্টো, ১৯৭৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৮ নভে, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১২ জুন, ১৯৭২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ জুন, ১৯৭২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill and uncalled capital. With all fixtures (including trade fixtures) now or hereafter thereon (please see doc.18 For details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ জুন, ১৯৭২একটি চার্জের নিবন্ধন

    CHESHIRE HOTELS LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১২ জানু, ২০১৭ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ১৫ এপ্রি, ২০১৯ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Ben David Woodthorpe
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    অভ্যাসকারী
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    Simon Harris
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    অভ্যাসকারী
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0