TRENTS LEISURE LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামTRENTS LEISURE LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00882956
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    TRENTS LEISURE LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    TRENTS LEISURE LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Mccoll's House
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Essex
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    TRENTS LEISURE LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে২৬ নভে, ২০১৭

    TRENTS LEISURE LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    ২২ ফেব, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Simon Jeremy Ian Fuller এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ৩১ জানু, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Robbie Ian Bell-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ২৪ অক্টো, ২০১৮ তারিখে Mr Simon Jeremy Ian Fuller-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০৭ সেপ, ২০১৮ তারিখে সচিব হিসাবে Bernadette Clare Young এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২৬ নভে, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ২৯ আগ, ২০১৮ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    5 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    ৩১ মে, ২০১৮ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ২২ আগ, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Steven Green-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২২ আগ, ২০১৭ তারিখে সচিব হিসাবে Bernadette Clare Young-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    ২২ আগ, ২০১৭ তারিখে সচিব হিসাবে Simon Jonathan Miller এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২৭ নভে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    ৩১ মে, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    সংশোধিত হিসাব নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য ২৯ নভে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAAMD

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২৯ নভে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    2 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ মে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৭ জুন, ২০১৬

    ০৭ জুন, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 27,500
    SH01

    ২৬ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Simon Jeremy Ian Fuller-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৬ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে James Lancaster এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১২ আগ, ২০১৫ তারিখে সচিব হিসাবে Kingsley John Tedder এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ নভে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    TRENTS LEISURE LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BELL, Robbie Ian
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    পরিচালক
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    EnglandBritish97384120002
    GREEN, Steven
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    পরিচালক
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    EnglandBritish209349290001
    MILLER, Simon Jonathan
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    পরিচালক
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    EnglandBritish88269280005
    BARNES, Christopher Howard
    11 Hepplewhite Close
    Baughurst
    RG26 5HD Basingstoke
    Hampshire
    সচিব
    11 Hepplewhite Close
    Baughurst
    RG26 5HD Basingstoke
    Hampshire
    British25597650001
    GOSNELL, Michael James
    The Birches
    1 Lowfield Close
    GU18 5QT Lightwater
    Surrey
    সচিব
    The Birches
    1 Lowfield Close
    GU18 5QT Lightwater
    Surrey
    British10496160001
    MILLER, Simon Jonathan
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    সচিব
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    British88269280005
    TAYLOR, Philip John Graham
    Cherry Tree House 19 Hill Road
    GU27 2JN Haslemere
    Surrey
    সচিব
    Cherry Tree House 19 Hill Road
    GU27 2JN Haslemere
    Surrey
    British10082610001
    TEDDER, Kingsley John
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    সচিব
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    British101631010002
    YOUNG, Bernadette Clare
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    সচিব
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    237939310001
    AGUSS, Martyn James
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    পরিচালক
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    EnglandBritish107991420002
    COX, Allister Russell
    The Small House Mynthurst
    Leigh
    RH2 8RJ Reigate
    Surrey
    পরিচালক
    The Small House Mynthurst
    Leigh
    RH2 8RJ Reigate
    Surrey
    EnglandBritish31500810002
    CULLENS, Alan
    4 Alexandra House
    Queens Hill Lodge
    SL5 7EQ Ascot
    Berkshire
    পরিচালক
    4 Alexandra House
    Queens Hill Lodge
    SL5 7EQ Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish6875310002
    FULLER, Simon Jeremy Ian
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    পরিচালক
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    EnglandBritish181763320002
    HANNA, Robert Houston
    Cherry Garth Stokesheath Road
    Oxshott
    KT22 0PS Leatherhead
    Surrey
    পরিচালক
    Cherry Garth Stokesheath Road
    Oxshott
    KT22 0PS Leatherhead
    Surrey
    British10082620001
    LANCASTER, James
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    পরিচালক
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    EnglandBritish147052660001
    WILKINSON, Stephen William
    Martin Mccoll House
    Ashwells Road,
    CM15 9ST Pilgrims Hatch, Brentwood
    Essex
    পরিচালক
    Martin Mccoll House
    Ashwells Road,
    CM15 9ST Pilgrims Hatch, Brentwood
    Essex
    United KingdomBritish101631100002
    WOOLHOUSE, Anthony Peter
    Wellbourne
    Vicarage Hill
    GU9 8HG Farnham
    Surrey
    পরিচালক
    Wellbourne
    Vicarage Hill
    GU9 8HG Farnham
    Surrey
    British10496200001
    WYATT, Peter Robert Michael
    Frogs Close
    Clayford Lane
    TA22 9RH Dulverton
    West Somerset
    পরিচালক
    Frogs Close
    Clayford Lane
    TA22 9RH Dulverton
    West Somerset
    British10082630001

    TRENTS LEISURE LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Ashwells Road
    Pilgrims Hatch
    CM15 9ST Brentwood
    Mccolls House
    Essex
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Ashwells Road
    Pilgrims Hatch
    CM15 9ST Brentwood
    Mccolls House
    Essex
    England
    না
    আইনি ফর্মProvate Company Limited By Shares
    নিবন্ধিত দেশEngland And Wales
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2016
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর80028
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    TRENTS LEISURE LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ নভে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ডিসে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from company to the chargee (as agent and trustee for the secured parties (as therein defined) pursuant to the terms of a credit agreement (as therein defined)) under or pursuant to any of the financing documents (as therein defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ ডিসে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ জুন, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জুল, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ জুল, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties and to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to any of the financing documents (as defined) including this guarantee and debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ৩১ জুল, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ মে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ মার্চ, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ মার্চ, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H 25 bridge street, swindon wiltshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ মার্চ, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২২ জানু, ১৯৮০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ ফেব, ১৯৮০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H 262/264 oxford road, reading, berks.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ ফেব, ১৯৮০একটি চার্জের নিবন্ধন
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ সেপ, ১৯৭৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ অক্টো, ১৯৭৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over the companys estate or interest in all f/h or l/h property, all stocks shares or other securities, all book and other debts. Assignment of goodwill. Floating charge over the undertaking and all other property and assets present and future (see doc M31).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ অক্টো, ১৯৭৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২০ জুল, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0