BAE SYSTEMS MARINE (YSL) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • নিশ্চয়তা বিবৃতি
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামBAE SYSTEMS MARINE (YSL) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিসক্রিয়
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00883985
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    BAE SYSTEMS MARINE (YSL) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    BAE SYSTEMS MARINE (YSL) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Victory Point
    Lyon Way, Frimley
    GU16 7EX Camberley
    Surrey
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    BAE SYSTEMS MARINE (YSL) LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    MARCONI MARINE (YSL) LIMITED১৬ অক্টো, ১৯৯৮১৬ অক্টো, ১৯৯৮
    YARROW SHIPBUILDERS LIMITED২১ জুল, ১৯৬৬২১ জুল, ১৯৬৬

    BAE SYSTEMS MARINE (YSL) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণনা
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩১ ডিসে, ২০২৪
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩০ সেপ, ২০২৫
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০২৩

    BAE SYSTEMS MARINE (YSL) LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?

    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে০৫ জুন, ২০২৫
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে১৯ জুন, ২০২৫
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে০৫ জুন, ২০২৪
    মেয়াদোত্তীর্ণনা

    BAE SYSTEMS MARINE (YSL) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    ১৪ জানু, ২০২৫ তারিখে Mr Anthony Clarke-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১৮ ডিসে, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Robert James Hinton-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৮ ডিসে, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Ann-Louise Holding এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২৩ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    ০৫ জুন, ২০২৪ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ০১ জুন, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Anthony Clarke-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ৩১ মে, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে David Stanley Parkes এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ জুন, ২০২৪ তারিখে সচিব হিসাবে Mr Anthony Clarke-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    ৩১ মে, ২০২৪ তারিখে সচিব হিসাবে David Stanley Parkes এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ০৪ ডিসে, ২০২৩ তারিখে Mr David Stanley Parkes-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০৪ ডিসে, ২০২৩ তারিখে Mr David Stanley Parkes-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    ০৪ ডিসে, ২০২৩ তারিখে Ms Ann-Louise Louise Holding-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০৪ ডিসে, ২০২৩ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Meslink Limited এর বিবরণের পরিবর্তন

    2 পৃষ্ঠাPSC05

    ০৪ ডিসে, ২০২৩ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Warwick House, PO Box 87 Farnborough Aerospace Centre Farnborough Hampshire GU14 6YU থেকে Victory Point Lyon Way, Frimley Camberley Surrey GU16 7EXপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২২ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    ০৫ জুন, ২০২৩ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২১ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    ০১ জুন, ২০২২ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    ০১ জুন, ২০২১ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ২৮ মে, ২০২১ তারিখে Mr David Stanley Parkes-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    ০১ জুন, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    ০১ জুন, ২০১৯ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    BAE SYSTEMS MARINE (YSL) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    CLARKE, Anthony
    SW1Y 5AD London
    6 Carlton Gardens
    England
    সচিব
    SW1Y 5AD London
    6 Carlton Gardens
    England
    323756730001
    CLARKE, Anthony
    SW1Y 5AD London
    6 Carlton Gardens
    England
    পরিচালক
    SW1Y 5AD London
    6 Carlton Gardens
    England
    EnglandBritishCompany Secretary246655390003
    HINTON, Robert James
    SW1Y 5AD London
    6 Carlton Gardens
    England
    পরিচালক
    SW1Y 5AD London
    6 Carlton Gardens
    England
    EnglandBritishDirector321430700001
    AXUP, William Bernard Noel
    5 Drumadoon Drive
    G84 9SF Helensburgh
    Dunbartonshire
    সচিব
    5 Drumadoon Drive
    G84 9SF Helensburgh
    Dunbartonshire
    BritishProject Director15010440001
    BURTON, Gerald
    35 Morlich Grove
    Dalgety Bay
    KY11 5UX Dunfermline
    Fife
    সচিব
    35 Morlich Grove
    Dalgety Bay
    KY11 5UX Dunfermline
    Fife
    BritishFinance Director49538130001
    MCNEILAGE, Alan Gordon
    Greenwood Lochwinnoch Road
    PA13 4DZ Kilmacolm
    Renfrewshire
    সচিব
    Greenwood Lochwinnoch Road
    PA13 4DZ Kilmacolm
    Renfrewshire
    British15010430001
    PARKES, David Stanley
    Lyon Way, Frimley
    GU16 7EX Camberley
    Victory Point
    Surrey
    England
    সচিব
    Lyon Way, Frimley
    GU16 7EX Camberley
    Victory Point
    Surrey
    England
    British25179240002
    PEACHEY, Eric Albert
    27 Ripon Way
    AL4 9AJ St Albans
    Hertfordshire
    সচিব
    27 Ripon Way
    AL4 9AJ St Albans
    Hertfordshire
    British904210001
    SEMPLE, Mitchell Scott
    Bonnyton Cottage
    Eaglesham
    G76 0PY Glasgow
    Lanarkshire
    সচিব
    Bonnyton Cottage
    Eaglesham
    G76 0PY Glasgow
    Lanarkshire
    BritishChartered Accountant365320001
    ALEXANDER, Brian William
    35 Blackwood Road
    Milngavie
    G62 7LB Glasgow
    Scotland
    পরিচালক
    35 Blackwood Road
    Milngavie
    G62 7LB Glasgow
    Scotland
    BritishAccountant49918010001
    AXUP, William Bernard Noel
    5 Drumadoon Drive
    G84 9SF Helensburgh
    Dunbartonshire
    পরিচালক
    5 Drumadoon Drive
    G84 9SF Helensburgh
    Dunbartonshire
    BritishProjects Director15010440001
    BRAY, Kelvin Arthur
    17 Cherry Tree Lane
    Nettleham
    LN2 2PR Lincoln
    Lincolnshire
    পরিচালক
    17 Cherry Tree Lane
    Nettleham
    LN2 2PR Lincoln
    Lincolnshire
    United KingdomBritishChartered Engineer64319250001
    BRYSON, Lindsay, Admiral Sir
    74 Dyke Road Avenue
    BN1 5LE Brighton
    East Sussex
    পরিচালক
    74 Dyke Road Avenue
    BN1 5LE Brighton
    East Sussex
    BritishEngineer3980940001
    BUCHANAN, Richard Angus Fownes
    2/R 15 Beaumont Gate
    Dowanhill
    G12 9ED Glasgow
    Scotland
    পরিচালক
    2/R 15 Beaumont Gate
    Dowanhill
    G12 9ED Glasgow
    Scotland
    BritishProject Director54238000001
    BURTON, Gerald
    50 Douglas Park Crescent
    Beardson
    G31 3DN Glasgow
    পরিচালক
    50 Douglas Park Crescent
    Beardson
    G31 3DN Glasgow
    BritishFinance Director49538130002
    DAVIES, Raymond John Gwynmor
    Laneside
    High Casterton
    LA6 2SF Kirkby Lonsdale
    Cumbria
    পরিচালক
    Laneside
    High Casterton
    LA6 2SF Kirkby Lonsdale
    Cumbria
    BritishPersonnel & Quality Assurance2294430001
    EASTON, Murray Simpson
    7 Cromalt Crescent North Baljaffray
    Bearsden
    G61 4RX Glasgow
    পরিচালক
    7 Cromalt Crescent North Baljaffray
    Bearsden
    G61 4RX Glasgow
    BritishOperations Director52962730001
    EASTON, Robert, Sir
    "Springfield"
    Stuckenduff
    G84 8NW Shandon
    Dunbartonshire
    Scotland
    পরিচালক
    "Springfield"
    Stuckenduff
    G84 8NW Shandon
    Dunbartonshire
    Scotland
    BritishChairman1111700001
    GEORGE, Brian Victor
    Wethersfield Wood Street
    Bushley Green
    GL20 6JA Tewkesbury
    Gloucestershire
    পরিচালক
    Wethersfield Wood Street
    Bushley Green
    GL20 6JA Tewkesbury
    Gloucestershire
    BritishGroup Managing Director34400710001
    GERSHON, Peter Oliver, Sir
    Old Rafters Magpie Lane
    Coleshill
    HP7 0LU Amersham
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Old Rafters Magpie Lane
    Coleshill
    HP7 0LU Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishManaging Director102014200001
    HOLDING, Ann-Louise
    Lyon Way, Frimley
    GU16 7EX Camberley
    Victory Point
    Surrey
    England
    পরিচালক
    Lyon Way, Frimley
    GU16 7EX Camberley
    Victory Point
    Surrey
    England
    EnglandBritishChartered Secretary73464490003
    IMMS, Robin John
    Mill Cottage
    Maperton Road, Charlton Horethorne
    DT9 4NT Sherborne
    Dorset
    পরিচালক
    Mill Cottage
    Maperton Road, Charlton Horethorne
    DT9 4NT Sherborne
    Dorset
    BritishFinancial Director70995850001
    LYNAS, Peter John, Mr.
    PO9
    পরিচালক
    PO9
    United KingdomBritishFinancial Director30789300002
    MCCOMAS, Samuel
    1 Gainburn Court
    Cumbernauld
    G67 4QG Glasgow
    North Lanark
    পরিচালক
    1 Gainburn Court
    Cumbernauld
    G67 4QG Glasgow
    North Lanark
    BritishQuality Director45406920001
    MCIVER, John
    76 Eton Drive
    Thornton Hough
    CH63 1JS Wirral
    Merseyside
    পরিচালক
    76 Eton Drive
    Thornton Hough
    CH63 1JS Wirral
    Merseyside
    BritishTechnical Director87797040001
    MCNEILAGE, Alan Gordon
    Greenwood Lochwinnoch Road
    PA13 4DZ Kilmacolm
    Renfrewshire
    পরিচালক
    Greenwood Lochwinnoch Road
    PA13 4DZ Kilmacolm
    Renfrewshire
    BritishFinancial Director15010430001
    MCNEILAGE, Alan Gordon
    Greenwood Lochwinnoch Road
    PA13 4DZ Kilmacolm
    Renfrewshire
    পরিচালক
    Greenwood Lochwinnoch Road
    PA13 4DZ Kilmacolm
    Renfrewshire
    BritishChartered Accountant15010430001
    MUSGRAVE, Colin James
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    পরিচালক
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    BritishSolicitor1086950001
    PARKES, David Stanley
    Lyon Way, Frimley
    GU16 7EX Camberley
    Victory Point
    Surrey
    England
    পরিচালক
    Lyon Way, Frimley
    GU16 7EX Camberley
    Victory Point
    Surrey
    England
    EnglandBritishCompany Secretary25179240048
    RIGBY, Robert Harry
    10 Harrop Road
    Hale
    WA15 9BX Altrincham
    Cheshire
    পরিচালক
    10 Harrop Road
    Hale
    WA15 9BX Altrincham
    Cheshire
    BritishManaging Director47005190001
    SEMPLE, Mitchell Scott
    Bonnyton Cottage
    Eaglesham
    G76 0PY Glasgow
    Lanarkshire
    পরিচালক
    Bonnyton Cottage
    Eaglesham
    G76 0PY Glasgow
    Lanarkshire
    BritishChartered Accountant365320001
    SEMPLE, William
    44 Strathmore Avenue
    PA1 3EE Paisley
    Renfrewshire
    পরিচালক
    44 Strathmore Avenue
    PA1 3EE Paisley
    Renfrewshire
    BritishCommercial Director38628700001
    SMITH, Eric Watson
    23 Newtyle Road
    Ralston
    PA1 3JU Paisley
    Lanarkshire
    পরিচালক
    23 Newtyle Road
    Ralston
    PA1 3JU Paisley
    Lanarkshire
    BritishPersonnel Director23132120003

    BAE SYSTEMS MARINE (YSL) LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Lyon Way, Frimley
    GU16 7EX Camberley
    Victory Point
    Surrey
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Lyon Way, Frimley
    GU16 7EX Camberley
    Victory Point
    Surrey
    England
    না
    আইনি ফর্মLimited By Shares
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষUnited Kingdom (England)
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর3764142
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    BAE SYSTEMS MARINE (YSL) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Company letting agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ মার্চ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ মার্চ, ১৯৯৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the company letting agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The deposit of £3,000. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Pennant Investments Limited
    ব্যবসায়
    • ১৫ মার্চ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Bond and assignation in security registered pursuant to an order of court
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ জুন, ১৯৭২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ আগ, ১৯৭২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the company's right title and interest in and to a contract dated 5TH june, 1972 all the company's right title and interest in and to the benefit of all sub contracts entered into by the company for the purpose of supplying the spares. All monies payable to the company in respect of the insurances effected by the company under that agreement all monies payable to the company under a policy to the entered into by the company for the ecgp. The amount for the time being standing to the credit of the designated account pl see doc 40 for details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Chartered Bank
    ব্যবসায়
    • ০২ আগ, ১৯৭২একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৪ এপ্রি, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Agreement registered pursuant to an order of court
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ জুন, ১৯৭২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ আগ, ১৯৭২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the company's right title and interest in and to a contract dated 5TH june, 1972 all the company's right title and interest in and to the benefit of all sub contracts entered into by the company for the purpose of supplying the spares. All monies payable to the company in respect of the insurances effected by the company under that agreement.all monies payable to the company under a policy to the entered into by the the company for the E.C.G.P. the amount for the time being standing to the credit of the designated account.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Chartered Bank
    ব্যবসায়
    • ০২ আগ, ১৯৭২একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৯ এপ্রি, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Financial agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ১৯৬৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ অক্টো, ১৯৬৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    For securing all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the right title and interest in and to the benefit of all sub-contracts entered into by the company for purpose of building a frigate for yarrow and company limited for sale to the royal thai navy and all monies payable to the company in respect of any insurances that may be taken out in respect of the frigate, the engines, boilers machinery & all other materials. (For full details see doc 26).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Chartered Bank
    ব্যবসায়
    • ১০ অক্টো, ১৯৬৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৪ এপ্রি, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ জুন, ১৯৬৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ অক্টো, ১৯৬৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £240,000
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Plot of ground with office block thereon situated at south street glasgow.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Yarrow and Company Limited
    ব্যবসায়
    • ৩০ অক্টো, ১৯৬৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মে, ১৯৬৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ মে, ১৯৬৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    Debenture for securing all monies due etc. pursuant to an agreement dated 7/2/68
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Floating charge (see doc 21 further details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Ship Building Industry Board
    ব্যবসায়
    • ২১ মে, ১৯৬৮একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0