TOWERGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামTOWERGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00892968
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    TOWERGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    TOWERGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    TOWERGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    HALL & CLARKE INSURANCE BROKERS LIMITED৩০ জুল, ২০০৮৩০ জুল, ২০০৮
    HALL & CLARKE INSURANCE BROKERS LIMITED২৬ আগ, ২০০৫২৬ আগ, ২০০৫
    HALL & CLARKE INSURANCE BROKERS PLC১৮ নভে, ১৯৮৬১৮ নভে, ১৯৮৬
    HALL AND CLARKE (INSURANCE CONSULTANTS) LIMITED২৯ নভে, ১৯৬৬২৯ নভে, ১৯৬৬

    TOWERGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৬

    TOWERGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    6 পৃষ্ঠাLIQ13

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    ১১ সেপ, ২০১৭ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Towergate House Eclipse Park, Sittingbourne Road Maidstone Kent ME14 3EN থেকে 15 Canada Square London E14 5GLপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ১৫ আগ, ২০১৭ তারিখে

    LRESSP

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    5 পৃষ্ঠাLIQ01

    ২০ এপ্রি, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    ২০ ডিসে, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr David Christopher Ross-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২০ ডিসে, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে Mrs Jacqueline Anne Gregory-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২০ এপ্রি, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৩ মে, ২০১৬

    ১৩ মে, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 50,000
    SH01

    ০১ মার্চ, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে Jennifer Owens এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ২৫ নভে, ২০১৫ তারিখে Mr Mark Stephen Mugge-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১৪ সেপ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Scott Egan এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১১ সেপ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Mark Stephen Mugge-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২০ এপ্রি, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৯ এপ্রি, ২০১৫

    ২৯ এপ্রি, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 50,000
    SH01

    ১৭ অক্টো, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mark Steven Hodges এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed hall & clarke insurance brokers LIMITED\certificate issued on 12/08/14
    3 পৃষ্ঠাCERTNM
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name১২ আগ, ২০১৪

    রেজোলিউশন দ্বারা নাম পরিবর্তন

    NM01
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ০৭ আগ, ২০১৪

    RES15

    বার্ষিক রিটার্ন ২০ এপ্রি, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২২ এপ্রি, ২০১৪

    ২২ এপ্রি, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 50,000
    SH01

    ২৫ নভে, ২০১৩ তারিখে সচিব হিসাবে Jennifer Owens-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    ০৮ অক্টো, ২০১৩ তারিখে সচিব হিসাবে Samuel Thomas Budgen Clark এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    TOWERGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    GREGORY, Jacqueline Anne
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    সচিব
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    221958200001
    MUGGE, Mark Stephen
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    পরিচালক
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    EnglandBritish162920630005
    ROSS, David Christopher
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    পরিচালক
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    United KingdomIrish222326970001
    CLARK, Darryl
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    সচিব
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    153022630001
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    সচিব
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    161870940001
    CLARKE, Margaret Mary
    Lawford Wokingham Road
    Hurst
    RG10 0RX Reading
    Berkshire
    সচিব
    Lawford Wokingham Road
    Hurst
    RG10 0RX Reading
    Berkshire
    British8288020001
    CRATON, Timothy Charles
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    সচিব
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    British76055420004
    HUNTER, Andrew Stewart
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    সচিব
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    156618560001
    OWENS, Jennifer
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    সচিব
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    183298770001
    REDDI, John
    Farbank 21 First Avenue
    BN14 9NJ Worthing
    West Sussex
    সচিব
    Farbank 21 First Avenue
    BN14 9NJ Worthing
    West Sussex
    British6180280001
    BAKER, Peter James
    50 Honister Heights
    CR8 1EU Purley
    Surrey
    পরিচালক
    50 Honister Heights
    CR8 1EU Purley
    Surrey
    British8288030001
    BOGART, Robert Patrick
    21 Beech Way
    Wheathampstead
    AL4 8LY St Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    21 Beech Way
    Wheathampstead
    AL4 8LY St Albans
    Hertfordshire
    ScotlandBritish104023310001
    BOLSHAW, Matthew
    Chipperfield
    Back Lane
    WD25 8EJ Letchmore Heath
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Chipperfield
    Back Lane
    WD25 8EJ Letchmore Heath
    Hertfordshire
    EnglandBritish98898670002
    CLARKE, Dudley John
    Lawford Wokingham Road
    Hurst
    RG10 0RX Reading
    Berkshire
    পরিচালক
    Lawford Wokingham Road
    Hurst
    RG10 0RX Reading
    Berkshire
    British8288040001
    CLARKE, Simon John
    Westbury
    Harvest Hill
    SL8 5JJ Hedsor
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Westbury
    Harvest Hill
    SL8 5JJ Hedsor
    Buckinghamshire
    British41695010003
    CULLUM, Peter Geoffrey
    Wealden Hall
    Parkfield
    TN15 0HX Sevenoaks
    Kent
    পরিচালক
    Wealden Hall
    Parkfield
    TN15 0HX Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish59873490009
    EARL, David George
    Cecil Close
    CM23 5RD Bishop's Stortford
    5
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Cecil Close
    CM23 5RD Bishop's Stortford
    5
    Hertfordshire
    EnglandBritish109451630001
    EGAN, Scott
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    পরিচালক
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish170703910001
    HODGES, Mark Steven
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    পরিচালক
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish58444370003
    JOHNSON, Timothy David
    The Green
    Westerham
    TN16 1AS Kent
    Nursery Cottage 3a
    পরিচালক
    The Green
    Westerham
    TN16 1AS Kent
    Nursery Cottage 3a
    EnglandBritish129538180001
    PHILIP, Timothy Duncan
    20 The Old Saw Mill
    Long Mill Lane Platt
    TN15 8QJ Sevenoaks
    Kent
    পরিচালক
    20 The Old Saw Mill
    Long Mill Lane Platt
    TN15 8QJ Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish99066410001
    PROVERBS, Antony
    27 Capital Wharf
    50 Wapping High Street
    E1W 1LY London
    পরিচালক
    27 Capital Wharf
    50 Wapping High Street
    E1W 1LY London
    EnglandBritish79185700012
    STEMP, Timothy Daniel
    Orchard Cottage
    Bellington
    HP5 2XW Chesham
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Orchard Cottage
    Bellington
    HP5 2XW Chesham
    Buckinghamshire
    EnglandEnglish72526930003
    TORRANCE, David Winton Watt
    Allt A'Bruaich
    IV4 7HX Kiltarlity
    Inverness-Shire
    পরিচালক
    Allt A'Bruaich
    IV4 7HX Kiltarlity
    Inverness-Shire
    UkBritish5901560006

    TOWERGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Towergate Insurance Limited
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    না
    আইনি ফর্মCompany Limited By Shares
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House Cardiff
    নিবন্ধন নম্বর07476462
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    TOWERGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ আগ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ আগ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H 302-308 preston road, harrow, middlesex. T/no. NGL725723. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ আগ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ জুন, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জুল, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ আগ, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ আগ, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ অক্টো, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Further charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ এপ্রি, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ এপ্রি, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £15,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a mortgage dated 17.12.81.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (1) f/H. Land and buildings known as 67 park royal road park royal, acton, ealing london. Title no: mx 474707. (2) f/h land and buildings known as stone at 249 acton lane, park royal, acton. Title no: ngl 517926.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Abbey National Building Society
    ব্যবসায়
    • ২৬ এপ্রি, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ এপ্রি, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ মে, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First fixed charge on all book & other debts with a floating charge all the (please see doc M45). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ মে, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ জানু, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ জানু, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a lawford wokingham road hurst berkshire title no bk 80844.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ জানু, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ ডিসে, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ডিসে, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £58,773.25 and further advances from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land & land k/a "lawford" workingham road, hurst berkshire title no bk 80844.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Abbey National Building Society
    ব্যবসায়
    • ০৮ ডিসে, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ ডিসে, ১৯৮১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ ডিসে, ১৯৮১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £25,000.25 and all other monies due or to beome due from the company to the chargee.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land & offices at 67 park royal road, acton london borough of ealing. Title no:- mx 474707.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Abbey National Building Society
    ব্যবসায়
    • ২১ ডিসে, ১৯৮১একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ এপ্রি, ১৯৮০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ এপ্রি, ১৯৮০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land & premises being 67 park royal road, acton, london borough of ealing. Tog. With all fixtures. Title no:- mx 474707.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ এপ্রি, ১৯৮০একটি চার্জের নিবন্ধন

    TOWERGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২৮ মে, ২০১৮ভেঙে গেছে
    ১৫ আগ, ২০১৭ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    অভ্যাসকারী
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    অভ্যাসকারী
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0