WIPAC GROUP (HOLDINGS) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামWIPAC GROUP (HOLDINGS) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00910691
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    WIPAC GROUP (HOLDINGS) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (9999) /

    WIPAC GROUP (HOLDINGS) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    WIPAC GROUP (HOLDINGS) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ জুল, ২০০৯

    WIPAC GROUP (HOLDINGS) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01
    AQR6XQJ3

    বার্ষিক রিটার্ন ০৩ নভে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৯ নভে, ২০১০

    ০৯ নভে, ২০১০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 250,000
    SH01
    XW5IEOXF

    ২৩ সেপ, ২০১০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    4 পৃষ্ঠাSH19
    A79QZNLN

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20
    RSAXBNL9

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS
    RSAXCNLA

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    3 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Canc share prem/undist reserves 15/09/2010
    RES13

    পরিচালক হিসাবে Stephen Webster এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01
    XN4C6JH6

    পরিচালক হিসাবে Mr Robert Andrew Ross Smith-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01
    XN4CFJHF

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ জুল, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA
    PO006H55

    বার্ষিক রিটার্ন ০৩ নভে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    XY4CNET5

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Stephen Paul Webster-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01
    XM1XBE39

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Alison Drew-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03
    XLSTKE34

    হিসাব ৩১ জুল, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA
    A840E5AF

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a
    X6XZ0504

    legacy

    5 পৃষ্ঠা363a

    হিসাব ৩১ জুল, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    5 পৃষ্ঠা363a

    হিসাব ৩১ জুল, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    হিসাব ৩১ জুল, ২০০৫ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    WIPAC GROUP (HOLDINGS) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    DREW, Alison
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    সচিব
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    British86845230002
    SMITH, Robert Andrew Ross
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4GA Reading
    Parkview 1220
    United Kingdom
    পরিচালক
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4GA Reading
    Parkview 1220
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant150753930001
    WOLSELEY DIRECTORS LIMITED
    Parkview 1220
    Arlington Business Park, Theale
    RG7 4GA Reading
    কর্পোরেট পরিচালক
    Parkview 1220
    Arlington Business Park, Theale
    RG7 4GA Reading
    122185200001
    BRANSON, David Anthony
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    সচিব
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    British272310001
    BUSHNELL, Adrian John
    138 Goddard Way
    CB10 2ED Saffron Walden
    Essex
    সচিব
    138 Goddard Way
    CB10 2ED Saffron Walden
    Essex
    BritishChartered Secretary43046230002
    FITZGERALD, Christopher John
    Field View Cottage
    Main Street Farthingstone
    NN12 8EZ Towcester
    Northamptonshire
    সচিব
    Field View Cottage
    Main Street Farthingstone
    NN12 8EZ Towcester
    Northamptonshire
    British86703050001
    MARKANDAY, Vijay
    20 Birchdale
    SL9 7JA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    সচিব
    20 Birchdale
    SL9 7JA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishDirector49523130001
    PARKER, Edward Geoffrey
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    সচিব
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    BritishChartered Secretary37378570013
    TURNER, John Patrick
    3 High Beeches
    Frimley
    GU16 8UG Camberley
    Surrey
    সচিব
    3 High Beeches
    Frimley
    GU16 8UG Camberley
    Surrey
    BritishFinance Director & Company Sec53281480001
    WHITE, Mark Jonathan
    Hawthorn House
    2 Wards Drive, Sarratt
    WD3 6AE Rickmansworth
    Herts
    সচিব
    Hawthorn House
    2 Wards Drive, Sarratt
    WD3 6AE Rickmansworth
    Herts
    BritishSolicitor82978250002
    BRANSON, David Anthony
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    পরিচালক
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    BritishCompany Director/Secretary272310001
    BROWN, Alan James
    2 Church Road
    CV8 3AR Baginton
    Lucy Price House
    Warwickshire
    পরিচালক
    2 Church Road
    CV8 3AR Baginton
    Lucy Price House
    Warwickshire
    United KingdomBritishMetallurgist124294280002
    BUSHNELL, Adrian John
    138 Goddard Way
    CB10 2ED Saffron Walden
    Essex
    পরিচালক
    138 Goddard Way
    CB10 2ED Saffron Walden
    Essex
    BritishChartered Secretary43046230002
    EARL, Geoffrey James
    3 Holcutt Close
    Wootton
    NN4 6AE Northampton
    পরিচালক
    3 Holcutt Close
    Wootton
    NN4 6AE Northampton
    United KingdomBritishCompany Director86673550001
    FITZGERALD, Christopher John
    Field View Cottage
    Main Street Farthingstone
    NN12 8EZ Towcester
    Northamptonshire
    পরিচালক
    Field View Cottage
    Main Street Farthingstone
    NN12 8EZ Towcester
    Northamptonshire
    United KingdomBritishChartered Accountant86703050001
    LANDSBERG, Kenneth William
    1 Lower Common Road
    SW15 1BP London
    পরিচালক
    1 Lower Common Road
    SW15 1BP London
    BritishChartered Accountant67271850002
    MARKANDAY, Vijay
    20 Birchdale
    SL9 7JA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    20 Birchdale
    SL9 7JA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishDirector49523130001
    MASTERS, Alexander Frank
    Grove Spring Nightingales Lane
    HP8 4SG Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Grove Spring Nightingales Lane
    HP8 4SG Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director9424220001
    PARKER, Edward Geoffrey
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    পরিচালক
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    BritishChartered Secretary37378570013
    ROBERTSON-SMITH, Michael John
    42 Mansell Street
    CV37 6NR Stratford Upon Avon
    পরিচালক
    42 Mansell Street
    CV37 6NR Stratford Upon Avon
    United KingdomBritishEngineer85369940001
    SHEPHERD, David Nigel
    1 Brookside
    Woodford Halse
    NN11 3RU Daventry
    Northamptonshire
    পরিচালক
    1 Brookside
    Woodford Halse
    NN11 3RU Daventry
    Northamptonshire
    BritishDirector40976920001
    TURNER, John Patrick
    3 High Beeches
    Frimley
    GU16 8UG Camberley
    Surrey
    পরিচালক
    3 High Beeches
    Frimley
    GU16 8UG Camberley
    Surrey
    GbBritishFinance Director & Company Sec53281480001
    WANSBROUGH, David George Rawdon
    Acorns
    Thursley
    GU8 6NJ Godalming
    Surrey
    পরিচালক
    Acorns
    Thursley
    GU8 6NJ Godalming
    Surrey
    BritishCompany Director47849990001
    WARD, Malcolm Stuart
    Blakes Cottage Horn Street
    Winslow
    MK18 3AP Buckingham
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Blakes Cottage Horn Street
    Winslow
    MK18 3AP Buckingham
    Buckinghamshire
    BritishManaging Director35014310003
    WEBSTER, Stephen Paul
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    পরিচালক
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    United KingdomBritishCompany Director40201730005
    WHITE, Mark Jonathan
    Hawthorn House
    2 Wards Drive, Sarratt
    WD3 6AE Rickmansworth
    Herts
    পরিচালক
    Hawthorn House
    2 Wards Drive, Sarratt
    WD3 6AE Rickmansworth
    Herts
    EnglandBritishSolicitor82978250002

    WIPAC GROUP (HOLDINGS) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ ডিসে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ জানু, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or wipac group limited to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The land defined as "the wipac land" being land lying to the west of london road,buckingham,bucks.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ জানু, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ অক্টো, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ ফেব, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ মার্চ, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for eci investments and for eci international trust and custodian of eci international limited partnership acting both on its own behalf and as trustee for the noteholders under the terms of the guarantee, the loan notes both dated 28.2.91 or any other security
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of second floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    ব্যবসায়
    • ০১ মার্চ, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৭ জানু, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ ডিসে, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ ডিসে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ ডিসে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ অক্টো, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ জুল, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ জুল, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Factory & warehouse premises ondon road buckingham buckinghamshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ জুল, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ অক্টো, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ জানু, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ জানু, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement d/d 22.1.88 and this charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Wipac Property Holdings Limited
    ব্যবসায়
    • ২৭ জানু, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ অক্টো, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ অক্টো, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ নভে, ১৯৮৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £115,000
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    B a h metallising plant as specified in the schedule. (For further details see form 395 dated. 11/11/86.).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Park Place Credit Limited.
    ব্যবসায়
    • ১১ নভে, ১৯৮৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ জানু, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ ফেব, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ ফেব, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ অক্টো, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0