LOGICAL COMMERCE LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামLOGICAL COMMERCE LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00919643
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    LOGICAL COMMERCE LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    LOGICAL COMMERCE LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    LOGICAL COMMERCE LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    DIAMOND PLATFORMS LIMITED০৮ নভে, ১৯৯৫০৮ নভে, ১৯৯৫
    EXETER HIRE CENTRE LIMITED২৫ অক্টো, ১৯৬৭২৫ অক্টো, ১৯৬৭

    LOGICAL COMMERCE LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৭

    LOGICAL COMMERCE LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    8 পৃষ্ঠাLIQ13

    ৩০ এপ্রি, ২০১৯ তারিখে সচিব হিসাবে Jerome Sarragozi এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ২৫ জানু, ২০১৯ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 15 Midland Court Central Park Lutterworth Leicestershire LE17 4PN England থেকে 30 Finsbury Square London EC2P 2YUপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    5 পৃষ্ঠাLIQ01

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    4 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ০৭ জানু, ২০১৯ তারিখে

    LRESSP

    ০৫ ডিসে, ২০১৮ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    16 পৃষ্ঠাAA

    ০২ ডিসে, ২০১৭ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ২৮ জুল, ২০১৭ তারিখে সচিব হিসাবে Mr Jerome Sarragozi-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    ২৮ জুল, ২০১৭ তারিখে সচিব হিসাবে Richard Andrew Cole এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ২৪ জুল, ২০১৭ তারিখে Mr Donald Thomas Kenny-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    16 পৃষ্ঠাAA

    ০১ জুল, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Thomas Anthony Murray-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ৩০ জুন, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Alan Stuart Merrell এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    চার্জ 13 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    ২৮ ফেব, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Jeremy Peter Fish এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০২ ডিসে, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    অডিটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাAUD

    ৩১ আগ, ২০১৬ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 145-157 st. John Street London EC1V 4PY থেকে 15 Midland Court Central Park Lutterworth Leicestershire LE17 4PNপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    ০৭ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে Alan Stuart Merrell এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ০৭ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে Richard Andrew Cole-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    বার্ষিক রিটার্ন ০২ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২২ ডিসে, ২০১৫

    ২২ ডিসে, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    LOGICAL COMMERCE LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    KENNY, Thomas Donald
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    England
    পরিচালক
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    England
    EnglandIrish165677760002
    MURRAY, Thomas Anthony
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    পরিচালক
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    EnglandBritish198214500001
    COLE, Richard Andrew
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    England
    সচিব
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    England
    207374600001
    FRANKLIN, Karen Jane
    189 Marldon Road
    TQ3 3NB Paignton
    Devon
    সচিব
    189 Marldon Road
    TQ3 3NB Paignton
    Devon
    British24926760001
    HILL, Percy James Hannaford
    65 Southfield Avenue
    TQ3 1LQ Paignton
    Devon
    সচিব
    65 Southfield Avenue
    TQ3 1LQ Paignton
    Devon
    British34368290001
    MERRELL, Alan Stuart
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    সচিব
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    British59110640004
    SARRAGOZI, Jerome
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    সচিব
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    236102320001
    SHIPMAN, David Cyril
    Church Farm
    Church Lane
    DE7 6DE Morley
    Derbyshire
    সচিব
    Church Farm
    Church Lane
    DE7 6DE Morley
    Derbyshire
    British77501360001
    APPLETON, Kevin Andrew
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    পরিচালক
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    EnglandBritish67821450016
    BAKER, Austin Philip
    4 Meadowcroft Drive
    Kingsteignton
    TQ12 3PB Newton Abbot
    Devon
    পরিচালক
    4 Meadowcroft Drive
    Kingsteignton
    TQ12 3PB Newton Abbot
    Devon
    British44426070001
    FISH, Jeremy Peter
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    England
    পরিচালক
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    England
    EnglandBritish160373640001
    FRANKLIN, Karen Jane
    189 Marldon Road
    TQ3 3NB Paignton
    Devon
    পরিচালক
    189 Marldon Road
    TQ3 3NB Paignton
    Devon
    British24926760001
    GANSSER-POTTS, Michael David
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    পরিচালক
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    EnglandBritish158445070001
    GESTETNER, Geoffrey Sigmund
    Flat 5 160 Gloucester Terrace
    W2 6HR London
    পরিচালক
    Flat 5 160 Gloucester Terrace
    W2 6HR London
    British47136960001
    MCMEEKING, Robert John
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    পরিচালক
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    United KingdomBritish75448720003
    MERRELL, Alan Stuart
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    পরিচালক
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    United KingdomBritish59110640004
    PRICE, David Lawrence
    Brook Farm
    Luddington In Th Brook
    PE28 0HB Oundle
    Northamptonshire
    পরিচালক
    Brook Farm
    Luddington In Th Brook
    PE28 0HB Oundle
    Northamptonshire
    British25187800003
    SHIPMAN, David Cyril
    Church Farm
    Church Lane
    DE7 6DE Morley
    Derbyshire
    পরিচালক
    Church Farm
    Church Lane
    DE7 6DE Morley
    Derbyshire
    British77501360001
    TANNER, Cecilia Kathleen Bessie
    Three Tors Higher Cadewell Lane
    Shiphay
    TQ2 7EX Torquay
    Devon
    পরিচালক
    Three Tors Higher Cadewell Lane
    Shiphay
    TQ2 7EX Torquay
    Devon
    British24926770001
    TANNER, Charles Derek
    Three Tors
    66 Higher Cadewell Lane Shiphay
    TQ2 7EX Torquay
    Devon
    পরিচালক
    Three Tors
    66 Higher Cadewell Lane Shiphay
    TQ2 7EX Torquay
    Devon
    British79342340001
    TANNER, Dale Charles
    5 Fair Isle Close
    Scotts Meadow Barton
    TQ2 7BT Torquay
    Devon
    পরিচালক
    5 Fair Isle Close
    Scotts Meadow Barton
    TQ2 7BT Torquay
    Devon
    British43117330002
    WRIGHT, Andrew John
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    পরিচালক
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    United KingdomBritish122845150001

    LOGICAL COMMERCE LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Zooom Holdings (Uk) Limited
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    England
    না
    আইনি ফর্মLimited Company
    নিবন্ধিত দেশUk
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act
    নিবন্ধিত স্থানEngland & Wales
    নিবন্ধন নম্বর4812536
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।

    LOGICAL COMMERCE LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ মার্চ, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ মার্চ, ২০১২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from an obligor or the obligors to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the security created under the deed is created in favour of the security agent for and on behalf of the secured parties is created over present and future assets of the company is security of the payment and discharge of all the secured obliations see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ২৭ মার্চ, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ২২ জুন, ২০১৭একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ নভে, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ নভে, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over all assets present and future, including goodwill, uncalled capital, shares, dividends, plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee) as Agent and/or Trustee for the Finance Parties
    ব্যবসায়
    • ২৭ নভে, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০৫ এপ্রি, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ সেপ, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ সেপ, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the obligors to any one or more of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The “Security Trustee”)
    ব্যবসায়
    • ২০ সেপ, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ এপ্রি, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১২ মার্চ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ মার্চ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২০ মার্চ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ আগ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ জুন, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ জুন, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge on all book debts and other debts owing to the company. Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts except those mentioned above uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ জুন, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৩ জুল, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ নভে, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ নভে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Hereditaments and premises being 10 bittern road, sowton industrial estate exeter, devon.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ নভে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৮ মে, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge as evidenced by a statutory declaration dated 17/2/87
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ জানু, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ জানু, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Warehouse premises on the north west side of salterton road, exmouth, devon.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ জানু, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৮ মে, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ আগ, ১৯৮১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ আগ, ১৯৮১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H 27 fore street, exmouth, devon.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ আগ, ১৯৮১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৮ মে, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ আগ, ১৯৮১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ আগ, ১৯৮১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H 10 bittern road, sowton industrial estate, exeter, devon.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ আগ, ১৯৮১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২০ আগ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattels mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ এপ্রি, ১৯৮১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ এপ্রি, ১৯৮১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All and singular the chattels, plant machinery and items described or referred to in the schedule (see doc M31 for details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Forward Trust LTD
    ব্যবসায়
    • ০৯ এপ্রি, ১৯৮১একটি চার্জের নিবন্ধন
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ জুল, ১৯৭৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ জুল, ১৯৭৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £8,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Shop & dwellinghouse, no 145, pinhoe road, exeter devon, title no dn 59731.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • E.J.Allen.
    ব্যবসায়
    • ২৮ জুল, ১৯৭৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ আগ, ১৯৭২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ আগ, ১৯৭২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys due etc.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Floating charge on the undertaking and all property present and future including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ আগ, ১৯৭২একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৮ ডিসে, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ মে, ১৯৬৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ মে, ১৯৬৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys due etc.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Plots 110 & 111 leadewell estate extension berkeley avenue, torquay.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ মে, ১৯৬৮একটি চার্জের নিবন্ধন

    LOGICAL COMMERCE LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০৭ জানু, ২০১৯ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ০৬ ডিসে, ২০১৯ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    অভ্যাসকারী
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0