PETER BLACK HEALTHCARE LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামPETER BLACK HEALTHCARE LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00931141
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    PETER BLACK HEALTHCARE LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    PETER BLACK HEALTHCARE LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Second Floor
    One Hood Street
    NE1 6JQ Newcastle Upon Tyne
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    PETER BLACK HEALTHCARE LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    ENGLISH GRAINS (HOLDINGS) LIMITED০১ জুন, ১৯৯৫০১ জুন, ১৯৯৫
    ENGLISH GRAINS LIMITED২৬ এপ্রি, ১৯৬৮২৬ এপ্রি, ১৯৬৮

    PETER BLACK HEALTHCARE LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৪

    PETER BLACK HEALTHCARE LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    13 পৃষ্ঠাLIQ13

    ২১ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    17 পৃষ্ঠাLIQ03

    ১২ এপ্রি, ২০১৭ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Fernwood House Fernwood Road Jesmond Newcastle upon Tyne NE2 1TJ থেকে Second Floor One Hood Street Newcastle upon Tyne NE1 6JQপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    দেউলিয়া আদালতের আদেশ

    Court order insolvency:court order re. Removal/replacement of liquidator
    11 পৃষ্ঠাLIQ MISC OC

    স্বেচ্ছাসেবক লিকুইডেটর হিসাবে কাজ বন্ধ করার নোটিশ

    1 পৃষ্ঠা4.40

    ০৮ জুল, ২০১৬ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা , Centenary House Centenary Way, Salford, Manchester, M50 1RF থেকে Saxon House Saxon Way Cheltenham Gloucestershire GL52 6QXপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ২২ জুন, ২০১৬ তারিখে

    LRESSP

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ১৫ জুন, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    ২৫ নভে, ২০১৫ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 5,146,026
    4 পৃষ্ঠাSH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ মে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৪ জুন, ২০১৫

    ০৪ জুন, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    ০৪ নভে, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Ulf Stefan Brettschneider এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    ০৪ নভে, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Nicholas Andrew Cottrell-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ মে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০১ জুল, ২০১৪

    ০১ জুল, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ মে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01

    ৩১ মে, ২০১৩ তারিখে Mr Ulf Stefan Brettschneider-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ৩১ মে, ২০১৩ তারিখে Robert Arthur Bacon-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    PETER BLACK HEALTHCARE LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BACON, Robert Arthur
    Floor
    One Hood Street
    NE1 6JQ Newcastle Upon Tyne
    Second
    পরিচালক
    Floor
    One Hood Street
    NE1 6JQ Newcastle Upon Tyne
    Second
    United KingdomBritishCompany Director192986020001
    COTTRELL, Nicholas Andrew
    Floor
    One Hood Street
    NE1 6JQ Newcastle Upon Tyne
    Second
    পরিচালক
    Floor
    One Hood Street
    NE1 6JQ Newcastle Upon Tyne
    Second
    EnglandBritishCompany Director7316340002
    KERSHAW, Christopher Sydney Sagar
    The Hollies
    Oakworth
    BD22 7HL Keighley
    West Yorkshire
    সচিব
    The Hollies
    Oakworth
    BD22 7HL Keighley
    West Yorkshire
    British1554150009
    KERSHAW, Christopher Sydney Sagar
    The Hollies
    Oakworth
    BD22 7HL Keighley
    West Yorkshire
    সচিব
    The Hollies
    Oakworth
    BD22 7HL Keighley
    West Yorkshire
    British1554150009
    KITSON, John Edward
    Poplar House
    Old Road Dunkeswick
    LS17 9HY Leeds
    West Yorkshire
    সচিব
    Poplar House
    Old Road Dunkeswick
    LS17 9HY Leeds
    West Yorkshire
    British102500730001
    LISTER, Robert Stephen
    Briery Wood
    Hebers Ghyll Drive
    LS29 9QQ Ilkley
    West Yorkshire
    সচিব
    Briery Wood
    Hebers Ghyll Drive
    LS29 9QQ Ilkley
    West Yorkshire
    British161918280001
    ALWAY, Edwin John
    42 Temple Mill Island
    SL7 1SQ Marlow
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    42 Temple Mill Island
    SL7 1SQ Marlow
    Buckinghamshire
    BritishDirector54081430001
    ARGENT, Nicholas Thompson
    3 Davenham Court
    Church Street Davenham
    CW9 8NQ Northwich
    Cheshire
    পরিচালক
    3 Davenham Court
    Church Street Davenham
    CW9 8NQ Northwich
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director42373790002
    BARTON, Robert John
    Sheepwalk Lane
    Ravenshead
    NG15 9FD Nottingham
    35
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    Sheepwalk Lane
    Ravenshead
    NG15 9FD Nottingham
    35
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector136554260001
    BRETTSCHNEIDER, Ulf Stefan
    Centenary Way
    Salford
    M50 1RF Manchester
    Centenary House
    পরিচালক
    Centenary Way
    Salford
    M50 1RF Manchester
    Centenary House
    United KingdomGermanCompany Director125315710001
    BURBAGE, Andrew Samuel
    34 Meadow View
    Rolleston On Dove
    DE13 9AN Burton On Trent
    Staffordshire
    পরিচালক
    34 Meadow View
    Rolleston On Dove
    DE13 9AN Burton On Trent
    Staffordshire
    Umited KimgdomBritishDirector44639850002
    BUSH, Anthony Kenneth Stephen
    75 St Marks Road
    RG9 1LP Henley On Thames
    Oxfordshire
    পরিচালক
    75 St Marks Road
    RG9 1LP Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishDirector66722090001
    CLEMENTS, Alan Gordon
    The Poplars
    24 Blagreaves Lane
    DE23 1FH Littleover
    Derbyshire
    পরিচালক
    The Poplars
    24 Blagreaves Lane
    DE23 1FH Littleover
    Derbyshire
    BritishDirector5123420004
    DONE, Richard John
    25 Aston Hall Drive
    DE72 2DD Aston On Trent
    Derbyshire
    পরিচালক
    25 Aston Hall Drive
    DE72 2DD Aston On Trent
    Derbyshire
    BritishDirector83680220001
    EVANS, Michael Ronford
    Field Place Huggetts Lane
    Willingdon
    BN22 0LH Eastbourne
    East Sussex
    পরিচালক
    Field Place Huggetts Lane
    Willingdon
    BN22 0LH Eastbourne
    East Sussex
    United KingdomBritishDirector44348410001
    GIRVEN, Paul
    12 Miller Close
    PE29 2YN Godmanchester
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    12 Miller Close
    PE29 2YN Godmanchester
    Cambridgeshire
    BritishCompany Director94158620001
    HODGKISS, Peter
    4 The Paddock
    LE9 9NW Newbold Verdon
    Leicester
    পরিচালক
    4 The Paddock
    LE9 9NW Newbold Verdon
    Leicester
    BritishDirector75630210001
    KERSHAW, Christopher Sydney Sagar
    Centenary Way
    Salford
    M50 1RF Manchester
    Centenary House
    পরিচালক
    Centenary Way
    Salford
    M50 1RF Manchester
    Centenary House
    EnglandBritishCompany Secretary1554150010
    KERSHAW, Christopher Sydney Sagar
    The Hollies
    Oakworth
    BD22 7HL Keighley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    The Hollies
    Oakworth
    BD22 7HL Keighley
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Secretary1554150009
    KITSON, John Edward
    Poplar House
    Old Road Dunkeswick
    LS17 9HY Leeds
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Poplar House
    Old Road Dunkeswick
    LS17 9HY Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishAccountant102500730001
    LEIVERS, Richard George
    Lorraine House
    26 Cleveland Walk
    BA2 6JU Bath
    Somerset
    পরিচালক
    Lorraine House
    26 Cleveland Walk
    BA2 6JU Bath
    Somerset
    BritishDirector81602460001
    LEWORTHY, Bruce George
    Risbon 11 The Butts
    Bratton
    BA13 4SW Westbury
    Wiltshire
    পরিচালক
    Risbon 11 The Butts
    Bratton
    BA13 4SW Westbury
    Wiltshire
    United KingdomBritishDirector34546950001
    MACKENZIE, Andrew Macgregor
    Stridings 33 Hazel Grove
    Greave
    OL13 9XT Bacup
    Lancashire
    পরিচালক
    Stridings 33 Hazel Grove
    Greave
    OL13 9XT Bacup
    Lancashire
    BritishDirector38695210001
    MARTIN, Gillian Louise
    Charlotte Grove
    Beeston
    NG9 3HU Nottingham
    7
    Nottinghamshire
    Uk
    পরিচালক
    Charlotte Grove
    Beeston
    NG9 3HU Nottingham
    7
    Nottinghamshire
    Uk
    EnglandBritishDirector136083360001
    MOORE, Paul Kennedy
    6 Mount Pleasant Avenue
    Jordanstown
    BT37 0NE Newtownabbey
    County Antrim
    পরিচালক
    6 Mount Pleasant Avenue
    Jordanstown
    BT37 0NE Newtownabbey
    County Antrim
    BritishCompany Director75780510001
    NORRIS, David Lees
    46 Toller Road
    Quorn
    LE12 8AH Loughborough
    Leicestershire
    পরিচালক
    46 Toller Road
    Quorn
    LE12 8AH Loughborough
    Leicestershire
    BritishDirector28161550001
    REDMAN, John Maybin Vivian
    Frant Lodge
    52 Frant Road
    TN2 5LJ Tunbridge Wells
    Kent
    পরিচালক
    Frant Lodge
    52 Frant Road
    TN2 5LJ Tunbridge Wells
    Kent
    Great BritainBritishDirector30405900001
    STEPHEN, Stuart
    25 Cavendish Crescent South
    NG7 1ED The Park
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    25 Cavendish Crescent South
    NG7 1ED The Park
    Nottinghamshire
    BritishDirector71577410005
    WOOD, Christopher David
    Hatherleigh Little Green
    BA11 3QP Mells
    Somerset
    পরিচালক
    Hatherleigh Little Green
    BA11 3QP Mells
    Somerset
    BritishDirector17128440002
    YEWDALL, Neil Stuart
    31 St Helens Lane
    Adel
    LS16 8BR Leeds
    West Yorkshire
    পরিচালক
    31 St Helens Lane
    Adel
    LS16 8BR Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director17046770002

    PETER BLACK HEALTHCARE LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২১ জুল, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ জুল, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC (The "Security Trustee")
    ব্যবসায়
    • ২৯ জুল, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ জুন, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২১ জুল, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ জুল, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • David Ian Mewett
    ব্যবসায়
    • ২৭ জুল, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ অক্টো, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of accession to a composite guarantee and debenture dated 15TH november 2000
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ ফেব, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ফেব, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each charging company to the chargee as security trustee for the security beneficiaries (as defined) (the "security trustee") under the facility documents (as defined) and on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ ফেব, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ জুল, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Single debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ ফেব, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ ফেব, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ ফেব, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ সেপ, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ অক্টো, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from lonsdale and bartholomew limited to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings on the north west side of curzon street, netherfield, carlton gedling nottinghamshire title no nt 105652 and/or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ অক্টো, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জানু, ১৯৮০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ ফেব, ১৯৮০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £300,000 and other sums payable pursuant to the exchange over contract.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed & floating charges on l/hold factory & premises at swains park rd, overseas, nr burton-on-trent together with all buildings fixtures, fixed plant & machinery, undertaking and all propertye and assets present and future including goodwill & uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Secretary of State for Wales.
    ব্যবসায়
    • ০১ ফেব, ১৯৮০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ নভে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    PETER BLACK HEALTHCARE LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২২ জুন, ২০১৬ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ০১ আগ, ২০১৮ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Simon Blakey
    Robson Laidler Llp Fernwood House Fernwood Road
    Jesmond
    NE2 1TJ Newcastle Upon Tyne
    অভ্যাসকারী
    Robson Laidler Llp Fernwood House Fernwood Road
    Jesmond
    NE2 1TJ Newcastle Upon Tyne
    Martin Daley
    Fernwood House Fernwood Road
    Jesmond
    NE2 1TJ Newcastle Upon Tyne
    অভ্যাসকারী
    Fernwood House Fernwood Road
    Jesmond
    NE2 1TJ Newcastle Upon Tyne

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0