PETER BLACK HEALTHCARE LIMITED
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
কোম্পানির নাম | PETER BLACK HEALTHCARE LIMITED |
---|---|
কোম্পানির স্থিতি | বাতিল |
আইনি ফর্ম | প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি |
কোম্পানি নম্বর | 00931141 |
এখতিয়ার | ইংল্যান্ড/ওয়েলস |
সৃষ্টির তারিখ | |
বন্ধের তারিখ |
সংক্ষিপ্তসার
সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছে | না |
---|---|
চার্জ রয়েছে | হ্যাঁ |
দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছে | হ্যাঁ |
নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণ | না |
PETER BLACK HEALTHCARE LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?
- নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম
PETER BLACK HEALTHCARE LIMITED কোথায় অবস্থিত?
নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | Second Floor One Hood Street NE1 6JQ Newcastle Upon Tyne |
---|---|
ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | না |
PETER BLACK HEALTHCARE LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?
কোম্পানির নাম | থেকে | পর্যন্ত |
---|---|---|
ENGLISH GRAINS (HOLDINGS) LIMITED | ০১ জুন, ১৯৯৫ | ০১ জুন, ১৯৯৫ |
ENGLISH GRAINS LIMITED | ২৬ এপ্রি, ১৯৬৮ | ২৬ এপ্রি, ১৯৬৮ |
PETER BLACK HEALTHCARE LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?
শেষ হিসাব | |
---|---|
শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে | ৩১ ডিসে, ২০১৪ |
PETER BLACK HEALTHCARE LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?
তারিখ | বর্ণনা | দলিল | প্রকার | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট | 1 পৃষ্ঠা | GAZ2 | ||||||||||
সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন | 13 পৃষ্ঠা | LIQ13 | ||||||||||
২১ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি | 17 পৃষ্ঠা | LIQ03 | ||||||||||
১২ এপ্রি, ২০১৭ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Fernwood House Fernwood Road Jesmond Newcastle upon Tyne NE2 1TJ থেকে Second Floor One Hood Street Newcastle upon Tyne NE1 6JQ এ পরিবর্তন করা হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | AD01 | ||||||||||
দেউলিয়া আদালতের আদেশ Court order insolvency:court order re. Removal/replacement of liquidator | 11 পৃষ্ঠা | LIQ MISC OC | ||||||||||
স্বেচ্ছাসেবক লিকুইডেটর হিসাবে কাজ বন্ধ করার নোটিশ | 1 পৃষ্ঠা | 4.40 | ||||||||||
০৮ জুল, ২০১৬ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা , Centenary House Centenary Way, Salford, Manchester, M50 1RF থেকে Saxon House Saxon Way Cheltenham Gloucestershire GL52 6QX এ পরিবর্তন করা হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | AD01 | ||||||||||
স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ | 1 পৃষ্ঠা | 600 | ||||||||||
রেজুলেশনগুলি Resolutions | 1 পৃষ্ঠা | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র | 3 পৃষ্ঠা | 4.70 | ||||||||||
legacy | 1 পৃষ্ঠা | SH20 | ||||||||||
১৫ জুন, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ
| 4 পৃষ্ঠা | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 পৃষ্ঠা | CAP-SS | ||||||||||
রেজুলেশনগুলি Resolutions | 2 পৃষ্ঠা | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
২৫ নভে, ২০১৫ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ
| 4 পৃষ্ঠা | SH01 | ||||||||||
নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি | 6 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ৩১ মে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 3 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
০৪ নভে, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Ulf Stefan Brettschneider এর পদব্যবস্থা বাতিল | 2 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||
০৪ নভে, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Nicholas Andrew Cottrell-এর নিয়োগ | 3 পৃষ্ঠা | AP01 | ||||||||||
নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি | 6 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ৩১ মে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 3 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি | 12 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ৩১ মে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 3 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
৩১ মে, ২০১৩ তারিখে Mr Ulf Stefan Brettschneider-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||||||||||
৩১ মে, ২০১৩ তারিখে Robert Arthur Bacon-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||||||||||
PETER BLACK HEALTHCARE LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?
নাম | নিয়োগ করা হয়েছে | পদত্যাগের তারিখ | ভূমিকা | ঠিকানা | কোম্পানি পরিচয় | বাসস্থানের দেশ | জাতীয়তা | জন্ম তারিখ | পেশা | নম্বর |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACON, Robert Arthur | পরিচালক | Floor One Hood Street NE1 6JQ Newcastle Upon Tyne Second | United Kingdom | British | Company Director | 192986020001 | ||||
COTTRELL, Nicholas Andrew | পরিচালক | Floor One Hood Street NE1 6JQ Newcastle Upon Tyne Second | England | British | Company Director | 7316340002 | ||||
KERSHAW, Christopher Sydney Sagar | সচিব | The Hollies Oakworth BD22 7HL Keighley West Yorkshire | British | 1554150009 | ||||||
KERSHAW, Christopher Sydney Sagar | সচিব | The Hollies Oakworth BD22 7HL Keighley West Yorkshire | British | 1554150009 | ||||||
KITSON, John Edward | সচিব | Poplar House Old Road Dunkeswick LS17 9HY Leeds West Yorkshire | British | 102500730001 | ||||||
LISTER, Robert Stephen | সচিব | Briery Wood Hebers Ghyll Drive LS29 9QQ Ilkley West Yorkshire | British | 161918280001 | ||||||
ALWAY, Edwin John | পরিচালক | 42 Temple Mill Island SL7 1SQ Marlow Buckinghamshire | British | Director | 54081430001 | |||||
ARGENT, Nicholas Thompson | পরিচালক | 3 Davenham Court Church Street Davenham CW9 8NQ Northwich Cheshire | United Kingdom | British | Company Director | 42373790002 | ||||
BARTON, Robert John | পরিচালক | Sheepwalk Lane Ravenshead NG15 9FD Nottingham 35 Nottinghamshire | England | British | Director | 136554260001 | ||||
BRETTSCHNEIDER, Ulf Stefan | পরিচালক | Centenary Way Salford M50 1RF Manchester Centenary House | United Kingdom | German | Company Director | 125315710001 | ||||
BURBAGE, Andrew Samuel | পরিচালক | 34 Meadow View Rolleston On Dove DE13 9AN Burton On Trent Staffordshire | Umited Kimgdom | British | Director | 44639850002 | ||||
BUSH, Anthony Kenneth Stephen | পরিচালক | 75 St Marks Road RG9 1LP Henley On Thames Oxfordshire | British | Director | 66722090001 | |||||
CLEMENTS, Alan Gordon | পরিচালক | The Poplars 24 Blagreaves Lane DE23 1FH Littleover Derbyshire | British | Director | 5123420004 | |||||
DONE, Richard John | পরিচালক | 25 Aston Hall Drive DE72 2DD Aston On Trent Derbyshire | British | Director | 83680220001 | |||||
EVANS, Michael Ronford | পরিচালক | Field Place Huggetts Lane Willingdon BN22 0LH Eastbourne East Sussex | United Kingdom | British | Director | 44348410001 | ||||
GIRVEN, Paul | পরিচালক | 12 Miller Close PE29 2YN Godmanchester Cambridgeshire | British | Company Director | 94158620001 | |||||
HODGKISS, Peter | পরিচালক | 4 The Paddock LE9 9NW Newbold Verdon Leicester | British | Director | 75630210001 | |||||
KERSHAW, Christopher Sydney Sagar | পরিচালক | Centenary Way Salford M50 1RF Manchester Centenary House | England | British | Company Secretary | 1554150010 | ||||
KERSHAW, Christopher Sydney Sagar | পরিচালক | The Hollies Oakworth BD22 7HL Keighley West Yorkshire | England | British | Company Secretary | 1554150009 | ||||
KITSON, John Edward | পরিচালক | Poplar House Old Road Dunkeswick LS17 9HY Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | Accountant | 102500730001 | ||||
LEIVERS, Richard George | পরিচালক | Lorraine House 26 Cleveland Walk BA2 6JU Bath Somerset | British | Director | 81602460001 | |||||
LEWORTHY, Bruce George | পরিচালক | Risbon 11 The Butts Bratton BA13 4SW Westbury Wiltshire | United Kingdom | British | Director | 34546950001 | ||||
MACKENZIE, Andrew Macgregor | পরিচালক | Stridings 33 Hazel Grove Greave OL13 9XT Bacup Lancashire | British | Director | 38695210001 | |||||
MARTIN, Gillian Louise | পরিচালক | Charlotte Grove Beeston NG9 3HU Nottingham 7 Nottinghamshire Uk | England | British | Director | 136083360001 | ||||
MOORE, Paul Kennedy | পরিচালক | 6 Mount Pleasant Avenue Jordanstown BT37 0NE Newtownabbey County Antrim | British | Company Director | 75780510001 | |||||
NORRIS, David Lees | পরিচালক | 46 Toller Road Quorn LE12 8AH Loughborough Leicestershire | British | Director | 28161550001 | |||||
REDMAN, John Maybin Vivian | পরিচালক | Frant Lodge 52 Frant Road TN2 5LJ Tunbridge Wells Kent | Great Britain | British | Director | 30405900001 | ||||
STEPHEN, Stuart | পরিচালক | 25 Cavendish Crescent South NG7 1ED The Park Nottinghamshire | British | Director | 71577410005 | |||||
WOOD, Christopher David | পরিচালক | Hatherleigh Little Green BA11 3QP Mells Somerset | British | Director | 17128440002 | |||||
YEWDALL, Neil Stuart | পরিচালক | 31 St Helens Lane Adel LS16 8BR Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 17046770002 |
PETER BLACK HEALTHCARE LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?
শ্রেণীবিন্যাস | তারিখ | স্থিতি | বিস্তারিত | |
---|---|---|---|---|
Debenture | তৈরি করা হয়েছে ২১ জুল, ২০০৬ ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ জুল, ২০০৬ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from any chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Debenture | তৈরি করা হয়েছে ২১ জুল, ২০০৬ ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ জুল, ২০০৬ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Deed of accession to a composite guarantee and debenture dated 15TH november 2000 | তৈরি করা হয়েছে ১৫ ফেব, ২০০১ ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ফেব, ২০০১ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All present and future obligations and liabilities due or to become due from each charging company to the chargee as security trustee for the security beneficiaries (as defined) (the "security trustee") under the facility documents (as defined) and on any account whatsoever | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Single debenture | তৈরি করা হয়েছে ০৫ ফেব, ১৯৮৭ ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ ফেব, ১৯৮৭ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Legal mortgage | তৈরি করা হয়েছে ২৬ সেপ, ১৯৮৫ ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ অক্টো, ১৯৮৫ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from lonsdale and bartholomew limited to the chargee | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ Land and buildings on the north west side of curzon street, netherfield, carlton gedling nottinghamshire title no nt 105652 and/or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Debenture | তৈরি করা হয়েছে ৩১ জানু, ১৯৮০ ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ ফেব, ১৯৮০ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ £300,000 and other sums payable pursuant to the exchange over contract. | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ Fixed & floating charges on l/hold factory & premises at swains park rd, overseas, nr burton-on-trent together with all buildings fixtures, fixed plant & machinery, undertaking and all propertye and assets present and future including goodwill & uncalled capital. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
|
PETER BLACK HEALTHCARE LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?
মামলা নম্বর | তারিখ | প্রকার | অভ্যাসকারী | অন্যান্য | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ |
|
তথ্য উৎস
- ইউকে কম্পানিজ হাউস
যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে। - লাইসেন্স: CC0