DAVID CONRAD (SALES) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামDAVID CONRAD (SALES) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00975554
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    DAVID CONRAD (SALES) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    DAVID CONRAD (SALES) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    DAVID CONRAD (SALES) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ জুন, ২০১৪

    DAVID CONRAD (SALES) LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    DAVID CONRAD (SALES) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    5 পৃষ্ঠা4.71

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ২০ নভে, ২০১৫ তারিখে

    LRESSP

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠা600

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    6 পৃষ্ঠা4.70

    বার্ষিক রিটার্ন ১০ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১১ জুন, ২০১৫

    ১১ জুন, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 250,000
    SH01

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    10 পৃষ্ঠাAA

    ১৯ আগ, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Scott Richard Mccabe-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৯ আগ, ২০১৪ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Sheffield United Fc Bramall Lane Sheffield Yorkshire S2 4SU থেকে Europa House 20 Esplanade Scarborough North Yorkshire YO11 2AQপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ১৯ আগ, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Malachy Brannigan এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৮ আগ, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Malachy Brannigan-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০৮ আগ, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Craig Burns এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ১০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৯ জুন, ২০১৪

    ১৯ জুন, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 250,000
    SH01

    পরিচালক হিসাবে Esplanade Director Limited-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP02

    সচিব হিসাবে Craig Burns এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    সচিব হিসাবে Esplanade Secretarial Services Limited-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP04

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১০ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ জুন, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Mr Craig Burns-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Julian Winter এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ১০ জুন, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ জুন, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    সচিব হিসাবে Craig Burns-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    DAVID CONRAD (SALES) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    ESPLANADE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর6133270
    123430250001
    MCCABE, Scott Richard
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish151895310001
    ESPLANADE DIRECTOR LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    কর্পোরেট পরিচালক
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর6133267
    123430390001
    BURNS, Craig
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    সচিব
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    167993930001
    CAPPER, Simon
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    সচিব
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    British118147580002
    FENOUGHTY, Mark Thomas
    108 Totley Brook Road
    S17 3QU Sheffield
    South Yorkshire
    সচিব
    108 Totley Brook Road
    S17 3QU Sheffield
    South Yorkshire
    British91397360003
    HARROP, David
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    সচিব
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    153054090001
    LIGHTBURN, Trevor
    75 Grosvenor Avenue
    Hartford
    CW8 1RP Northwich
    Cheshire
    সচিব
    75 Grosvenor Avenue
    Hartford
    CW8 1RP Northwich
    Cheshire
    British27731500001
    MANNING, Michael Atkinson
    67 Postern Close
    YO23 1JF York
    North Yorkshire
    সচিব
    67 Postern Close
    YO23 1JF York
    North Yorkshire
    British20393860001
    WHETTON, Barry Newton
    The Stables
    179 Woodford Road
    SK7 1QE Bramhall
    Stockport
    সচিব
    The Stables
    179 Woodford Road
    SK7 1QE Bramhall
    Stockport
    British14277000002
    BAMFORD, Alan Maxwell
    53 Vicarage Lane
    Dore
    S17 3GY Sheffield
    South Yorkshire
    পরিচালক
    53 Vicarage Lane
    Dore
    S17 3GY Sheffield
    South Yorkshire
    British82114720001
    BARNETT, Joel, The Right Honourable Lord Barnett
    7 Hillingdon Road
    Whitefield
    M45 7QQ Manchester
    Lancashire
    পরিচালক
    7 Hillingdon Road
    Whitefield
    M45 7QQ Manchester
    Lancashire
    United KingdomBritish2883500001
    BIRCH, Trevor
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    Bramall Lane
    South Yorkshire
    পরিচালক
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    Bramall Lane
    South Yorkshire
    UkBritish160667800001
    BRANNIGAN, Malachy
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    পরিচালক
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    EnglandIrish110939170001
    BURNS, Craig
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    পরিচালক
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    EnglandBritish167991320001
    CAPPER, David
    5 Wychwood Glen
    Sothall
    S20 2QL Sheffield
    পরিচালক
    5 Wychwood Glen
    Sothall
    S20 2QL Sheffield
    British61833820001
    CAPPER, Simon
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    পরিচালক
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    United KingdomBritish118147580002
    EDELSON, John Michael
    17 Carrwood
    WA15 0ED Hale Barns
    Cheshire
    পরিচালক
    17 Carrwood
    WA15 0ED Hale Barns
    Cheshire
    EnglandBritish28353840001
    FENOUGHTY, Mark Thomas
    108 Totley Brook Road
    S17 3QU Sheffield
    South Yorkshire
    পরিচালক
    108 Totley Brook Road
    S17 3QU Sheffield
    South Yorkshire
    British91397360003
    GREEN, Charles Alexander
    Oak Tree Farm
    Blankney Barff
    LN4 3BJ Wetheringham
    Lincolnshire
    পরিচালক
    Oak Tree Farm
    Blankney Barff
    LN4 3BJ Wetheringham
    Lincolnshire
    British75952680002
    HARROP, David Anthony
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    পরিচালক
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    EnglandBritish160187290001
    HAWTHORNE, Philip
    11 Avondale Road
    Swinley
    WN1 2BE Wigan
    Lancashire
    পরিচালক
    11 Avondale Road
    Swinley
    WN1 2BE Wigan
    Lancashire
    British79740350001
    LYONS, Jonathan Howard
    The Gables
    Rossmill Lane
    WA15 0AH Altrincham
    Cheshire
    পরিচালক
    The Gables
    Rossmill Lane
    WA15 0AH Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish12396450001
    MANNING, Michael Atkinson
    67 Postern Close
    YO23 1JF York
    North Yorkshire
    পরিচালক
    67 Postern Close
    YO23 1JF York
    North Yorkshire
    British20393860001
    MANNING, Michael Atkinson
    67 Postern Close
    YO23 1JF York
    North Yorkshire
    পরিচালক
    67 Postern Close
    YO23 1JF York
    North Yorkshire
    British20393860001
    MCDONALD, Anthony Michael
    Glenwood Cottage 25 Andrew Lane
    High Lane
    SK6 8HX Stockport
    Cheshire
    পরিচালক
    Glenwood Cottage 25 Andrew Lane
    High Lane
    SK6 8HX Stockport
    Cheshire
    British51141710003
    ROBINSON, Terence James
    The Long Barn
    Hollymount Lane, Greenmount
    BL8 4HP Bury
    Lancashire
    পরিচালক
    The Long Barn
    Hollymount Lane, Greenmount
    BL8 4HP Bury
    Lancashire
    EnglandBritish107314140001
    ROCKETT, Jason
    Bramall Lane
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    পরিচালক
    Bramall Lane
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    United KingdomBritish111427410006
    THURMAN, John Lythall
    Rosebank 8 Moor Lane
    Kirk Langley
    DE6 4LQ Ashbourne
    Derbyshire
    পরিচালক
    Rosebank 8 Moor Lane
    Kirk Langley
    DE6 4LQ Ashbourne
    Derbyshire
    British41580370003
    TOWNSEND, Ian
    Homelands
    Upper Dunsforth
    YO26 9RU Great Ouseburn York
    পরিচালক
    Homelands
    Upper Dunsforth
    YO26 9RU Great Ouseburn York
    United KingdomBritish26617400002
    WHETTON, Barry Newton
    The Stables
    179 Woodford Road
    SK7 1QE Bramhall
    Stockport
    পরিচালক
    The Stables
    179 Woodford Road
    SK7 1QE Bramhall
    Stockport
    British14277000002
    WINTER, Julian
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    পরিচালক
    Sheffield United Fc
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Yorkshire
    EnglandBritish163637880001
    WOOD, Peter Philip
    Flat 45 Whinfell Court
    Eccleshall Road
    S11 9QA Sheffield
    South Yorkshire
    পরিচালক
    Flat 45 Whinfell Court
    Eccleshall Road
    S11 9QA Sheffield
    South Yorkshire
    British59507480001

    DAVID CONRAD (SALES) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ জুল, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ জুল, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ জুল, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ জুল, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ জুন, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ জুন, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Argent Credit Corporation PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ জুন, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জুল, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Group cross guarantee industry and debenture.
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ ডিসে, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জানু, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited.
    ব্যবসায়
    • ০৪ জানু, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৯ ফেব, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Single debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ জুল, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ আগ, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ আগ, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৫ জুন, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ১১ ডিসে, ১৯৮১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ ডিসে, ১৯৮১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A fixed charge over all book & other debts and fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts except above uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ ডিসে, ১৯৮১একটি চার্জের নিবন্ধন

    DAVID CONRAD (SALES) LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২০ নভে, ২০১৫ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ১৭ আগ, ২০১৬ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Emma Cray
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    অভ্যাসকারী
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    অভ্যাসকারী
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0