KELNIGAL GROUP LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামKELNIGAL GROUP LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00979170
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    KELNIGAL GROUP LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    KELNIGAL GROUP LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    200 Great Dover Street
    SE1 4YB London
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    KELNIGAL GROUP LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    HIGH-POINT RENDEL GROUP LIMITED২৬ ফেব, ২০০৭২৬ ফেব, ২০০৭
    HIGH-POINT RENDEL GROUP PLC১৪ জানু, ১৯৯৮১৪ জানু, ১৯৯৮
    HIGH-POINT PLC০৬ অক্টো, ১৯৮৮০৬ অক্টো, ১৯৮৮
    HIGH-POINT SERVICES GROUP PLC৩১ ডিসে, ১৯৭৭৩১ ডিসে, ১৯৭৭
    HIGH-POINT CONTRACT SERVICES LIMITED০৮ মে, ১৯৭০০৮ মে, ১৯৭০

    KELNIGAL GROUP LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১৫

    KELNIGAL GROUP LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    ০৯ জানু, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    7 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩১ মার্চ, ২০১৬ থেকে ৩০ সেপ, ২০১৬ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    ০৬ জুল, ২০১৬ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 61 Southwark Street London SE1 1SA থেকে 200 Great Dover Street London SE1 4YBপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৯ জানু, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ১২ জানু, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 0.01
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Share premium account reduced. Approval & authorisation of reduction 07/12/2015
    RES13

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    16 পৃষ্ঠাAA

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed high-point rendel group LIMITED\certificate issued on 04/08/15
    2 পৃষ্ঠাCERTNM
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ০২ জুল, ২০১৫

    RES15

    নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাCONNOT

    চার্জ 009791700014 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    6 পৃষ্ঠাMR04

    বার্ষিক রিটার্ন ০৯ জানু, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১২ জানু, ২০১৫

    ১২ জানু, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 274,249.12
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    অডিটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাAUD

    পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর সংক্ষিপ্ত ১৯ এপ্রি, ২০১৪ থেকে ৩১ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    পূর্ণ হিসাব ১৯ এপ্রি, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    16 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৫ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৬ ডিসে, ২০১৩

    ০৬ ডিসে, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 274,249.12
    SH01

    পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর সংক্ষিপ্ত ৩১ জুল, ২০১৩ থেকে ১৯ এপ্রি, ২০১৩ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    চার্জ 13 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ নিবন্ধন 009791700014

    191 পৃষ্ঠাMR01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ জুল, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    16 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৫ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    KELNIGAL GROUP LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    PARSONS, Charlotte Louise
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    সচিব
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    Other135626530001
    BELL, Nigel Stuart
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    পরিচালক
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    United KingdomBritishDirector91913690001
    HINGLEY, Kelvin William Thomas
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    পরিচালক
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    United KingdomBritishManagement Consultant50467220002
    PARSONS, Charlotte Louise
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    পরিচালক
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    United KingdomBritishFinance Director140414820004
    BEST, John David
    Milbanke 43 Lady Byron Lane
    Knowle
    B93 9AX Solihull
    West Midlands
    সচিব
    Milbanke 43 Lady Byron Lane
    Knowle
    B93 9AX Solihull
    West Midlands
    British2810080001
    DAVISON, Suzanne
    106a Coppermill Lane
    Walthamstow
    E17 7HE London
    সচিব
    106a Coppermill Lane
    Walthamstow
    E17 7HE London
    British80856470001
    DESMOND, Pat
    7 Regents Drive
    BR2 6BU Keston
    Kent
    সচিব
    7 Regents Drive
    BR2 6BU Keston
    Kent
    BritishAccountant52839700001
    DIXON, Leslie Albert
    167 St Bernards Road
    B92 7DH Solihull
    West Midlands
    সচিব
    167 St Bernards Road
    B92 7DH Solihull
    West Midlands
    British3640870001
    FINDLAY, Ian Scott
    4 The Cobbles
    Off Priory Walk
    B72 1XE Sutton Coldfield
    West Midlands
    সচিব
    4 The Cobbles
    Off Priory Walk
    B72 1XE Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishChartered Accountant54138670001
    FINDLAY, Ian Scott
    4 The Cobbles
    Off Priory Walk
    B72 1XE Sutton Coldfield
    West Midlands
    সচিব
    4 The Cobbles
    Off Priory Walk
    B72 1XE Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishChartered Accountant54138670001
    GREENWOOD, Stephen Harold
    45 New Concordia Wharf
    Mill Street
    SE1 2BB London
    সচিব
    45 New Concordia Wharf
    Mill Street
    SE1 2BB London
    BritishChartered Accountant71052650001
    GREENWOOD, Stephen Harold
    45 New Concordia Wharf
    Mill Street
    SE1 2BB London
    সচিব
    45 New Concordia Wharf
    Mill Street
    SE1 2BB London
    BritishChartered Accountant71052650001
    TRENDELL, William Anthony
    Victorian Rendezvous
    18 Rectory Close Merrow
    GU4 7AR Guildford
    Surrey
    সচিব
    Victorian Rendezvous
    18 Rectory Close Merrow
    GU4 7AR Guildford
    Surrey
    BritishFinance Director12317760001
    BENNETT, Melvin Eugene
    2016 Bulrush Lane
    Cardiff By The Sea
    FOREIGN San Diego Ca 92007 Usa
    পরিচালক
    2016 Bulrush Lane
    Cardiff By The Sea
    FOREIGN San Diego Ca 92007 Usa
    AmericanManagement Consultant43502520002
    DESMOND, Pat
    7 Regents Drive
    BR2 6BU Keston
    Kent
    পরিচালক
    7 Regents Drive
    BR2 6BU Keston
    Kent
    BritishAccountant52839700001
    DIXON, Leslie Albert
    167 St Bernards Road
    B92 7DH Solihull
    West Midlands
    পরিচালক
    167 St Bernards Road
    B92 7DH Solihull
    West Midlands
    BritishChartered Accountant3640870001
    FINDLAY, Ian Scott
    4 The Cobbles
    Off Priory Walk
    B72 1XE Sutton Coldfield
    West Midlands
    পরিচালক
    4 The Cobbles
    Off Priory Walk
    B72 1XE Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishChartered Accountant54138670001
    GREENWOOD, Stephen Harold
    45 New Concordia Wharf
    Mill Street
    SE1 2BB London
    পরিচালক
    45 New Concordia Wharf
    Mill Street
    SE1 2BB London
    BritishChartered Accountant71052650001
    HOOKWAY, David Wilfred
    68 Hartley Old Road
    CR8 4HJ Purley
    Surrey
    পরিচালক
    68 Hartley Old Road
    CR8 4HJ Purley
    Surrey
    BritishEngineer374710001
    JOHNSON, Peter
    54 Mymms Drive
    Brookmans Park
    AL9 7AF Hatfield
    Hertfordshire
    পরিচালক
    54 Mymms Drive
    Brookmans Park
    AL9 7AF Hatfield
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant11342310001
    PALMER, Horace Anthony
    Fairfield London Road
    Sunninghill
    SL5 0PH Ascot
    Berkshire
    পরিচালক
    Fairfield London Road
    Sunninghill
    SL5 0PH Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director45646020002
    PERREY, Derek Randall
    Oaklands Rockbear Hill
    Marsh Green
    EX5 2EZ Exeter
    পরিচালক
    Oaklands Rockbear Hill
    Marsh Green
    EX5 2EZ Exeter
    BritishDirector12614160001
    REEVES, Ian William
    Hewletts Mill
    Galhampton
    BA22 7BG Yeovil
    Somerset
    পরিচালক
    Hewletts Mill
    Galhampton
    BA22 7BG Yeovil
    Somerset
    BritishEngineer71881990001
    REEVES, Ian William
    Hewletts Mill
    Galhampton
    BA22 7BG Yeovil
    Somerset
    পরিচালক
    Hewletts Mill
    Galhampton
    BA22 7BG Yeovil
    Somerset
    BritishConsultant71881990001
    SHEPPARD, Allen John George, The Right Honourable Lord
    Didgmere Hall Low Hill Road
    Roydon
    CM19 5JN Harlow
    Essex
    পরিচালক
    Didgmere Hall Low Hill Road
    Roydon
    CM19 5JN Harlow
    Essex
    Great BritainBritishAccountant66789210001
    SMITH, Martin Christopher Geoffrey
    9 Finlarigg Drive
    Edgbaston
    B15 3RH Birmingham
    West Midlands
    পরিচালক
    9 Finlarigg Drive
    Edgbaston
    B15 3RH Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritishManagement Consultant71281420001
    STUBBS, Robert John
    40 Tolmers Road
    Cuffley
    EN6 4JF Potters Bar
    Hertfordshire
    পরিচালক
    40 Tolmers Road
    Cuffley
    EN6 4JF Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCo Director40694340001
    TREE, David George
    East Wickham 59 College Lane
    Hurstpierpoint
    BN6 9AD Hassocks
    West Sussex
    পরিচালক
    East Wickham 59 College Lane
    Hurstpierpoint
    BN6 9AD Hassocks
    West Sussex
    BritishStockbroker64855130001
    TRENDELL, William Anthony
    Victorian Rendezvous
    18 Rectory Close Merrow
    GU4 7AR Guildford
    Surrey
    পরিচালক
    Victorian Rendezvous
    18 Rectory Close Merrow
    GU4 7AR Guildford
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director12317760001
    WHARTON, Robert Victor
    Seven Clare Drive
    Edgbaston
    B15 3LP Birmingham
    West Midlands
    পরিচালক
    Seven Clare Drive
    Edgbaston
    B15 3LP Birmingham
    West Midlands
    United KingdomBritishConsultant3640880001

    KELNIGAL GROUP LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Mr Kelvin William Thomas Hingley
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    না
    জাতীয়তা: British
    বাসস্থানের দেশ: United Kingdom
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ২৫% এর বেশি কিন্তু ৫০% এর বেশি নয় শেয়ারের মালিকানাধীন।
    Mr Nigel Stuart Bell
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    না
    জাতীয়তা: British
    বাসস্থানের দেশ: United Kingdom
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ২৫% এর বেশি কিন্তু ৫০% এর বেশি নয় শেয়ারের মালিকানাধীন।

    KELNIGAL GROUP LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ এপ্রি, ২০১৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ মে, ২০১৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Trade mark: hp-high point. Class: 16. registration number: 1074975. notification of addition to or amendment of charge.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • 20-20 Trustees Limited
    • Bridge Trustees Limited
    ব্যবসায়
    • ১০ মে, ২০১৩একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ২৪ জুল, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ মে, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জুন, ২০১০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ জুন, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ২৭ জুন, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ জুল, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ জুল, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Arab National Bank
    ব্যবসায়
    • ২৭ জুল, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ মে, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Guarantee and debenture by the company and high-point rendel limited, high-point europe limited, vantagepoint management consultants (public sector) limited
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ জুল, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ জুল, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ জুল, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ মার্চ, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ ফেব, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ ফেব, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Book debts and all the goodwill of the business. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ১৭ ফেব, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ মার্চ, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of assignment
    তৈরি করা হয়েছে ১০ জুন, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ জুন, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and under the terms of the facility agreement being the master facilities agreement dated 9 june 1997 (as therein defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The agreement being the placing and offer agreement dated 10/6/97 relating to a placing and open offer of ordinary shares of 1P each in high-point PLC and the benefit of the same and assigns all right title and interest in and to all moneys owing under the agreement. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ জুন, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ মার্চ, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ অক্টো, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ অক্টো, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ অক্টো, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ মার্চ, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ জুন, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ জুন, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ জুন, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ মার্চ, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ ডিসে, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ জানু, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    No 11 amen lodge ave. Maria lane l/b or the city of london t/no - lgl 427936.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ জানু, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ মার্চ, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ ডিসে, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ জানু, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The penthouse, amen lodge ave, maria lane l/borne city of london t/no-ngl 137194.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ জানু, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ মার্চ, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জানু, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ ফেব, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property situate and known as the penthouse amen lodge, warwick lane london EC4 title no ngl 137194 and flat 11 amen lodge warwick lane london EC4 title no ngl 427936 together with all buildings, trade and other fixtures, fixed plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • City Bank N.A.
    ব্যবসায়
    • ০৬ ফেব, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২০ জানু, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ জুল, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ জুল, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ জুল, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ অক্টো, ১৯৮০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ অক্টো, ১৯৮০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/Hold 6TH & part 7TH floor of king edward house, new st. Birmingham B2 4QW. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ অক্টো, ১৯৮০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৯ জুল, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১১ আগ, ১৯৮০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ আগ, ১৯৮০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    2A highfield road, dartford kent, title no k 464228. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ আগ, ১৯৮০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৯ জুল, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0