CONTACTA SERVICES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCONTACTA SERVICES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00979640
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    CONTACTA SERVICES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম উত্পাদন (27900) / উৎপাদন
    • অন্যান্য উৎপাদন (বিস্তারিত নির্দিষ্ট নয়) (32990) / উৎপাদন

    CONTACTA SERVICES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Recovery House 15-17 Roebuck Road
    Hainault Business Park
    IG6 3TU Ilford
    Essex
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    CONTACTA SERVICES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    CONTACTA LIMITED১৫ নভে, ১৯৯৯১৫ নভে, ১৯৯৯
    CONTACTA COMMUNICATION SYSTEMS LIMITED১৪ মে, ১৯৭০১৪ মে, ১৯৭০

    CONTACTA SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১১

    CONTACTA SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    CONTACTA SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    8 পৃষ্ঠা4.72
    A38XHELL

    ১১ সেপ, ২০১৩ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    8 পৃষ্ঠা4.68
    A2IAIBXS

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাF10.2
    A1LUPM7N

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01
    A1HHQZV7

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ 4.19

    7 পৃষ্ঠা4.20
    A1HHQZUZ

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600
    A1HHQZUI

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য অসামান্য রেজোলিউশন

    LRESEX

    ছোট কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA
    A16QFAO3

    পরিচালক হিসাবে Mohammad Almassi এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01
    A0ORB29T

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ অক্টো, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    8 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৮ নভে, ২০১১

    ২৮ নভে, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 5,000
    SH01
    XGIGXZMT

    ০১ নভে, ২০১১ তারিখে Louise Pamphilon-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01
    XGIGWZMS

    ছোট কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA
    AZZB9VD0

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ অক্টো, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    9 পৃষ্ঠাAR01
    XZC83P6E

    ০১ অক্টো, ২০১০ তারিখে Mr Mohammad Nasser Almassi-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01
    XZC82P6D

    ছোট কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA
    AGEEZN04

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed contacta LIMITED\certificate issued on 13/05/10
    2 পৃষ্ঠাCERTNM
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name১৩ মে, ২০১০

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ২৬ এপ্রি, ২০১০

    RES15
    RUFCRJI4

    নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাCONNOT
    A8ENCJIW

    অডিটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাAUD
    A5NXIF73

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ অক্টো, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    X3VSGF3L

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Mrs Catherine Lesley Thomas-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01
    X3VSEF3J

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Mr Simon Thomas-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01
    X3VSFF3K

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Louise Pamphilon-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01
    X3VSCF3H

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Andrew Thomas-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01
    X3VSDF3I

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Mohammad Nasser Almassi-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01
    X3VSBF3G

    CONTACTA SERVICES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    THOMAS, Catherine Lesley
    Lydgate House 229 Well Street
    ME19 6JW East Malling
    Kent
    সচিব
    Lydgate House 229 Well Street
    ME19 6JW East Malling
    Kent
    British21689230002
    PAMPHILON, Louise
    Kendal Meadow
    Chestfield
    CT5 3PZ Whitstable
    14
    Kent
    England
    পরিচালক
    Kendal Meadow
    Chestfield
    CT5 3PZ Whitstable
    14
    Kent
    England
    EnglandBritishCommercial Director137484340002
    THOMAS, Andrew
    Merredene
    Cranbrook Road
    TN17 1DX Goudhurst
    Kent
    পরিচালক
    Merredene
    Cranbrook Road
    TN17 1DX Goudhurst
    Kent
    United KingdomBritishSales Director151604320001
    THOMAS, Catherine Lesley
    Lydgate House 229 Well Street
    ME19 6JW East Malling
    Kent
    পরিচালক
    Lydgate House 229 Well Street
    ME19 6JW East Malling
    Kent
    EnglandBritishSecretary21689230002
    THOMAS, Simon
    Lydgate House
    229 Well Street
    ME19 6JW East Malling
    Kent
    পরিচালক
    Lydgate House
    229 Well Street
    ME19 6JW East Malling
    Kent
    EnglandBritishCompany Director43323060005
    ALMASSI, Mohammad Nasser
    South View Road
    TN5 6TN Wadhurst
    Foxgloves
    East Sussex
    England
    পরিচালক
    South View Road
    TN5 6TN Wadhurst
    Foxgloves
    East Sussex
    England
    EnglandBritishDirector106562460001
    CLEMENT, Alastair Denver
    Home Farmhouse Squerryes
    TN16 1SL Westerham
    Kent
    পরিচালক
    Home Farmhouse Squerryes
    TN16 1SL Westerham
    Kent
    United KingdomBritishCo Director Accountant33935960002
    GUNN, Christopher Simon
    The Old Rectory
    Denton
    CT4 6QZ Canterbury
    Kent
    পরিচালক
    The Old Rectory
    Denton
    CT4 6QZ Canterbury
    Kent
    BritishChartered Accountant78797710001

    CONTACTA SERVICES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ সেপ, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ অক্টো, ২০০৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All interest from time to time standing to the credit of an interest bearing account where the deposit balance as that term is defined in the rent deposit deed see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Kings Hill Trustee No.1 Limited & Kings Hill Trustee No.2 Limited & Both as Trustees of the Kings Hill Unit Trust
    ব্যবসায়
    • ০৬ অক্টো, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জানু, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ ফেব, ২০০৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Sme Invoice Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ০২ ফেব, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২১ এপ্রি, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ এপ্রি, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £24,215.58 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The sum of £24,215.58 or a higher sum being the equivalent of three months' yearly rent as defined in the lease.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Rouse Kent (Central) Limited
    ব্যবসায়
    • ২৪ এপ্রি, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ ফেব, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ মার্চ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ মার্চ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ এপ্রি, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ ডিসে, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ ডিসে, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £140,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Imex house vip trading estate. Hope & anchor lane, london S.E.7.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Eagle Star Insurance Company Limited
    ব্যবসায়
    • ২৪ ডিসে, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ আগ, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ মার্চ, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ মার্চ, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Imex house, v t p trading estate, anchor and hope lane, charlton SE 7 7TE.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ মার্চ, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ মার্চ, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ মার্চ, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge over all book debt & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and fture including book debt (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ মার্চ, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ মার্চ, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ মার্চ, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    ব্যবসায়
    • ১৭ মার্চ, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ আগ, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    CONTACTA SERVICES LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০২ সেপ, ২০১৪ভেঙে গেছে
    ১২ সেপ, ২০১২ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Alan John Clark
    Carter Clark Recovery House
    15-17 Roebuck Road, Hainault Business Park
    IG6 3TU Ilford
    Essex
    অভ্যাসকারী
    Carter Clark Recovery House
    15-17 Roebuck Road, Hainault Business Park
    IG6 3TU Ilford
    Essex

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0