CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বিবৃতি
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00981659
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য ব্যবসা সহায়তা পরিষেবা কার্যক্রম ন.এ.সি. (82990) / প্রশাসনিক এবং সহায়ক পরিষেবা কার্যক্রম

    CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    RENTCO NATIONWIDE LIMITED০৯ জুন, ১৯৭০০৯ জুন, ১৯৭০

    CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ জুন, ২০১৬

    CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    10 পৃষ্ঠাLIQ13

    বিবিধ

    Form AD03/historic register/members
    2 পৃষ্ঠাMISC

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    5 পৃষ্ঠাLIQ01

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত পরিদর্শন স্থান Oakwood Corporate Services Limited 3rd Floor Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD03

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা Oakwood Corporate Services Limited 3rd Floor Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT এ পরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD02

    ১২ জানু, ২০১৮ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা , 3rd Floor, 1 Ashley Road, Altrincham, Cheshire, WA14 2DT থেকে 1 More London Place London SE1 2AFপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    4 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ২১ ডিসে, ২০১৭ তারিখে

    LRESSP

    ০৬ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Ge Ese Uk Limited এর বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাPSC02

    ২৮ ডিসে, ২০১৭ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তির বিবৃতির প্রত্যাহার

    2 পৃষ্ঠাPSC09

    ৩১ অক্টো, ২০১৭ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ১১ সেপ, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Joseph Preston Swithenbank এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৪ জুন, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Neil Campbell Smith এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ৩০ মার্চ, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Jonathan Lawrence John Gatt-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    ৩১ অক্টো, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    Neil Smith কে পরিচালক হিসাবে নিয়োগের জন্য দ্বিতীয় দাখিল

    6 পৃষ্ঠাRP04AP01

    ৩১ আগ, ২০১৬ তারিখে Joseph Preston Swithenbank-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ৩১ আগ, ২০১৬ তারিখে Joseph Preston Swithenbank-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ০৪ মার্চ, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Cancellation of captial redemption reserve 19/02/2016
    RES13

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর7038430
    146358090001
    GATT, Jonathan Lawrence John
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    পরিচালক
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomMaltese228824220001
    ENOCH, Simon Jocelyn
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    সচিব
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    British61314280001
    PRICE, Philip Ian
    4 Queenswood Avenue
    Hutton
    CM13 1HR Brentwood
    Essex
    সচিব
    4 Queenswood Avenue
    Hutton
    CM13 1HR Brentwood
    Essex
    British75578650002
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    কর্পোরেট সচিব
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    কর্পোরেট সচিব
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    67382580002
    TRAF SHELF (NOMINEES) LIMITED
    Trafalgar House
    29 Park Place
    LS1 2SP Leeds
    West Yorkshire
    কর্পোরেট সচিব
    Trafalgar House
    29 Park Place
    LS1 2SP Leeds
    West Yorkshire
    50087010001
    BEADLE, Paul Laurence
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    পরিচালক
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    United KingdomBritish100238650001
    CAKEBREAD, David
    The Quadrant
    Aztec West
    BS32 4GQ Bristol
    2630
    United Kingdom
    পরিচালক
    The Quadrant
    Aztec West
    BS32 4GQ Bristol
    2630
    United Kingdom
    United KingdomBritish183172770001
    CHANDLER, Andrew Philip
    66 Baywell
    Leybourne
    ME19 5QQ West Malling
    Kent
    পরিচালক
    66 Baywell
    Leybourne
    ME19 5QQ West Malling
    Kent
    British53832740001
    CITRON, Zachary Joseph
    23 Holders Hill Crescent
    NW14 1NE London
    পরিচালক
    23 Holders Hill Crescent
    NW14 1NE London
    British91783950001
    CLARK, John Robert Morton
    20 Mount Avenue
    Ealing
    W5 2RG London
    পরিচালক
    20 Mount Avenue
    Ealing
    W5 2RG London
    EnglandBritish79328330001
    CLARK, Roy Graham
    18 Rosary Gardens
    SW7 4NT London
    পরিচালক
    18 Rosary Gardens
    SW7 4NT London
    British65257100001
    CLUBB, Ian Mcmaster
    Pond House
    EN5 4PS Hadley Green
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Pond House
    EN5 4PS Hadley Green
    Hertfordshire
    British3485960001
    CROWTHER, Jonathan Michael
    11 Wheatley Rise
    LS29 8SQ Ilkley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    11 Wheatley Rise
    LS29 8SQ Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritish49068160001
    ENOCH, Simon Jocelyn
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    পরিচালক
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    EnglandBritish61314280001
    FOSTER, Roy Garvin
    Bowerbank
    36 St Marks Road
    RG9 1LW Henley On Thames
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Bowerbank
    36 St Marks Road
    RG9 1LW Henley On Thames
    Oxfordshire
    British37099790002
    FREDHOLM, James William
    76 Staveley Road
    Chiswick
    W4 3HU London
    পরিচালক
    76 Staveley Road
    Chiswick
    W4 3HU London
    American33092100001
    GOODWIN, Stephen Keith
    Tumblewood Cottage 23 Beacon Way
    SM7 1DZ Banstead
    Surrey
    পরিচালক
    Tumblewood Cottage 23 Beacon Way
    SM7 1DZ Banstead
    Surrey
    British5343520001
    GREEN, Pamela Anne
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    পরিচালক
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    British38435990009
    HOWELL, David
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    পরিচালক
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish109591300001
    MONTAGUE, Robert Joel
    Pusey House
    SN7 8QB Pusey
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Pusey House
    SN7 8QB Pusey
    Oxfordshire
    British65130630002
    OSBORNE, Richard Wallace Gollin Osborne
    5 Northfield Wall
    59 North Road Highgate
    N6 London
    পরিচালক
    5 Northfield Wall
    59 North Road Highgate
    N6 London
    Australian17452320001
    RAINE, Richard Denby
    1 Acris Street
    SW18 2QT London
    পরিচালক
    1 Acris Street
    SW18 2QT London
    British50519950001
    RIEDIJK, Hans Arie
    Trompenburo Straat 10m
    1079 TX Amsterdam
    The Netherlands
    পরিচালক
    Trompenburo Straat 10m
    1079 TX Amsterdam
    The Netherlands
    Dutch57483360001
    SMITH, Neil Campbell
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    পরিচালক
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish183029170001
    SMITS, Robert Anthony
    Heemraadschapslaan 2
    1181 Vb
    Amstelveen
    পরিচালক
    Heemraadschapslaan 2
    1181 Vb
    Amstelveen
    Dutch54592350001
    STONE, Richard
    6 Birchways
    WA4 5DQ Appleton
    Cheshire
    পরিচালক
    6 Birchways
    WA4 5DQ Appleton
    Cheshire
    British75179060001
    SWITHENBANK, Joseph Preston
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    পরিচালক
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomUs Citizen183236480004
    T I P EUROPE LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    কর্পোরেট পরিচালক
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    65164760003

    CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    না
    আইনি ফর্মLimited By Shares
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষUnited Kingdom (England)
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর1329406
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিদের বিষয়ে সর্বশেষ বিবৃতিগুলি কী কী?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বিবৃতি
    জানানো হয়েছেবন্ধ হয়েছেবিবৃতি
    ৩১ অক্টো, ২০১৬০১ ডিসে, ২০১৭কোম্পানি এখনও কোম্পানির সাথে সম্পর্কিত একজন নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি বা একটি নিবন্ধনযোগ্য প্রাসঙ্গিক আইনি সত্তা আছে কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপগুলি সম্পূর্ণ করেনি

    CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ জুল, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ জুল, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under, or pursuant to the credit agreement, the indenture, the notes, the company's bank guarantee, the company's noteholder guarantee, the new asset financing guarantees and the other secured documents
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.as Security Trustee for the Secured Parties
    ব্যবসায়
    • ৩০ জুল, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ মে, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ আগ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ সেপ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the lease agreement dated 29TH december 1989 (as defined),as amended by supplemental agreements dated 31ST december 1991 and 14TH august 1995
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The trailers as described in the attached schedule with all accessories,components,parts......etc. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Trinity (Jersey) Limited
    ব্যবসায়
    • ০১ সেপ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ মে, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মার্চ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ মার্চ, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties (as defined therein) or the banks (as defined in the credit agreement dated 13TH february 1994) on any account whatsoever under the terms of the said credit agreement and a guarantee dated 15TH march 1994 and the other documents relating thereto (each as defined in the credit agreement)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    ব্যবসায়
    • ২১ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ জুল, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ সেপ, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ অক্টো, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the first agreements of various dates
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the company's right title & interest in the monies then or thereafterpayable to the company by the sub-leases pursuant to the terms of the sub-lease agreements.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Mdfc Industrial Finance Limtied.
    ব্যবসায়
    • ১৯ অক্টো, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২২ জুন, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ২১ জুল, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ আগ, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the company's right title and interest in the monies payable to the company by the sub-lessees pursuant to the sub lease agreements (see form 395 for full details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Svenska Finans (UK) Limited.
    ব্যবসায়
    • ১১ আগ, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৯ জুল, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ জুন, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ জুল, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or by virtue of the first agreements and under the terms of the c harge.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the company's right title and interest in the monies payable to the company by the sub-lessees pursuant to the sublease agreements (see form 395 for full details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ball Leasing Limited.
    ব্যবসায়
    • ১৮ জুল, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২২ জুন, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ মার্চ, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ এপ্রি, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Unit 3 badminton court church street amersham buckinghamshire title no. Bm 86544.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ এপ্রি, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২২ জুন, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ফেব, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ ফেব, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms or by virtue of all conditional sale, hire purchase leas ing and/or bailment contracts under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the company's rights title and interest in and to all agreements entered into or to be entered into by the company with third parties (see form 395 for full details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Security Pacific Eurofinance Inc
    ব্যবসায়
    • ২৫ ফেব, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২২ জুন, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ফেব, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ ফেব, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the security documents of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Floating charge all its undertaking and all property and assets present and future.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Security Pacific Eurofinance, Inc.
    ব্যবসায়
    • ২৫ ফেব, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৭ অক্টো, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ডিসে, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ জানু, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of any agreement and under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any agreement entered into whether before on or after the date hereof b etween the company and a person to whom the company lets or agrees to let goods. (For full details see form 395).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Mortgage Leasing Limited
    ব্যবসায়
    • ১২ জানু, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২২ জুন, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২১ ডিসে, ২০১৭ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ১০ এপ্রি, ২০১৯ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    অভ্যাসকারী
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    অভ্যাসকারী
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0