G & A E SLINGSBY LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামG & A E SLINGSBY LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00982921
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    G & A E SLINGSBY LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7499) /

    G & A E SLINGSBY LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    G & A E SLINGSBY LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    NEOLITH LIMITED০১ ডিসে, ১৯৮৯০১ ডিসে, ১৯৮৯
    NEOLITH CHEMICALS LIMITED২৪ জুন, ১৯৭০২৪ জুন, ১৯৭০

    G & A E SLINGSBY LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ জুল, ২০০৯

    G & A E SLINGSBY LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ০৮ সেপ, ২০১০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    3 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Share premium & undistributable reserves cancelled 31/08/2010
    RES13

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ জুন, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    একজন পরিচালকের পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Mr Robert Andrew Ross Smith-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Stephen Webster-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Alison Drew-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    হিসাব ৩১ জুল, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    হিসাব ৩১ জুল, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    হিসাব ৩১ জুল, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    5 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    হিসাব ৩১ জুল, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    2 পৃষ্ঠা363a

    হিসাব ৩১ জুল, ২০০৫ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    G & A E SLINGSBY LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    DREW, Alison
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    সচিব
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    British86845230002
    SMITH, Robert Andrew Ross
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4GA Reading
    Parkview 1220
    United Kingdom
    পরিচালক
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4GA Reading
    Parkview 1220
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant150753930001
    WEBSTER, Stephen Paul
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    পরিচালক
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    United KingdomBritishCompany Director40201730005
    WOLSELEY DIRECTORS LIMITED
    Parkview 1220
    Arlington Business Park, Theale
    RG7 4GA Reading
    কর্পোরেট পরিচালক
    Parkview 1220
    Arlington Business Park, Theale
    RG7 4GA Reading
    122185200001
    MORRIS, Anthony Charles
    42 Walnut Way
    Hyde Heath
    HP6 5SD Amersham
    Buckinghamshire
    সচিব
    42 Walnut Way
    Hyde Heath
    HP6 5SD Amersham
    Buckinghamshire
    British28467660001
    PARKER, Edward Geoffrey
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    সচিব
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    BritishChartered Secretary37378570013
    SMITH, Brian Frederick
    Leawood
    Bell Lane Broadheath
    WR15 8QX Tenbury Wells
    Worcestershire
    সচিব
    Leawood
    Bell Lane Broadheath
    WR15 8QX Tenbury Wells
    Worcestershire
    British6030670001
    WHITE, Mark Jonathan
    38 Grange Close
    Church Road Nascot Wood
    WD17 4HQ Watford
    Hertfordshire
    সচিব
    38 Grange Close
    Church Road Nascot Wood
    WD17 4HQ Watford
    Hertfordshire
    British82978250001
    WOODWARD, William Edward
    19 Tideswell Close
    West Hunsbury
    NN4 9XY Northampton
    Northamptonshire
    সচিব
    19 Tideswell Close
    West Hunsbury
    NN4 9XY Northampton
    Northamptonshire
    British11797040001
    BRANSON, David Anthony
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    পরিচালক
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    BritishCompany Director/Secretary272310001
    BUCKETT, Cecil John
    Vectis House 10 Cherry Hill Drive
    Barnt Green
    B45 8JY Birmingham
    West Midlands
    পরিচালক
    Vectis House 10 Cherry Hill Drive
    Barnt Green
    B45 8JY Birmingham
    West Midlands
    BritishCompany Director690420001
    EARNSHAW, Allan
    Sandy Field 566 Newchurch Road
    Rawtenstall
    BB4 7TN Rossendale
    Lancashire
    পরিচালক
    Sandy Field 566 Newchurch Road
    Rawtenstall
    BB4 7TN Rossendale
    Lancashire
    BritishCompany Director10010090001
    HAYHURST, Kevin
    7 Heath Hill Drive
    Stacksteads
    OL13 0SG Bacup
    Lancashire
    পরিচালক
    7 Heath Hill Drive
    Stacksteads
    OL13 0SG Bacup
    Lancashire
    BritishCompany Director21410340001
    PARKER, Edward Geoffrey
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    পরিচালক
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    BritishChartered Secretary37378570013
    POOLE, Kenneth Eccles
    15 Waingap Rise
    Syke
    OL12 9TZ Rochdale
    Lancashire
    পরিচালক
    15 Waingap Rise
    Syke
    OL12 9TZ Rochdale
    Lancashire
    BritishCompany Director6505570001
    SMITH, Brian Frederick
    Leawood
    Bell Lane Broadheath
    WR15 8QX Tenbury Wells
    Worcestershire
    পরিচালক
    Leawood
    Bell Lane Broadheath
    WR15 8QX Tenbury Wells
    Worcestershire
    BritishDirector6030670001
    STANTON, Brian William
    The Moors
    Burlingham
    WR10 3AD Pershore
    Hereford & Worcester
    পরিচালক
    The Moors
    Burlingham
    WR10 3AD Pershore
    Hereford & Worcester
    BritishDirector14648180001
    WADSWORTH, Christopher Robert
    Cherry Trees
    Hinstock
    TF9 2ST Market Drayton
    Shropshire
    England
    পরিচালক
    Cherry Trees
    Hinstock
    TF9 2ST Market Drayton
    Shropshire
    England
    BritishCompany Director27227340001
    WHITE, Mark Jonathan
    Hawthorn House
    2 Wards Drive, Sarratt
    WD3 6AE Rickmansworth
    Herts
    পরিচালক
    Hawthorn House
    2 Wards Drive, Sarratt
    WD3 6AE Rickmansworth
    Herts
    EnglandBritishSolicitor82978250002
    WOODWARD, William Edward
    19 Tideswell Close
    West Hunsbury
    NN4 9XY Northampton
    Northamptonshire
    পরিচালক
    19 Tideswell Close
    West Hunsbury
    NN4 9XY Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritishCompany Secretary11797040001

    G & A E SLINGSBY LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ এপ্রি, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মে, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the goodwill,book debts and patents. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ মে, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ ফেব, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ আগ, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ আগ, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Floating charge over all the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ আগ, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ ফেব, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জুল, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ আগ, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £17000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Hydraulic equipment as listed on schedule to doc M18.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Commercial Credit Services Limited
    ব্যবসায়
    • ১০ আগ, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ নভে, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২১ নভে, ১৯৮৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ নভে, ১৯৮৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land and bldgs to the nw of the green, houghton le spring, sunderland. Title no ty 56641 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Williams & Glyns Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ নভে, ১৯৮৩একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২১ নভে, ১৯৮৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ নভে, ১৯৮৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H plot of land & bldgs erected thereon k/a unit 15 glebe farm road, rugby warwickshire title no wk 249722 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Williams & Glyns Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ নভে, ১৯৮৩একটি চার্জের নিবন্ধন
    Supplemental debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ১৯৮১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ এপ্রি, ১৯৮১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first fixed charge on all book debts & other debts both present & future.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Williams & Glyns Bank
    ব্যবসায়
    • ০৩ এপ্রি, ১৯৮১একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0