COLLEGE OF ST. MARK AND ST. JOHN FOUNDATION (THE)

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCOLLEGE OF ST. MARK AND ST. JOHN FOUNDATION (THE)
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মগ্যারান্টি ছাড়াই শেয়ার ক্যাপিটাল ছাড়াই ব্যক্তিগত সীমিত দায় কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00986239
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    COLLEGE OF ST. MARK AND ST. JOHN FOUNDATION (THE) এর উদ্দেশ্য কী?

    • প্রথম-ডিগ্রি স্তরের উচ্চ শিক্ষা (85421) / শিক্ষা

    COLLEGE OF ST. MARK AND ST. JOHN FOUNDATION (THE) কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    College Of St Mark And St John
    Derriford Road
    PL6 8BH Plymouth, Devonshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    COLLEGE OF ST. MARK AND ST. JOHN FOUNDATION (THE) এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ জুল, ২০১১

    COLLEGE OF ST. MARK AND ST. JOHN FOUNDATION (THE) এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ০১ জানু, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Thelma Olive Sorensen এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ জানু, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Alison Seabeck এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ জানু, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Nigel Rowe এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ জানু, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে John Alan Porter এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ জানু, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Christopher Lonsdale Rodham এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ জানু, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Philip Clive Mantell এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ জানু, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Margaret Kathleen Noble এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ জানু, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Bob Philbeam এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ জানু, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mark Richard Macnair এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ জানু, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Michael John Lincoln এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ জানু, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Stephen Irvine Heap এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ জানু, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Lucinda Mary George-Foster এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ জানু, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে John Frank Ford এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ জানু, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Catherine Elizabeth Edmonds এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ জানু, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে John Henry Dyer এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ জানু, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Elizabeth Barbara Dunball এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ জানু, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Benjamin John Dobson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ জানু, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Margaret Ann Cooper এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ জানু, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Ian Nigel Chandler এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ জানু, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Linda Brightman এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ জানু, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Joseph Robert Benson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ জানু, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Jonathan Barry এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    COLLEGE OF ST. MARK AND ST. JOHN FOUNDATION (THE) এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    COOK, Karen
    Adit Lane
    South Pill
    PL12 6HS Saltash
    Southern Cross
    Cornwall
    সচিব
    Adit Lane
    South Pill
    PL12 6HS Saltash
    Southern Cross
    Cornwall
    British157024240001
    THEYER, Nigel Anthony
    7 Albemarle Villas
    Stoke
    PL1 5QZ Plymouth
    Devon
    পরিচালক
    7 Albemarle Villas
    Stoke
    PL1 5QZ Plymouth
    Devon
    EnglandBritishSolicitor48292800001
    BROWN, David
    7 Middlewell Parc
    PL27 7HH Wadebridge
    Cornwall
    সচিব
    7 Middlewell Parc
    PL27 7HH Wadebridge
    Cornwall
    BritishManagement Accountant119639630001
    LEE, Barry Roy
    College Of St Mark & St John Derriford Road
    PL6 8BH Plymouth
    Devon
    সচিব
    College Of St Mark & St John Derriford Road
    PL6 8BH Plymouth
    Devon
    British20842950001
    ALAO, Abimbola
    9 Tramway Road
    PL6 7TQ Plymouth
    Devon
    পরিচালক
    9 Tramway Road
    PL6 7TQ Plymouth
    Devon
    United KingdomBritishTeacher115762780001
    ALDRIDGE, Peter John
    1 Forge Lane
    Butterleigh
    EX15 1QG Cullompton
    Devon
    পরিচালক
    1 Forge Lane
    Butterleigh
    EX15 1QG Cullompton
    Devon
    EnglishHeadmaster20843060001
    ANDERSON, John Edward
    Laurel Cottage
    Chillaton
    PL16 0HS Lifton
    Devon
    পরিচালক
    Laurel Cottage
    Chillaton
    PL16 0HS Lifton
    Devon
    BritishPrincipal College Of Higher Education35552990003
    ANSELL, Stephen
    17 Badgers Close
    PL21 9TN Ivybridge
    Devon
    পরিচালক
    17 Badgers Close
    PL21 9TN Ivybridge
    Devon
    BritishLecturer115639200001
    BAKER, David Michael
    The Oaks
    Marjon, Derriford Road
    PL6 8BH Plymouth
    Devon
    পরিচালক
    The Oaks
    Marjon, Derriford Road
    PL6 8BH Plymouth
    Devon
    BritishAcademic91932230002
    BARRY, Jonathan, Dr
    Thornton Hill
    EX4 4NS Exeter
    32
    Devon
    পরিচালক
    Thornton Hill
    EX4 4NS Exeter
    32
    Devon
    United KingdomBritishUniversity Teaching134986470001
    BENNETT, Paul
    8 Winkfield Close
    LU4 0BY Luton
    Bedfordshire
    পরিচালক
    8 Winkfield Close
    LU4 0BY Luton
    Bedfordshire
    BritishPresident Of Su54351300001
    BENSON, Joseph Robert
    Derriford Road
    PL6 8BH Plymouth
    Marjow Student Union Ucp Marjon
    Devon
    England
    পরিচালক
    Derriford Road
    PL6 8BH Plymouth
    Marjow Student Union Ucp Marjon
    Devon
    England
    United KingdomBritishPresident Of Student Union162121890001
    BLACKSELL, Andrew Mark, Dr
    Lower Hobey
    Belstone
    EX20 1QY Okehampton
    Devon
    পরিচালক
    Lower Hobey
    Belstone
    EX20 1QY Okehampton
    Devon
    BritishReader In Human Geography31483250001
    BLIGHT, Catherine Montgomery
    Parc Mead Retanning Lane
    Sticker
    PL26 7HH St Austell
    Cornwall
    পরিচালক
    Parc Mead Retanning Lane
    Sticker
    PL26 7HH St Austell
    Cornwall
    BritishNone1157010002
    BLUNT, Roy, Transport Officer
    6 Brunel Way
    PL21 0AF Ivybridge
    Devon
    পরিচালক
    6 Brunel Way
    PL21 0AF Ivybridge
    Devon
    BritishDriver20843030001
    BOON, Jason
    House 1
    College Of St Mark & St John
    PL6 8BH Plymouth
    Devon
    পরিচালক
    House 1
    College Of St Mark & St John
    PL6 8BH Plymouth
    Devon
    BritishSu President123127270001
    BOXALL, Michael Stanley
    1 Beatty Close
    Derriford
    PL6 6LJ Plymouth
    Devon
    পরিচালক
    1 Beatty Close
    Derriford
    PL6 6LJ Plymouth
    Devon
    BritishChief Executive & Town Clerk39401610001
    BRIGHTMAN, Linda
    Hillside Road
    BS20 8LQ Portishead
    110
    Somerset
    পরিচালক
    Hillside Road
    BS20 8LQ Portishead
    110
    Somerset
    United KingdomBritishRegional Director Education133968500002
    BRISTOW, David
    311 Coleridge Hall, College Of
    St Mark & St John, Derriford Road
    PL6 8BH Plymouth
    Devon
    পরিচালক
    311 Coleridge Hall, College Of
    St Mark & St John, Derriford Road
    PL6 8BH Plymouth
    Devon
    BritishSu President71533310001
    BUCHALIK, Alexander
    College St Mark & St John
    PL6 8BH Derriford Road
    Plymouth
    পরিচালক
    College St Mark & St John
    PL6 8BH Derriford Road
    Plymouth
    BritishSu President79332250001
    BUTCHER, Pauline
    38 Fore Street
    EX20 2DT North Tawton
    Devon
    পরিচালক
    38 Fore Street
    EX20 2DT North Tawton
    Devon
    BritishLecturer47422950001
    CAINE, Michael, Sir
    Croft
    Torrington Road
    EX19 8HR Winkleigh
    Devon
    পরিচালক
    Croft
    Torrington Road
    EX19 8HR Winkleigh
    Devon
    BritishChairman Booker Plc39003420002
    CHADWICK, Priscilla, Dr
    Berkhamsted Collegiate School
    Castle Street
    HP4 2BB Berkhamsted
    পরিচালক
    Berkhamsted Collegiate School
    Castle Street
    HP4 2BB Berkhamsted
    BritishSchool Principal51291820002
    CHANDLER, Ian Nigel, The Venerable
    46a Cambridge Road
    Ford
    PL2 1PU Plymouth
    St Marks House
    Devon
    পরিচালক
    46a Cambridge Road
    Ford
    PL2 1PU Plymouth
    St Marks House
    Devon
    United KingdomBritishArchdeacon Of Plymouth157090330001
    CLARK, Tobias James
    7 Erisey Terrace
    TR11 2AP Falmouth
    Cornwall
    পরিচালক
    7 Erisey Terrace
    TR11 2AP Falmouth
    Cornwall
    BritishSu President99835490001
    CLEMENTS, Francis Alexander
    11 Frensham Avenue
    Glenholt
    PL6 7JN Plymouth
    Devon
    পরিচালক
    11 Frensham Avenue
    Glenholt
    PL6 7JN Plymouth
    Devon
    United KingdomBritishLibrarian125574120001
    COCKS, Peter Bridgeman
    The Island
    Island Crescent
    TR7 1EA Newquay
    Cornwall
    পরিচালক
    The Island
    Island Crescent
    TR7 1EA Newquay
    Cornwall
    BritishRetired Solicitor37534980001
    COLEMAN, Bruce Inor, Dr
    1 Willow Walk
    EX4 6RP Exeter
    Devon
    পরিচালক
    1 Willow Walk
    EX4 6RP Exeter
    Devon
    BritishUniversity Teacher31730260001
    COLLIER, Paul Arnold
    27 Hampshire Close
    EX4 1NA Exeter
    Devon
    পরিচালক
    27 Hampshire Close
    EX4 1NA Exeter
    Devon
    BritishLecturer77509390001
    COOK, Karen Mary, Dr.
    Grassmere Way
    Pillmere
    PL12 6XD Saltash
    17
    Cornwall
    পরিচালক
    Grassmere Way
    Pillmere
    PL12 6XD Saltash
    17
    Cornwall
    United KingdomBritishAccountant125559680002
    COOPER, Margaret Ann
    Fairmead Bungalow
    Fairmead Road Burraton
    PL12 4JH Saltash
    Cornwall
    পরিচালক
    Fairmead Bungalow
    Fairmead Road Burraton
    PL12 4JH Saltash
    Cornwall
    EnglandBritishAcademic73009560002
    COUPLAND, Jon, Dr
    2 Beechfield Avenue
    PL20 6DU Yelverton
    Devon
    পরিচালক
    2 Beechfield Avenue
    PL20 6DU Yelverton
    Devon
    BritishLecturer47422780001
    DANIEL, John Sagar, Sir
    Wednesden House
    Bedford Road, Aspley Guise
    MK17 8DQ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Wednesden House
    Bedford Road, Aspley Guise
    MK17 8DQ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishUniversity Adminstrator64569790002
    DAVEY, Norman, Rev
    2 The Poplars
    EX4 9HH Exeter
    Devon
    পরিচালক
    2 The Poplars
    EX4 9HH Exeter
    Devon
    BritishClerk In Holy Orders13712190001
    DAVIDSON, Christopher John, Reverend
    14 Pridhams Way
    Exminster
    EX6 8TA Exeter
    Dveon
    পরিচালক
    14 Pridhams Way
    Exminster
    EX6 8TA Exeter
    Dveon
    BritishClerk In Holy Orders57471710001

    COLLEGE OF ST. MARK AND ST. JOHN FOUNDATION (THE) এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Fixed charge and assignment
    তৈরি করা হয়েছে ০১ ফেব, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ ফেব, ২০০৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that f/h land and buildings being the penninsula allied health centre ay the college of st mark and st john, derriford road, plymouth, t/n DN28506. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ ফেব, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ এপ্রি, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ এপ্রি, ১৯৯৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Freehold property k/a tallastone garden site derriford plymouth devon and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ এপ্রি, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জানু, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ ফেব, ১৯৯৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a land and buildings on the south east side of plymbridge lane derriford plymouth t/no;-dn 344995 (part) and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ ফেব, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ ফেব, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ ফেব, ১৯৯৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a land and buildings on the south east side of plymbridge lane derriford plymouth devon t/no DN28506 and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ ফেব, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Escrow account charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ অক্টো, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ অক্টো, ১৯৯৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the property option agreement dated 7 january 1994 or the deed of charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies to be paid into the escrow account and all debts or obligations for the payment of any such monies. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Marjon Tenancies 1 PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ অক্টো, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Escrow account charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ অক্টো, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ অক্টো, ১৯৯৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the first relevant offer (as defined) or any documents executed pursuant thereto or the deed of charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies which are paid into the escrow account and all debts or obligations for the payment of any such monies. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Cave Nominees Limited
    ব্যবসায়
    • ২৬ অক্টো, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১০ জুন, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ জুন, ১৯৮৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/Hold property known as the college of st. Mark of st. John derriford plymouth.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Whitbread and Company PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ জুন, ১৯৮৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২০ মে, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১০ নভে, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ নভে, ১৯৮২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property on the s/e side of 9 plymbridge lane, derriford plymouth devon tn dn 28506 and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ নভে, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0