HEATH INSURANCE BROKING LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামHEATH INSURANCE BROKING LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01005219
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    HEATH INSURANCE BROKING LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স (65120) / আর্থিক এবং বীমা কার্যক্রম

    HEATH INSURANCE BROKING LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    The Walbrook Building
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    HEATH INSURANCE BROKING LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    C E HEATH (INSURANCE BROKING) LIMITED২৫ এপ্রি, ১৯৮৮২৫ এপ্রি, ১৯৮৮
    C.E. HEATH & CO. (INSURANCE BROKING) LIMITED১৮ মার্চ, ১৯৭১১৮ মার্চ, ১৯৭১

    HEATH INSURANCE BROKING LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৭

    HEATH INSURANCE BROKING LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    ০৯ আগ, ২০১৮ তারিখে সচিব হিসাবে Mr Alistair Charles Peel-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    ০৯ আগ, ২০১৮ তারিখে সচিব হিসাবে William Lindsay Mcgowan এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ৩১ জানু, ২০১৮ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    ৩১ জানু, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ জানু, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০২ ফেব, ২০১৬

    ০২ ফেব, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 55
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    ০৯ ফেব, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Matthew Pike-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০৯ ফেব, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে David Christopher Ross এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ জানু, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৫ ফেব, ২০১৫

    ০৫ ফেব, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 55
    SH01

    ২৬ জানু, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mark Stephen Mugge এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ জানু, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৩ ফেব, ২০১৪

    ০৩ ফেব, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 55
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    সচিব হিসাবে Mr William Lindsay Mcgowan-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    সচিব হিসাবে Hl Corporate Services Limited এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ জানু, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    ১১ অক্টো, ২০১২ তারিখে Mr David Christopher Ross-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    HEATH INSURANCE BROKING LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    PEEL, Alistair Charles
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    সচিব
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    249410010001
    PIKE, Matthew William
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    পরিচালক
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    EnglandBritish187274510001
    MCGOWAN, William Lindsay
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    সচিব
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    180337270001
    ROWE, Nicholas
    Amberly House
    The Cleave
    OX11 0EL Harwell
    Oxfordshire
    সচিব
    Amberly House
    The Cleave
    OX11 0EL Harwell
    Oxfordshire
    British33862660001
    SHARP, Pandora
    Flat 9 Da Vinci Court
    1 Rossetti Road
    SE16 3EA London
    সচিব
    Flat 9 Da Vinci Court
    1 Rossetti Road
    SE16 3EA London
    British64972020003
    WILKINSON, Sidney James
    67 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    সচিব
    67 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    British1138390001
    WILKINSON, Sidney James
    67 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    সচিব
    67 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    British1138390001
    HL CORPORATE SERVICES LIMITED
    Houndsditch
    EC3A 7AH London
    133
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    Houndsditch
    EC3A 7AH London
    133
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর1054707
    43700080007
    BARTON, Michael Keith
    Alie Street
    E1 8DE London
    9
    পরিচালক
    Alie Street
    E1 8DE London
    9
    EnglandUnited States109126210001
    BLOOMER, William David
    Barry Road
    East Dulwich
    SE22 0JS London
    214
    পরিচালক
    Barry Road
    East Dulwich
    SE22 0JS London
    214
    United KingdomBritish72374560002
    BROADHURST, Timothy Edward
    Highfield House Main Road
    Knockholt
    TN14 7NU Sevenoaks
    Kent
    পরিচালক
    Highfield House Main Road
    Knockholt
    TN14 7NU Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish8657480001
    BRUCE, Michael Andrew
    Royston Manor St Peter's Lane
    Clayworth
    DN22 9AA Retford
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    Royston Manor St Peter's Lane
    Clayworth
    DN22 9AA Retford
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish61928170002
    BURTON, Michael John
    4a Langton Way
    SE3 7TL London
    পরিচালক
    4a Langton Way
    SE3 7TL London
    British63922600001
    COLOSSO, Adrian
    Burnham Road
    Woodham Mortimer
    CM9 6SP Maldon
    Hillside Farm
    Essex
    পরিচালক
    Burnham Road
    Woodham Mortimer
    CM9 6SP Maldon
    Hillside Farm
    Essex
    EnglandBritish4555310002
    DEXTER, Neil Edward
    1 Courtlands
    Prince Imperial Road
    BR7 5LX Chislehurst
    Kent
    পরিচালক
    1 Courtlands
    Prince Imperial Road
    BR7 5LX Chislehurst
    Kent
    EnglandBritish42053970001
    ELDRET, Kenneth George
    Broadmead
    3 Franklands Gardens
    RH15 0UJ Burgess Hill
    West Sussex
    পরিচালক
    Broadmead
    3 Franklands Gardens
    RH15 0UJ Burgess Hill
    West Sussex
    British34990880001
    FIELDING, Richard Walter
    West Hall
    Longburton
    DT9 5PF Sherborne
    Dorset
    পরিচালক
    West Hall
    Longburton
    DT9 5PF Sherborne
    Dorset
    United KingdomBritish77656210001
    HARRISON, Robert Melville
    Flint Cottage 53 Ridgway Road
    GU9 8NR Farnham
    Surrey
    পরিচালক
    Flint Cottage 53 Ridgway Road
    GU9 8NR Farnham
    Surrey
    British8722560001
    HORNER, Frank Henry Leslie
    Pettits House Mountnessing Lane
    Doddinghurst
    CM15 0SP Brentwood
    Essex
    পরিচালক
    Pettits House Mountnessing Lane
    Doddinghurst
    CM15 0SP Brentwood
    Essex
    British28353000001
    HUGHES, Michael Harold
    881 Ocean Drive
    Appartment 16 F
    USA Key Biscayne
    Florida
    পরিচালক
    881 Ocean Drive
    Appartment 16 F
    USA Key Biscayne
    Florida
    British65226980002
    HUGHES, Paul John
    96 Burnham Road
    SS9 2JS Leigh On Sea
    Essex
    পরিচালক
    96 Burnham Road
    SS9 2JS Leigh On Sea
    Essex
    EnglandBritish5389800001
    KAUFMAN, John Banwell
    6 Scotsdale Close
    BR5 1NU Petts Wood
    Kent
    পরিচালক
    6 Scotsdale Close
    BR5 1NU Petts Wood
    Kent
    EnglandBritish147388510001
    KIER, Michael Hector
    23 Belmont Road
    TW2 5DA Twickenham
    Middlesex
    পরিচালক
    23 Belmont Road
    TW2 5DA Twickenham
    Middlesex
    Danish8719670001
    LETBY, Roger David
    19 Alverton Close
    Great Notley
    CM7 8XU Braintree
    Essex
    পরিচালক
    19 Alverton Close
    Great Notley
    CM7 8XU Braintree
    Essex
    British28585270003
    MACKAY, Ian Hamish Noel
    27 Percy Laurie House
    217 Upper Richmond Road
    SW15 6SY London
    পরিচালক
    27 Percy Laurie House
    217 Upper Richmond Road
    SW15 6SY London
    British104334150001
    MACKENZIE GREEN, John Garvie
    Higher Langdon
    DT8 3NN Beaminster
    Dorset
    পরিচালক
    Higher Langdon
    DT8 3NN Beaminster
    Dorset
    British34988570004
    MACKENZIE GREEN, John Garvie
    Cheesedown Farm
    Steventon
    RG25 3AY Basingstoke
    Hampshire
    পরিচালক
    Cheesedown Farm
    Steventon
    RG25 3AY Basingstoke
    Hampshire
    British34988570001
    MCCARTHY, Paul Frank
    Tor House Station Road
    Woldingham
    CR3 7DA Caterham
    Surrey
    পরিচালক
    Tor House Station Road
    Woldingham
    CR3 7DA Caterham
    Surrey
    British65173730001
    MONEY, Anthony John
    Bevingdon House
    Belchamp Otten
    CO10 7BE Sudbury
    Suffolk
    পরিচালক
    Bevingdon House
    Belchamp Otten
    CO10 7BE Sudbury
    Suffolk
    EnglandBritish8785440001
    MUGGE, Mark Stephen
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    পরিচালক
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    EnglandAmerican162920630001
    NEWBERY, Trevor Philip
    Mount Lodge
    37 Thorpe Esplanade
    SS1 3BA Southend On Sea
    Essex
    পরিচালক
    Mount Lodge
    37 Thorpe Esplanade
    SS1 3BA Southend On Sea
    Essex
    British66912140001
    NEWBERY, Trevor Philip
    Mount Lodge
    37 Thorpe Esplanade
    SS1 3BA Southend On Sea
    Essex
    পরিচালক
    Mount Lodge
    37 Thorpe Esplanade
    SS1 3BA Southend On Sea
    Essex
    British66912140001
    NICHOLS, David William
    Fairacre Ravensdale Road
    South Ascot
    SL5 9HJ Ascot
    Berkshire
    পরিচালক
    Fairacre Ravensdale Road
    South Ascot
    SL5 9HJ Ascot
    Berkshire
    British6384890001
    PRESLAND, Peter Eric
    Rats Castle
    Castletons Oak Cranbrook Road
    TN27 8DY Biddenden Ashford
    Kent
    পরিচালক
    Rats Castle
    Castletons Oak Cranbrook Road
    TN27 8DY Biddenden Ashford
    Kent
    EnglandBritish7649630002
    PROCTOR, Jonathan Paul
    6 Herondale Avenue
    Wandsworth Common
    SW18 3JL London
    পরিচালক
    6 Herondale Avenue
    Wandsworth Common
    SW18 3JL London
    British8638320001

    HEATH INSURANCE BROKING LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Friary Intermediate Limited
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    England
    না
    আইনি ফর্মLimited Company
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানEngland And Wales
    নিবন্ধন নম্বর4404202
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।

    HEATH INSURANCE BROKING LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ ফেব, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ মার্চ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties (as defined) pursuant to all or any of the secured documents (as defined), including the debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ মার্চ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জানু, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of variation made in addition to and modifying the security and trust deed dated 1 september 1989 ("the principal deed") as modified by a deed of variation dated 1 november 1993 (the "first deed of variation"),
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ সেপ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ অক্টো, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to lloyds brokers byelaw (no. 5 of 1988) (see form 395 for full details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyd's
    ব্যবসায়
    • ০১ অক্টো, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ জুল, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Third guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ ডিসে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ জানু, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the senior finance documents and the debenture as defined therein
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Trustee for the Beneficiaries
    ব্যবসায়
    • ১৪ জানু, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ মে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Second guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ ডিসে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the senior finance documents and the debenture as defined therein
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for the Beneficiaries
    ব্যবসায়
    • ২২ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ মে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of variation
    তৈরি করা হয়েছে ০১ নভে, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ নভে, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the security and trust deed dated 01/09/89
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies standing to the credit of an insurance broking account. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds
    ব্যবসায়
    • ১০ নভে, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ জুল, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deposit agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ নভে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ নভে, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deposit agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The balances for the time being standing to the credit of any accounts with the bank see form 395 for details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citibank N.A.
    ব্যবসায়
    • ১২ নভে, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ নভে, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Trust deed
    তৈরি করা হয়েছে ০১ সেপ, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ সেপ, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    See schedule attached to form 395 for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyd's as Trustee
    ব্যবসায়
    • ১৪ সেপ, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৩ জুল, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deposit charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ নভে, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ নভে, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All right title & interest of the company in & all sums from time to time standing to the credit of each l/c deposit account in the name of the company opened with the bank.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ নভে, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০১ ডিসে, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge document
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ এপ্রি, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ এপ্রি, ১৯৮৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A) all sums of money which may now or hereafter be held by or for the account of the bank in the name or the company at the main office of the bank in london together with all interest accruing from time to time thereon. B) all shares stocks, bonds debentures certificates of deposit or other securities (see doc M21 for details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Chase Manhattan Bank N.A.
    ব্যবসায়
    • ২৫ এপ্রি, ১৯৮৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১১ জুল, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Trust deed
    তৈরি করা হয়েছে ২১ ফেব, ১৯৮৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ১৯৮৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the company's right title and interest in the monies standing to the credit of the company's "c" account and monies and investments standing to the credit in other iba accounts of the company. (See doc M.20).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Corporation of Lloyd's
    ব্যবসায়
    • ২৩ ফেব, ১৯৮৩একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৯ অক্টো, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0