MARSHELL GROUP LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামMARSHELL GROUP LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01011142
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    MARSHELL GROUP LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    MARSHELL GROUP LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Ground Floor West
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Essex
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    MARSHELL GROUP LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    TOBACCO KIOSKS LIMITED১৪ মে, ১৯৭১১৪ মে, ১৯৭১

    MARSHELL GROUP LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে২৯ নভে, ২০২০

    MARSHELL GROUP LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ স্থগিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাSOAS(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর সংক্ষিপ্ত ২৯ মে, ২০২২ থেকে ২৮ মে, ২০২২ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ২৯ মে, ২০২৩ থেকে ২৯ নভে, ২০২৩ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর সংক্ষিপ্ত ৩০ মে, ২০২২ থেকে ২৯ মে, ২০২২ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    ১৯ এপ্রি, ২০২৩ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর সংক্ষিপ্ত ৩১ মে, ২০২২ থেকে ৩০ মে, ২০২২ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩০ নভে, ২০২১ থেকে ৩১ মে, ২০২২ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    ০৪ মে, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Chief Operating Officer Karen Anita Mcewan-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৯ এপ্রি, ২০২২ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ২৪ মার্চ, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Simon Jonathan Miller এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৪ মার্চ, ২০২২ তারিখে সচিব হিসাবে Indigo Corporate Secretary Limited-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP04

    ১৪ মার্চ, ২০২২ তারিখে সচিব হিসাবে Rachel Peat এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২৯ নভে, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    ১৯ এপ্রি, ২০২১ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ০৬ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Tm Group Holdings Ltd এর বিবরণের পরিবর্তন

    2 পৃষ্ঠাPSC05

    ০৯ ডিসে, ২০২০ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Tm Group Holdings Ltd এর বিবরণের পরিবর্তন

    2 পৃষ্ঠাPSC05

    ০৯ ডিসে, ২০২০ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Ground Floor West One London Road Brentwood Essex CM14 4QP United Kingdom থেকে Ground Floor West One London Road Brentwood Essex CM14 4QWপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২৪ নভে, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    ১০ সেপ, ২০২০ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Mccoll's House Ashwells Road Brentwood Essex CM15 9st থেকে Ground Floor West One London Road Brentwood Essex CM14 4QPপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ০৯ জুল, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Giles Matthew Oliver David-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ৩০ জুন, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Robbie Ian Bell এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৯ এপ্রি, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    MARSHELL GROUP LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    INDIGO CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Rectory Grove
    SS9 2HL Leigh On Sea
    Monometer House
    Essex
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    Rectory Grove
    SS9 2HL Leigh On Sea
    Monometer House
    Essex
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইউকে লিমিটেড কোম্পানি
    নিবন্ধন নম্বর13253973
    281695990002
    BUTLER, Stuart Clive
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    England
    পরিচালক
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    England
    EnglandBritishFinance Director127794710001
    DAVID, Giles Matthew Oliver
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    England
    পরিচালক
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer187907210001
    MCEWAN, Karen Anita
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    England
    পরিচালক
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    England
    EnglandBritishChief Operating Officer 272054760001
    BARNES, Christopher Howard
    11 Hepplewhite Close
    Baughurst
    RG26 5HD Basingstoke
    Hampshire
    সচিব
    11 Hepplewhite Close
    Baughurst
    RG26 5HD Basingstoke
    Hampshire
    British25597650001
    FAIRBAIRN, David William
    15 Chestnut Avenue
    WD3 4HA Rickmansworth
    Hertfordshire
    সচিব
    15 Chestnut Avenue
    WD3 4HA Rickmansworth
    Hertfordshire
    British35463440001
    GOSNELL, Michael James
    The Birches
    1 Lowfield Close
    GU18 5QT Lightwater
    Surrey
    সচিব
    The Birches
    1 Lowfield Close
    GU18 5QT Lightwater
    Surrey
    British10496160001
    MILLER, Simon Jonathan
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    সচিব
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    British88269280005
    PEAT, Rachel
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    England
    সচিব
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    England
    256010520001
    TEDDER, Kingsley John
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    সচিব
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    British101631010002
    YOUNG, Bernadette Clare
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    সচিব
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    237929500001
    AGUSS, Martyn James
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    পরিচালক
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    EnglandBritishDirector107991420002
    BELL, Robbie Ian
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    পরিচালক
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    EnglandBritishChief Financial Officer97384120002
    BROWN, Ian
    5 Coldicott Gardens
    Orchard Manor
    WR11 6JW Evesham
    Worcestershire
    পরিচালক
    5 Coldicott Gardens
    Orchard Manor
    WR11 6JW Evesham
    Worcestershire
    BritishManaging Director38866120001
    BULPITT, Nigel Peter
    The Old School
    Upper Froyle
    GU34 4LB Alton
    Hampshire
    পরিচালক
    The Old School
    Upper Froyle
    GU34 4LB Alton
    Hampshire
    EnglandBritishChartered Accountant451080002
    BURCHELL, Philip Raymond
    123 Tolmers Road
    EN6 4JW Cuffley Potters Bar
    Hertfordshire
    পরিচালক
    123 Tolmers Road
    EN6 4JW Cuffley Potters Bar
    Hertfordshire
    BritishCompany Director36622820001
    BUTLER, Adrian Nickolas
    The Retreat
    Wellmans Meadow
    RG20 5HJ Kingsclere
    Berkshire
    পরিচালক
    The Retreat
    Wellmans Meadow
    RG20 5HJ Kingsclere
    Berkshire
    BritishRetail Director48681750001
    CARPENTER, George Frederick Alfred
    8 Yarrowside
    Little Chalfont
    HP7 9QL Amersham
    Bucks
    পরিচালক
    8 Yarrowside
    Little Chalfont
    HP7 9QL Amersham
    Bucks
    BritishCompany Director7680560001
    COX, Allister Russell
    The Small House Mynthurst
    Leigh
    RH2 8RJ Reigate
    Surrey
    পরিচালক
    The Small House Mynthurst
    Leigh
    RH2 8RJ Reigate
    Surrey
    EnglandBritishFinancial Dir31500810002
    CULLENS, Alan
    4 Alexandra House
    Queens Hill Lodge
    SL5 7EQ Ascot
    Berkshire
    পরিচালক
    4 Alexandra House
    Queens Hill Lodge
    SL5 7EQ Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector6875310002
    FAIRBAIRN, David William
    15 Chestnut Avenue
    WD3 4HA Rickmansworth
    Hertfordshire
    পরিচালক
    15 Chestnut Avenue
    WD3 4HA Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant7680570001
    FULLER, Simon Jeremy Ian
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    পরিচালক
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    EnglandBritishCfo181763320001
    GREEN, Steven
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    পরিচালক
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    EnglandBritishDirector209349290001
    GRIFFITHS, William Trafford
    26 Dove Park
    Chorleywood
    WD3 5NY Rickmansworth
    Hertfordshire
    পরিচালক
    26 Dove Park
    Chorleywood
    WD3 5NY Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishCompany Director26623510001
    KEEN, David John
    4 Boynton Drive
    Mapperley
    NG3 3EP Nottingham
    পরিচালক
    4 Boynton Drive
    Mapperley
    NG3 3EP Nottingham
    BritishCompany Director56997350001
    LANCASTER, James
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    পরিচালক
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    EnglandBritishDirector147052660001
    MILLER, Simon Jonathan
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    England
    পরিচালক
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    England
    EnglandBritishDirector88269280005
    MITCHELL, Philip
    3 White House Drive
    Merrow
    GU1 2SU Guildford
    Surrey
    পরিচালক
    3 White House Drive
    Merrow
    GU1 2SU Guildford
    Surrey
    BritishCompany Director6907290001
    PANTO, Ian Michael
    Eversley Park Avenue
    Chorleywood
    WD3 5DU Rickmansworth
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Eversley Park Avenue
    Chorleywood
    WD3 5DU Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishCompany Director26623520001
    TERRAS, Duncan Crichton
    5 Old Manor Close
    Drayton Bassett
    B78 3UQ Tamworth
    Staffordshire
    পরিচালক
    5 Old Manor Close
    Drayton Bassett
    B78 3UQ Tamworth
    Staffordshire
    BritishDirector43713630003
    THOMSON, Peter Nicholson
    Cranwell Lodge 29 Marshals Drive
    AL1 4RB St Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Cranwell Lodge 29 Marshals Drive
    AL1 4RB St Albans
    Hertfordshire
    ScottishRetail Trading Director975790001
    WATERS, Nigel John
    The Retreat
    Stanford Road Swinford
    LE17 6BJ Lutterworth
    Leicestershire
    পরিচালক
    The Retreat
    Stanford Road Swinford
    LE17 6BJ Lutterworth
    Leicestershire
    BritishDirector39768100001
    WILKINSON, Stephen William
    Martin Mccoll House
    Ashwells Road,
    CM15 9ST Pilgrims Hatch, Brentwood
    Essex
    পরিচালক
    Martin Mccoll House
    Ashwells Road,
    CM15 9ST Pilgrims Hatch, Brentwood
    Essex
    United KingdomBritishDirector101631100002

    MARSHELL GROUP LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    United Kingdom
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    United Kingdom
    না
    আইনি ফর্মLimited By Shares
    নিবন্ধিত দেশUnited Kingdom
    আইনি কর্তৃপক্ষEngland
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর03462566
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    MARSHELL GROUP LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ জুল, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ জুল, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৪ জুল, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ অক্টো, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ নভে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ডিসে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from company to the chargee (as agent and trustee for the secured parties (as therein defined) pursuant to the terms of a credit agreement (as therein defined)) under or pursuant to any of the financing documents (as therein defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ ডিসে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ জুন, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জুল, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ জুল, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties and to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to the financing documents (as defined) including this guarantee and debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ৩১ জুল, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ মে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ সেপ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ সেপ, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the rent deposit deed
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The rent deposit account in respect of the l/h premises k/a concession unit 3 netto foodstore oldfirld lane wortley leeds. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Dansk Supermarkets
    ব্যবসায়
    • ২৯ সেপ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ আগ, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0