MARSHELL GROUP LIMITED
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
কোম্পানির নাম | MARSHELL GROUP LIMITED |
---|---|
কোম্পানির স্থিতি | বাতিল |
আইনি ফর্ম | প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি |
কোম্পানি নম্বর | 01011142 |
এখতিয়ার | ইংল্যান্ড/ওয়েলস |
সৃষ্টির তারিখ | |
বন্ধের তারিখ |
সংক্ষিপ্তসার
সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছে | না |
---|---|
চার্জ রয়েছে | হ্যাঁ |
দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছে | না |
নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণ | না |
MARSHELL GROUP LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?
- নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম
MARSHELL GROUP LIMITED কোথায় অবস্থিত?
নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | Ground Floor West One London Road CM14 4QW Brentwood Essex England |
---|---|
ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | না |
MARSHELL GROUP LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?
কোম্পানির নাম | থেকে | পর্যন্ত |
---|---|---|
TOBACCO KIOSKS LIMITED | ১৪ মে, ১৯৭১ | ১৪ মে, ১৯৭১ |
MARSHELL GROUP LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?
শেষ হিসাব | |
---|---|
শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে | ২৯ নভে, ২০২০ |
MARSHELL GROUP LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?
তারিখ | বর্ণনা | দলিল | প্রকার | |
---|---|---|---|---|
স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান ্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | GAZ2(A) | ||
স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ স্থগিত করা হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | SOAS(A) | ||
স্বে চ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি | 1 পৃষ্ঠা | GAZ1(A) | ||
কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন | 3 পৃষ্ঠা | DS01 | ||
বর্তমান হিসাব অর্থবছর সংক্ষিপ্ত ২৯ মে, ২০২২ থেকে ২৮ মে, ২০২২ পর্যন্ত | 1 পৃষ্ঠা | AA01 | ||
বর্তমান হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ২৯ মে, ২০২৩ থেকে ২৯ নভে, ২০২৩ পর্যন্ত | 1 পৃষ্ঠা | AA01 | ||
পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর সংক্ষিপ্ত ৩০ মে, ২০২২ থেকে ২৯ মে, ২০২২ পর্যন্ত | 1 পৃষ্ঠা | AA01 | ||
১৯ এপ্রি, ২০২৩ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর সংক্ষিপ্ত ৩১ মে, ২০২২ থেকে ৩০ মে, ২০২২ পর্যন্ত | 1 পৃষ্ঠা | AA01 | ||
পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩০ নভে, ২০২১ থেকে ৩১ মে, ২০২২ পর্যন্ত | 1 পৃষ্ঠা | AA01 | ||
০৪ মে, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Chief Operating Officer Karen Anita Mcewan-এর নিয়োগ | 2 পৃষ্ঠা | AP01 | ||
১৯ এপ্রি, ২০২২ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
২৪ মার্চ, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Simon Jonathan Miller এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||
১৪ মার্চ, ২০২২ তারিখে সচিব হিসাবে Indigo Corporate Secretary Limited-এর নিয়োগ | 2 পৃষ্ঠা | AP04 | ||
১৪ মার্চ, ২০২২ তারিখে সচিব হিসাবে Rachel Peat এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM02 | ||
নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২৯ নভে, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি | 4 পৃষ্ঠা | AA | ||
১৯ এপ্রি, ২০২১ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
০৬ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Tm Group Holdings Ltd এর বিবরণের পরিবর্তন | 2 পৃষ্ঠা | PSC05 | ||
০৯ ডিসে, ২০২০ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Tm Group Holdings Ltd এর বিবরণের পরিবর্তন | 2 পৃষ্ঠা | PSC05 | ||
০৯ ডিসে, ২০২০ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Ground Floor West One London Road Brentwood Essex CM14 4QP United Kingdom থেকে Ground Floor West One London Road Brentwood Essex CM14 4QW এ পরিবর্তন করা হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | AD01 | ||
নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২৪ নভে, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি | 4 পৃষ্ঠা | AA | ||
১০ সেপ, ২০২০ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Mccoll's House Ashwells Road Brentwood Essex CM15 9st থেকে Ground Floor West One London Road Brentwood Essex CM14 4QP এ পরিবর্তন করা হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | AD01 | ||
০৯ জুল, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Giles Matthew Oliver David-এর নিয়োগ | 2 পৃষ্ঠা | AP01 | ||
৩০ জুন, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Robbie Ian Bell এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||
১৯ এপ্রি, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
MARSHELL GROUP LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?
নাম | নিয়োগ করা হয়েছে | পদত্যাগের তারিখ | ভূমি কা | ঠিকানা | কোম্পানি পরিচয় | বাসস্থানের দেশ | জাতীয়তা | জন্ম তারিখ | পেশা | নম্বর | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDIGO CORPORATE SECRETARY LIMITED | কর্পোরেট সচিব | Rectory Grove SS9 2HL Leigh On Sea Monometer House Essex United Kingdom |
| 281695990002 | ||||||||||
BUTLER, Stuart Clive | পরিচালক | One London Road CM14 4QW Brentwood Ground Floor West Essex England | England | British | Finance Director | 127794710001 | ||||||||
DAVID, Giles Matthew Oliver | পরিচালক | One London Road CM14 4QW Brentwood Ground Floor West Essex England | England | British | Chief Financial Officer | 187907210001 | ||||||||
MCEWAN, Karen Anita | পরিচালক | One London Road CM14 4QW Brentwood Ground Floor West Essex England | England | British | Chief Operating Officer | 272054760001 | ||||||||
BARNES, Christopher Howard | সচিব | 11 Hepplewhite Close Baughurst RG26 5HD Basingstoke Hampshire | British | 25597650001 | ||||||||||
FAIRBAIRN, David William | সচিব | 15 Chestnut Avenue WD3 4HA Rickmansworth Hertfordshire | British | 35463440001 | ||||||||||
GOSNELL, Michael James | সচিব | The Birches 1 Lowfield Close GU18 5QT Lightwater Surrey | British | 10496160001 | ||||||||||
MILLER, Simon Jonathan | সচিব | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex England | British | 88269280005 | ||||||||||
PEAT, Rachel | সচিব | One London Road CM14 4QW Brentwood Ground Floor West Essex England | 256010520001 | |||||||||||
TEDDER, Kingsley John | সচিব | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex England | British | 101631010002 | ||||||||||
YOUNG, Bernadette Clare | সচিব | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex | 237929500001 | |||||||||||
AGUSS, Martyn James | পরিচালক | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex England | England | British | Director | 107991420002 | ||||||||
BELL, Robbie Ian | পরিচালক | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex | England | British | Chief Financial Officer | 97384120002 | ||||||||
BROWN, Ian | পরিচালক | 5 Coldicott Gardens Orchard Manor WR11 6JW Evesham Worcestershire | British | Managing Director | 38866120001 | |||||||||
BULPITT, Nigel Peter | পরিচালক | The Old School Upper Froyle GU34 4LB Alton Hampshire | England | British | Chartered Accountant | 451080002 | ||||||||
BURCHELL, Philip Raymond | পরিচালক | 123 Tolmers Road EN6 4JW Cuffley Potters Bar Hertfordshire | British | Company Director | 36622820001 | |||||||||
BUTLER, Adrian Nickolas | পরিচালক | The Retreat Wellmans Meadow RG20 5HJ Kingsclere Berkshire | British | Retail Director | 48681750001 | |||||||||
CARPENTER, George Frederick Alfred | পরিচালক | 8 Yarrowside Little Chalfont HP7 9QL Amersham Bucks | British | Company Director | 7680560001 | |||||||||
COX, Allister Russell | পরিচালক | The Small House Mynthurst Leigh RH2 8RJ Reigate Surrey | England | British | Financial Dir | 31500810002 | ||||||||
CULLENS, Alan | পরিচালক | 4 Alexandra House Queens Hill Lodge SL5 7EQ Ascot Berkshire | United Kingdom | British | Director | 6875310002 | ||||||||
FAIRBAIRN, David William | পরিচালক | 15 Chestnut Avenue WD3 4HA Rickmansworth Hertfordshire | British | Chartered Accountant | 7680570001 | |||||||||
FULLER, Simon Jeremy Ian | পরিচালক | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex | England | British | Cfo | 181763320001 | ||||||||
GREEN, Steven | পরিচালক | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex | England | British | Director | 209349290001 | ||||||||
GRIFFITHS, William Trafford | পরিচালক | 26 Dove Park Chorleywood WD3 5NY Rickmansworth Hertfordshire | British | Company Director | 26623510001 | |||||||||
KEEN, David John | পরিচালক | 4 Boynton Drive Mapperley NG3 3EP Nottingham | British | Company Director | 56997350001 | |||||||||
LANCASTER, James | পরিচালক | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex England | England | British | Director | 147052660001 | ||||||||
MILLER, Simon Jonathan | পরিচালক | One London Road CM14 4QW Brentwood Ground Floor West Essex England | England | British | Director | 88269280005 | ||||||||
MITCHELL, Philip | পরিচালক | 3 White House Drive Merrow GU1 2SU Guildford Surrey | British | Company Director | 6907290001 | |||||||||
PANTO, Ian Michael | পরিচালক | Eversley Park Avenue Chorleywood WD3 5DU Rickmansworth Hertfordshire | British | Company Director | 26623520001 | |||||||||
TERRAS, Duncan Crichton | পরিচালক | 5 Old Manor Close Drayton Bassett B78 3UQ Tamworth Staffordshire | British | Director | 43713630003 | |||||||||
THOMSON, Peter Nicholson | পরিচালক | Cranwell Lodge 29 Marshals Drive AL1 4RB St Albans Hertfordshire | Scottish | Retail Trading Director | 975790001 | |||||||||
WATERS, Nigel John | পরিচালক | The Retreat Stanford Road Swinford LE17 6BJ Lutterworth Leicestershire | British | Director | 39768100001 | |||||||||
WILKINSON, Stephen William | পরিচালক | Martin Mccoll House Ashwells Road, CM15 9ST Pilgrims Hatch, Brentwood Essex | United Kingdom | British | Director | 101631100002 |
MARSHELL GROUP LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?
নাম | জানানো হয়েছে | ঠিকানা | বন্ধ হয়েছে | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tm Group Holdings Ltd | ০৬ এপ্রি, ২০১৬ | One London Road CM14 4QW Brentwood Ground Floor West Essex United Kingdom | না | ||||||||||
| |||||||||||||
নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
|
MARSHELL GROUP LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?
শ্রেণীবিন্যাস | তারিখ | স্থিতি | বিস্তারিত | |
---|---|---|---|---|
Debenture | তৈরি করা হয়েছে ১৭ জুল, ২০০২ ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ জুল, ২০০২ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Guarantee & debenture | তৈরি করা হয়েছে ২৮ নভে, ১৯৯৮ ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ডিসে, ১৯৯৮ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from company to the chargee (as agent and trustee for the secured parties (as therein defined) pursuant to the terms of a credit agreement (as therein defined)) under or pursuant to any of the financing documents (as therein defined) | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Guarantee and debenture | তৈরি করা হয়েছে ২৪ জুল, ১৯৯৫ ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ জুল, ১৯৯৫ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties and to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to the financing documents (as defined) including this guarantee and debenture | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Rent deposit deed | তৈরি করা হয়েছে ২৬ সেপ, ১৯৯৪ ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ সেপ, ১৯৯৪ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the rent deposit deed | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ The rent deposit account in respect of the l/h premises k/a concession unit 3 netto foodstore oldfirld lane wortley leeds. See the mortgage charge document for full details. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
|
তথ্য উৎস
- ইউকে কম্পানিজ হাউস
যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে। - লাইসেন্স: CC0