WIGHTLINK HOLIDAYS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামWIGHTLINK HOLIDAYS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01036534
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    WIGHTLINK HOLIDAYS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • সমুদ্র এবং উপকূলীয় মালবাহী জল পরিবহন (50200) / পরিবহন এবং স্টোরেজ

    WIGHTLINK HOLIDAYS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Gunwharf Terminal
    Gunwharf Road
    PO1 2LA Portsmouth
    Hampshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    WIGHTLINK HOLIDAYS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    PASSTRUCK(SHIPPING)COMPANY LIMITED৩০ ডিসে, ১৯৭১৩০ ডিসে, ১৯৭১

    WIGHTLINK HOLIDAYS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১৫

    WIGHTLINK HOLIDAYS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    6 পৃষ্ঠা4.71

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ২৪ ফেব, ২০১৬ তারিখে

    LRESSP

    ১৮ ডিসে, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে John Burrows-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৮ ডিসে, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Russell Kew এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৭ এপ্রি, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    9 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৮ মে, ২০১৫

    ১৮ মে, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ গৃহীত করার রেজুলেশন

    RES01

    ১৩ ফেব, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Gordon Ian Winston Parsons এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    ১৩ ফেব, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Raffaella Copper এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    ১৩ ফেব, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Richard Abel এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    ১৩ ফেব, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Steven Lowry-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    ১৩ ফেব, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Robert John Gregor-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    ১৩ ফেব, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Holt William John Hanna-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২৯ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    ০৩ জুল, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Richard Abel-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৭ এপ্রি, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    9 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৭ মে, ২০১৪

    ০৭ মে, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    পরিচালক হিসাবে Raffaella Copper-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০১ ফেব, ২০১৪ তারিখে Mr Gordon Ian Winston Parsons-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Richard Carroll এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৭ এপ্রি, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    9 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    WIGHTLINK HOLIDAYS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    PASCOE, Jonathan Mark
    Felstead
    Kingsmead,
    PO17 5AX Wickham
    Hampshire
    সচিব
    Felstead
    Kingsmead,
    PO17 5AX Wickham
    Hampshire
    British95618140004
    BURROWS, John Robert
    Gunwharf Terminal
    Gunwharf Road
    PO1 2LA Portsmouth
    Hampshire
    পরিচালক
    Gunwharf Terminal
    Gunwharf Road
    PO1 2LA Portsmouth
    Hampshire
    EnglandBritishBusiness Manager203907140001
    GREGOR, Robert John
    Gunwharf Terminal
    Gunwharf Road
    PO1 2LA Portsmouth
    Hampshire
    পরিচালক
    Gunwharf Terminal
    Gunwharf Road
    PO1 2LA Portsmouth
    Hampshire
    United KingdomBritishManaging Partner Investment Adviser194229200001
    HANNA, Holt William John
    Gunwharf Terminal
    Gunwharf Road
    PO1 2LA Portsmouth
    Hampshire
    পরিচালক
    Gunwharf Terminal
    Gunwharf Road
    PO1 2LA Portsmouth
    Hampshire
    United KingdomBritishVice President Investment Adviser175956200002
    LOWRY, Steven
    Gunwharf Terminal
    Gunwharf Road
    PO1 2LA Portsmouth
    Hampshire
    পরিচালক
    Gunwharf Terminal
    Gunwharf Road
    PO1 2LA Portsmouth
    Hampshire
    United KingdomBritishPartner Investment Adviser238941650001
    PASCOE, Jonathan Mark
    Felstead
    Kingsmead,
    PO17 5AX Wickham
    Hampshire
    পরিচালক
    Felstead
    Kingsmead,
    PO17 5AX Wickham
    Hampshire
    EnglandBritishChartered Accountant95618140004
    HUMPHRYES, Adam Salusbury
    Eleanor House
    Gilbert Street
    SO24 0BY Ropley
    Hampshire
    সচিব
    Eleanor House
    Gilbert Street
    SO24 0BY Ropley
    Hampshire
    BritishFinance Director1964480001
    MULVEY, Michael Peter
    14 Sylvan Lane
    Hamble
    SO31 4QG Southampton
    Hampshire
    সচিব
    14 Sylvan Lane
    Hamble
    SO31 4QG Southampton
    Hampshire
    BritishConsultant71070260001
    WALKER, Peter Colin
    Home Farm House Easole Street
    Nonington
    CT15 4HG Dover
    Kent
    সচিব
    Home Farm House Easole Street
    Nonington
    CT15 4HG Dover
    Kent
    English59076670002
    ABEL, Richard
    28 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Ropemaker Place
    England
    পরিচালক
    28 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Ropemaker Place
    England
    United KingdomBritishFund Manager155181590001
    AIKEN, Michael Patrick
    Bottle House Lane
    South Park
    TN11 8ET Penshurst
    Horns Lodge
    Kent
    পরিচালক
    Bottle House Lane
    South Park
    TN11 8ET Penshurst
    Horns Lodge
    Kent
    EnglandBritishChairman63802210001
    AIKEN, Michael Patrick
    Bottle House Lane
    South Park
    TN11 8ET Penshurst
    Horns Lodge
    Kent
    পরিচালক
    Bottle House Lane
    South Park
    TN11 8ET Penshurst
    Horns Lodge
    Kent
    EnglandBritishShipping63802210001
    BENSON, David Gillies
    Ducks Farm
    Eastcott
    SN10 4PJ Devizes
    Wiltshire
    পরিচালক
    Ducks Farm
    Eastcott
    SN10 4PJ Devizes
    Wiltshire
    BritishDirector1856390001
    BOGG, Dyson Peter Kelly
    Citypoint
    Level 35, Citypoint 1 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Level 35,
    পরিচালক
    Citypoint
    Level 35, Citypoint 1 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Level 35,
    United KingdomAustralianBanker135422570001
    CARROLL, Richard William Stanley
    28 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Ropemaker Place
    England
    পরিচালক
    28 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Ropemaker Place
    England
    United KingdomBritishDirector159253020001
    COPPER, Raffaella
    28 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Ropemaker Place
    England
    পরিচালক
    28 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Ropemaker Place
    England
    EnglandBritishDirector187466450001
    EDSALL, Simon James
    Cross House
    High Street
    GU32 1NW East Meon
    Hampshire
    পরিচালক
    Cross House
    High Street
    GU32 1NW East Meon
    Hampshire
    United KingdomBritishBanker127921480003
    HOGAN, Philip
    13 Lexden Road
    West Bergholt
    CO6 3BT Essex
    Prospect House
    United Kingdom
    পরিচালক
    13 Lexden Road
    West Bergholt
    CO6 3BT Essex
    Prospect House
    United Kingdom
    EnglandBritishAssociate Director152768350001
    HUMPHRYES, Adam Salusbury
    Eleanor House
    Gilbert Street
    SO24 0BY Ropley
    Hampshire
    পরিচালক
    Eleanor House
    Gilbert Street
    SO24 0BY Ropley
    Hampshire
    United KingdomBritishFinance Director1964480001
    KEW, Russell Martin
    Woodlands
    Wallington
    PO16 8UH Fareham
    3
    Hampshire
    England
    পরিচালক
    Woodlands
    Wallington
    PO16 8UH Fareham
    3
    Hampshire
    England
    EnglandBritishChief Executive83815440001
    MULVEY, Michael Peter
    14 Sylvan Lane
    Hamble
    SO31 4QG Southampton
    Hampshire
    পরিচালক
    14 Sylvan Lane
    Hamble
    SO31 4QG Southampton
    Hampshire
    BritishConsultant71070260001
    O'SULLIVAN, Daniel John
    26 Forest Close
    BR7 5QS Chislehurst
    Kent
    পরিচালক
    26 Forest Close
    BR7 5QS Chislehurst
    Kent
    BritishChartered Accountant1630610001
    PARSONS, Gordon Ian Winston
    28 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Ropemaker Place
    England
    পরিচালক
    28 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Ropemaker Place
    England
    United KingdomBritishAccountant183966450004
    STANLEY, Martin Stephen William
    IP12
    পরিচালক
    IP12
    United KingdomBritishBanker67692310003
    STRACEY, Michael John Louis
    Kenton Lodge Kenton
    Debenham
    IP14 6JT Stowmarket
    Suffolk
    পরিচালক
    Kenton Lodge Kenton
    Debenham
    IP14 6JT Stowmarket
    Suffolk
    BritishChartered Accountant1843510001
    WHITE, Philip Joseph
    16 Hildenbrook Farm
    Riding Lane
    TN11 9JN Hildenbourough
    Kent
    পরিচালক
    16 Hildenbrook Farm
    Riding Lane
    TN11 9JN Hildenbourough
    Kent
    United KingdomBritishBanker148798530001
    WILLIAMS, Melvyn
    3 The Highway
    HA7 3PJ Stanmore
    Middlesex
    পরিচালক
    3 The Highway
    HA7 3PJ Stanmore
    Middlesex
    BritishManaging Director36599330001
    WILLSON, Andrew David
    Honeysuckle Cottage
    West Meon
    GU32 1LX Petersfield
    Hampshire
    পরিচালক
    Honeysuckle Cottage
    West Meon
    GU32 1LX Petersfield
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector109054960001

    WIGHTLINK HOLIDAYS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Wightlink deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ আগ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ আগ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    In favour of the chargee all moneys and liabilities whatsoever which now or at any time hereafter may become due, owing or payable to the security trustee or any of the other wightlink secured parties by whl and each other obligor (both as defined) actually or contingently, under or in respect of the issuer/borrower facility agreement and/or the working capital facility agreement, the wightlink deed of charge or any other relevant document to which the obligor is a party
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All of its right title interest and benefit present and future in to and under the relevant documents (other than the issuer/borrower facility agreement) to which it is a party..all of its right title interest and benefit present and future in and to all book debts and other debts, rents and all moneys and liabilities whatsoever (see form 395 for further details) floating charge the whole of its undertaking all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Prudential Trustee Company Limited
    ব্যবসায়
    • ২৪ আগ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ জুন, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ জুন, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ জুন, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under or pursuant to the facility documents and/or the security documents as defined in this guarantee and debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland Plcas Security Trustee
    ব্যবসায়
    • ১৯ জুন, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ ফেব, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ নভে, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ নভে, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The payment, discharge and satisfaction to the chargee of the obligations of the company under the terms of the finance documents
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Meespierson N.V. (As Trustee for and on Behalf of the Beneficiaries)
    ব্যবসায়
    • ২৯ নভে, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ জুন, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ ডিসে, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ ডিসে, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums payable under a facility agreement dated 17TH december 1990 (see form 395 for further details)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All book and other debts and monetary claims. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Chase Manhattan Bank N.A
    ব্যবসায়
    • ২১ ডিসে, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৪ ফেব, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ডিসে, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জানু, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys due or to become due from the company and/or sealing harbours limited to the chargee under the terms of a tripartite agreement dated 23RD december 1988 and the financial institutions named as "banks" in the facility agreement dated 13TH december 1988 as amended from time to time and to barclays bank PLC pursuant to the overdraft facility agreement dated 13TH december 1988 as amended from time to time.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the company's right title & interest in & to all policies & contracts of insurance & intries ina protection & indennity in respect of the vessels (for full details see from 395 ref:- M311).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Chase Manhattan Bank N.A.
    ব্যবসায়
    • ০৪ জানু, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৬ মে, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ডিসে, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জানু, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys due or to become due from the company and/or sealine harboures limited to the chargee under the terms go a triportite agreement dated 23RD december 1988 and the financial institutions named as "banks" in the facility agreement dated 13TH december 1988 as amended from time to time and to barclays bank PLC pursuant to the overdraft facility agreement dated 13TH december 1988 as amended from time to time
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the company's right, title & interest in & to all policies & contracts of insurance & entries in a protection & indennity inrespect of the vessels (for full details see forms 395 ref:- M311).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Chase Manhattan Bank N.A.
    ব্যবসায়
    • ০৪ জানু, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৬ মে, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ডিসে, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জানু, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys due or to become due from the company and/or sealine harboures limited to the chargee under the terms of a tripartite agreement dated 23RD december 1988 and the financial institutions named as "banks" in the facility agreement dated 13TH december 1988 as amended from time to time and to barclays bank PLC pursuant to the overdraft facility agreement dated 13TH december 1988 as amended from time to time.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the company's right, title a interesst in & to all policies & contracts of insurance a entries in a protection & indennityin respect of the vessels (for full details see form 395 ref:- M311).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Chase Manhattan Bank N.A.
    ব্যবসায়
    • ০৪ জানু, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৬ মে, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Ships mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ডিসে, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জানু, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from seabank UK limited and/or sealink harlomes limited to chase manhatten bank N.A. to the chargee. Under the terms of the facility agreement dated 13/12/88 & an overdraft facility agreement dated 13/12/88 between sealink UK limited and barclays bank PLC
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    64 64TH shares in motorship "caedmon" registred under the british flag in the port of london with official no: 360676.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Chase Manhattan Bank N.A.
    ব্যবসায়
    • ০৪ জানু, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    Ships mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ডিসে, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জানু, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from sealink UK limited and/or sealink harloms limited to chase manhatten bank N.A. to the chargee. Under the terms of the facility agreement dated 13/12/88 & an overdraft facility agreement dated 13/12/88 between sealink UK limited and barclays bank PLC
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    64 64TH shares in motorship "cenwulf" registered under the british flag in the part of london with official no 360842.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Chase Manhattan Bank N.A.
    ব্যবসায়
    • ০৪ জানু, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    Ships mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ডিসে, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জানু, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from sealink UK limited and/or sealink harlous limited to chase manhatten bank N.A. to the chargee under the terms of the facility agreement dated 13/12/88 or an overdraft facility agreement dated 13/12/88 between sealink UK limited and barclays bank PLC
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    64 64TH chares in the motorship "cersed" registred under the british flag in the port of london with official number 360946.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Chase Manhattan Bank N.A.
    ব্যবসায়
    • ০৪ জানু, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    Deed of covenant
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুল, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ আগ, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due to the chargee under or pusuant to a loan agreement dated 16TH july 1985 supplemental to a mortgage dated 29TH july 1985
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the company's right, title & interest in & to all policies & contracts of insurance & all entries in a protection & indendity in respect of the vessel for full details see annexure on doc M26 for full details see annexure on doc M27.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citibank N.A.
    ব্যবসায়
    • ১৩ আগ, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    Deed of covenant
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুল, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ আগ, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due to the chargee under or pursuant to a loan agreement dated 16TH july 1985 supplemental to a mortgage dated 29TH july 1985
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the company's right, title & interest in & to all policies & contracts of insurance & all entries in a protection & indendity in respect of the vessel for full details see anneyure on doc M26.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citibank N.A.
    ব্যবসায়
    • ১৩ আগ, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    Deed of covenane
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুল, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ আগ, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to be-come due to the chargee under of pursuant to a loan agreement dated 16TH july 1985 supplemental to a mortgage dated 29TH july 1985
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the company's right, title & interest in & to all policies & contracts of insurance & all entries in a protection & indemnity in respect of the vessel for full details see doc M25.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citibank N.A.
    ব্যবসায়
    • ১৩ আগ, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    Ships mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুল, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ আগ, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due under and pursuant to a loan agreement dated 16TH july 1985
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    64/64TH shares in the motorship "cenred" - official no. 360946.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citibank N.A
    ব্যবসায়
    • ১৩ আগ, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    Ship mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুল, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ আগ, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due under and pursuant to a loan agreement dated 16TH july 1985
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    64/64TH shares in the motorship "cenwulf" official no 360842.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citibank N.A.
    ব্যবসায়
    • ১৩ আগ, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    Ships mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুল, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ আগ, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due under and pursuant to a loan agreement dated 16TH july 1985
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    64/64TH shares in the motorship "cardmon" - official no. 360676.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citibank N.A.
    ব্যবসায়
    • ১৩ আগ, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন

    WIGHTLINK HOLIDAYS LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২৪ ফেব, ২০১৬ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ০৮ ফেব, ২০১৭ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    অভ্যাসকারী
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    অভ্যাসকারী
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0