TOREX RETAIL ONLINE COMPUTER SERVICES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামTOREX RETAIL ONLINE COMPUTER SERVICES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01044892
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    TOREX RETAIL ONLINE COMPUTER SERVICES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7499) /

    TOREX RETAIL ONLINE COMPUTER SERVICES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    BENEDICT MACKENZIE
    62 Wilson Street
    EC2A 2BU London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    TOREX RETAIL ONLINE COMPUTER SERVICES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    ALPHAMERIC ONLINE COMPUTER SERVICES LIMITED১১ জুন, ২০০২১১ জুন, ২০০২
    ALPHAMERIC SOLUTIONS LIMITED০১ মার্চ, ১৯৯৬০১ মার্চ, ১৯৯৬
    ALPHAMERIC KEYBOARDS LIMITED০৬ মার্চ, ১৯৭২০৬ মার্চ, ১৯৭২

    TOREX RETAIL ONLINE COMPUTER SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ জুন, ২০০৭

    TOREX RETAIL ONLINE COMPUTER SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    3 পৃষ্ঠা4.71

    ১০ সেপ, ২০০৯ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ১১ সেপ, ২০০৮ তারিখে

    LRESSP

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    legacy

    1 পৃষ্ঠা190

    legacy

    1 পৃষ্ঠা353

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    হিসাব ৩০ জুন, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা225

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    TOREX RETAIL ONLINE COMPUTER SERVICES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    COOKSLEY, Graeme Roy
    Chamer Russweg 19
    6300 Zug
    Switzerland
    সচিব
    Chamer Russweg 19
    6300 Zug
    Switzerland
    New Zealander126903810001
    ISAACSON, Kirk Jeffrey, Mr.
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    পরিচালক
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    UsaOther123425810001
    HORN, Nigel David
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    সচিব
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    British109926660001
    ISAACSON, Kirk Jeffrey, Mr.
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    সচিব
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    Other123425810001
    JOHNSON, Robin Simon
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    সচিব
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    British11498320001
    JOHNSTON, John William
    Alremans Wylye Road
    Hanging Langford
    SP3 4NN Salisbury
    Wiltshire
    সচিব
    Alremans Wylye Road
    Hanging Langford
    SP3 4NN Salisbury
    Wiltshire
    British57851480001
    LEEK, Marcus
    7 Gloster Drive
    CV8 2TU Kenilworth
    Warwickshire
    সচিব
    7 Gloster Drive
    CV8 2TU Kenilworth
    Warwickshire
    British115960470001
    MINIKIN, Claire Louise
    Dunholme
    Manor Close
    KT24 6SA East Horsley
    Surrey
    সচিব
    Dunholme
    Manor Close
    KT24 6SA East Horsley
    Surrey
    British77770730001
    OLLIS, Stephen Anthony
    Cornerways 41 Sangers Drive
    RH6 8AL Horley
    Surrey
    সচিব
    Cornerways 41 Sangers Drive
    RH6 8AL Horley
    Surrey
    British64363660001
    SOULSBY, James Andrew
    Bramshott Lodge
    Woolmer Hill
    GU27 1QA Haslemere
    Surrey
    সচিব
    Bramshott Lodge
    Woolmer Hill
    GU27 1QA Haslemere
    Surrey
    British38342300002
    WARRINGTON, Lorri
    Applecroft
    Plaistow Road Ifold
    RH14 0TU Billingshurst
    West Sussex
    সচিব
    Applecroft
    Plaistow Road Ifold
    RH14 0TU Billingshurst
    West Sussex
    British84757210001
    BLACKBURNE, Geoffrey Robert
    14 Wheatears Drive
    West Wellow
    SO51 6RA Romsey
    Hampshire
    পরিচালক
    14 Wheatears Drive
    West Wellow
    SO51 6RA Romsey
    Hampshire
    British39171140001
    CANNING, Philip Francis
    63 Ivar Gardens
    Lychpit
    RG24 8YD Basingstoke
    Hampshire
    পরিচালক
    63 Ivar Gardens
    Lychpit
    RG24 8YD Basingstoke
    Hampshire
    British34793910001
    CANNING, Phillip Francis
    Roeside
    Bradshaw Lane, Chapel En Le Frith
    SK23 9UL High Peak
    Derbyshire
    পরিচালক
    Roeside
    Bradshaw Lane, Chapel En Le Frith
    SK23 9UL High Peak
    Derbyshire
    British70379550001
    COOKSLEY, Graeme
    19 Charmer Fussweg
    Zug
    6300
    Switzerland
    পরিচালক
    19 Charmer Fussweg
    Zug
    6300
    Switzerland
    New Zealander122786180001
    EVANS, David Victor
    Whiteside 99 Hatch Lane
    Old Basing
    RG24 7EG Basingstoke
    Hampshire
    পরিচালক
    Whiteside 99 Hatch Lane
    Old Basing
    RG24 7EG Basingstoke
    Hampshire
    British6221420001
    GREENOUGH, Michael
    711 Pintail Court
    Granbury
    Texas 76049
    Usa
    পরিচালক
    711 Pintail Court
    Granbury
    Texas 76049
    Usa
    Canadian123427350001
    HORN, Nigel David
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    British109926660001
    HORNSTEIN, Rodney Maxwell
    40 Fairfax Road
    NW6 4HA London
    পরিচালক
    40 Fairfax Road
    NW6 4HA London
    EnglandBritish4322180001
    JOHNSTON, David James
    33 Frensham Vale
    Lower Bourne
    GU10 3HS Farnham
    Surrey
    পরিচালক
    33 Frensham Vale
    Lower Bourne
    GU10 3HS Farnham
    Surrey
    EnglandBritish76164390001
    JOHNSTON, John William
    Alremans Wylye Road
    Hanging Langford
    SP3 4NN Salisbury
    Wiltshire
    পরিচালক
    Alremans Wylye Road
    Hanging Langford
    SP3 4NN Salisbury
    Wiltshire
    British57851480001
    LEEK, Marcus
    7 Gloster Drive
    CV8 2TU Kenilworth
    Warwickshire
    পরিচালক
    7 Gloster Drive
    CV8 2TU Kenilworth
    Warwickshire
    British115960470001
    MCLAREN, Michael Gerald
    October House 4 The Mount Drive
    RH2 0EZ Reigate
    Surrey
    পরিচালক
    October House 4 The Mount Drive
    RH2 0EZ Reigate
    Surrey
    EnglandBritish68561640002
    MEADE, Michael Gerald
    54 Clapham Common North Side
    SW4 9RX London
    পরিচালক
    54 Clapham Common North Side
    SW4 9RX London
    EnglandBritish,Irish142059750001
    MINIKIN, Claire Louise
    Dunholme
    Manor Close
    KT24 6SA East Horsley
    Surrey
    পরিচালক
    Dunholme
    Manor Close
    KT24 6SA East Horsley
    Surrey
    British77770730001
    MITCHELL, Robert Neil Whyte
    50 Leckford Road
    Jericho
    OX2 6HY Oxford
    Oxfordshire
    পরিচালক
    50 Leckford Road
    Jericho
    OX2 6HY Oxford
    Oxfordshire
    British116745740001
    MORCOMBE, Alan William
    Waverley House
    Kitcombe Wood
    GU34 3ND Faringdon
    Hampshire
    পরিচালক
    Waverley House
    Kitcombe Wood
    GU34 3ND Faringdon
    Hampshire
    British32807230004
    PEARMAN, Mark Chalice
    The Old Rectory
    Honiley
    CV8 1NP Kenilworth
    Warwickshire
    পরিচালক
    The Old Rectory
    Honiley
    CV8 1NP Kenilworth
    Warwickshire
    United KingdomBritish57516220003
    PRINCE, Ian Robert
    Underley Lodge Horsell Park
    GU21 4LY Woking
    Surrey
    পরিচালক
    Underley Lodge Horsell Park
    GU21 4LY Woking
    Surrey
    British29848090001
    PRINCE, Peter
    8 The Chase
    SL5 7UJ Ascot
    Berkshire
    পরিচালক
    8 The Chase
    SL5 7UJ Ascot
    Berkshire
    United States Of AmericaBritish125228870001
    RANDALL, Martin Keith
    Jacks Platt
    Duddleswell
    TN22 3JR Uckfield
    East Sussex
    পরিচালক
    Jacks Platt
    Duddleswell
    TN22 3JR Uckfield
    East Sussex
    United KingdomBritish40012240002
    SMITH, Kenneth Ronald
    Telconia Close
    Headley Down
    GU35 8ED Bordon
    7
    Hampshire
    পরিচালক
    Telconia Close
    Headley Down
    GU35 8ED Bordon
    7
    Hampshire
    United KingdomBritish34793900002
    SMITH, Kenneth Ronald
    Telconia Close
    Headley Down
    GU35 8ED Bordon
    7
    Hampshire
    পরিচালক
    Telconia Close
    Headley Down
    GU35 8ED Bordon
    7
    Hampshire
    United KingdomBritish34793900002
    TAYLOR, Keith Wilhall
    Dove Cottage
    Sly Corner Lee Common
    HP16 9LD Great Missenden
    Bucks
    পরিচালক
    Dove Cottage
    Sly Corner Lee Common
    HP16 9LD Great Missenden
    Bucks
    EnglandBritish119095470001
    THOMPSON, Richard James
    19 Fairfields Drive
    Ravenshead
    NG15 9HR Nottingham
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    19 Fairfields Drive
    Ravenshead
    NG15 9HR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish64550460002

    TOREX RETAIL ONLINE COMPUTER SERVICES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Fixed charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ ফেব, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ মার্চ, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All property rights in letters patent/trade mark/name with associated goodwill (please see doc 395 tc ref 353C for full details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ মার্চ, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৭ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ মে, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ মে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First fixed charge on all book and other debts. Floating charge on all the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ মে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৭ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Assignment
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ ফেব, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ মার্চ, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement dated 29/02/84
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All rights and interest in the lease dated 29/2/84 together with all monies now or hereafter to become payable under the lease and tog. With the benefit of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities taken by the company in connection with lease. (See doc. M23).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Security Pacific International Leasing (Europe) Inc.
    ব্যবসায়
    • ১৩ মার্চ, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ জানু, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ জানু, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All book and other debts now & from time to time owing to the company.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ জানু, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    Letter of instruction and charge.
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ ডিসে, ১৯৭৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ ডিসে, ১৯৭৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All and any sums of money owing or becoming due to the company from griffin factors limited under or by virtue of a factoring agreement executed by the company on 12 march 1979 or any other factoring agreement between the company and griffin factors limited.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ ডিসে, ১৯৭৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২১ অক্টো, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ মার্চ, ১৯৭৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ মার্চ, ১৯৭৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a factoring agreement dated 12 march 1979.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Floating charge over undertaking and all property present and future including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Griffin Factors Limited
    ব্যবসায়
    • ২২ মার্চ, ১৯৭৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২১ অক্টো, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    TOREX RETAIL ONLINE COMPUTER SERVICES LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১৯ ফেব, ২০১০ভেঙে গেছে
    ১১ সেপ, ২০০৮ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Simon James Underwood
    62 Wilson Street
    EC2A 2BU London
    অভ্যাসকারী
    62 Wilson Street
    EC2A 2BU London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0