TAH LTD

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামTAH LTD
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01080444
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    TAH LTD এর উদ্দেশ্য কী?

    • তথ্য প্রযুক্তি পরামর্শদাতা কার্যক্রম (62020) / তথ্য এবং যোগাযোগ

    TAH LTD কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    30 Factory Road Upton Industrial Estate
    Factory Road
    BH16 5SL Poole
    Dorset
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    TAH LTD এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    THE ACCOUNTING HOUSE CONSULTANCY SERVICES LIMITED১৯ সেপ, ১৯৮৯১৯ সেপ, ১৯৮৯
    THE ACCOUNTING HOUSE (SYSTEMS) LIMITED০৭ এপ্রি, ১৯৮৯০৭ এপ্রি, ১৯৮৯
    THE ACCOUNTING HOUSE (OFFICE SYSTEMS) LIMITED১২ সেপ, ১৯৮৮১২ সেপ, ১৯৮৮
    FARNHAM OFFICE SUPPLIES LIMITED ০৬ নভে, ১৯৭২০৬ নভে, ১৯৭২

    TAH LTD এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৫

    TAH LTD এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    TAH LTD এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    অডিট ছাড় সহায়ক হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    36 পৃষ্ঠাPARENT_ACC

    legacy

    1 পৃষ্ঠাAGREEMENT2

    legacy

    3 পৃষ্ঠাGUARANTEE2

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৬ মে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৩ জুন, ২০১৬

    ১৩ জুন, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    অডিট ছাড় সহায়ক হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    35 পৃষ্ঠাPARENT_ACC

    legacy

    1 পৃষ্ঠাAGREEMENT2

    legacy

    3 পৃষ্ঠাGUARANTEE2

    বার্ষিক রিটার্ন ১৬ মে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৯ মে, ২০১৫

    ২৯ মে, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    ০৩ মার্চ, ২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Winchfield Lodge Old Potbridge Road Winchfield Hook Hampshire RG27 8BT থেকে 30 Factory Road Upton Industrial Estate Factory Road Poole Dorset BH16 5SLপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ১৩ ফেব, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Philip Winston Louis এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৯ সেপ, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Ellen Whitter এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    20 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৬ মে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২১ মে, ২০১৪

    ২১ মে, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    পরিচালক হিসাবে Karl Anderson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Karl Anderson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    সচিব হিসাবে Mrs Tracey Jayne Shotliff-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    সচিব হিসাবে Karl Anderson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    22 পৃষ্ঠাAA

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর সংক্ষিপ্ত ৩১ মার্চ, ২০১৪ থেকে ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    TAH LTD এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    SHOTLIFF, Tracey Jayne
    Upton Industrial Estate
    Factory Road
    BH16 5SL Poole
    30 Factory Road
    Dorset
    England
    সচিব
    Upton Industrial Estate
    Factory Road
    BH16 5SL Poole
    30 Factory Road
    Dorset
    England
    185795310001
    CONWAY, Robert John
    Primavera, Village Street
    Goodworth Clatford
    SP11 7QX Andover
    Hampshire
    পরিচালক
    Primavera, Village Street
    Goodworth Clatford
    SP11 7QX Andover
    Hampshire
    EnglandBritish101064260001
    ANDERSON, Karl Vincent
    24 Wentworth Close
    RG45 6UL Crowthorne
    Berkshire
    সচিব
    24 Wentworth Close
    RG45 6UL Crowthorne
    Berkshire
    British57120660001
    JACKSON, Graham Richard
    5 Hawley Grove
    Blackwater
    GU17 9JY Camberley
    Surrey
    সচিব
    5 Hawley Grove
    Blackwater
    GU17 9JY Camberley
    Surrey
    British86738910001
    REES, Michael John David
    Farne House
    Court Barn Lane Birdham
    PO20 7BQ Chichester
    West Sussex
    সচিব
    Farne House
    Court Barn Lane Birdham
    PO20 7BQ Chichester
    West Sussex
    British3612460001
    ANDERSON, Karl Vincent
    24 Wentworth Close
    RG45 6UL Crowthorne
    Berkshire
    পরিচালক
    24 Wentworth Close
    RG45 6UL Crowthorne
    Berkshire
    EnglandBritish57120660001
    BALL, Christopher
    5 Campbell Close
    Yateley
    GU17 7GZ Camberley
    Surrey
    পরিচালক
    5 Campbell Close
    Yateley
    GU17 7GZ Camberley
    Surrey
    British48435680001
    BLIGHTMAN, Michael Charles
    18 King Stable Street
    Eton
    SL4 6AB Windsor
    Berkshire
    পরিচালক
    18 King Stable Street
    Eton
    SL4 6AB Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish4642670003
    BRANDON, Clive
    43 Russell Road
    Horsell
    GU21 4UU Woking
    Surrey
    পরিচালক
    43 Russell Road
    Horsell
    GU21 4UU Woking
    Surrey
    British96353010001
    DRAKE, Paul Douglas
    9 Wiggett Grove
    Binfield
    RG12 5DY Bracknell
    Berkshire
    পরিচালক
    9 Wiggett Grove
    Binfield
    RG12 5DY Bracknell
    Berkshire
    British36041180001
    DUNHAM, Jonathan Charles
    Penlee Blundel Lane
    Stoke Dabernon
    KT11 2SE Cobham
    Surrey
    পরিচালক
    Penlee Blundel Lane
    Stoke Dabernon
    KT11 2SE Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish35844940002
    HERRING, Malcolm William
    Eagles The Thatchway
    Rustington
    BN16 2BN Littlehampton
    West Sussex
    পরিচালক
    Eagles The Thatchway
    Rustington
    BN16 2BN Littlehampton
    West Sussex
    British4020970001
    INGHAM, Kevin Thomas
    153 Upper Welland Road
    WR14 4LB Malvern
    Worcestershire
    পরিচালক
    153 Upper Welland Road
    WR14 4LB Malvern
    Worcestershire
    British6059400003
    JACKSON, Graham Richard
    5 Hawley Grove
    Blackwater
    GU17 9JY Camberley
    Surrey
    পরিচালক
    5 Hawley Grove
    Blackwater
    GU17 9JY Camberley
    Surrey
    EnglandBritish86738910001
    LOUIS, Philip Winston
    The Street
    Aldermaston
    RG7 4LN Reading
    Brook House
    Berkshire
    England
    পরিচালক
    The Street
    Aldermaston
    RG7 4LN Reading
    Brook House
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish198912140001
    MORRIS, Brian
    28 Kings Hill
    Beech
    GU34 4AL Alton
    Hampshire
    পরিচালক
    28 Kings Hill
    Beech
    GU34 4AL Alton
    Hampshire
    British4020950001
    PELL, Michael
    23 Nightingale Road
    WD3 2DE Rickmansworth
    Hertfordshire
    পরিচালক
    23 Nightingale Road
    WD3 2DE Rickmansworth
    Hertfordshire
    British68128440002
    PRIDE, Michael
    23 Nightingale Road
    WD3 2DE Rickmansworth
    Hertfordshire
    পরিচালক
    23 Nightingale Road
    WD3 2DE Rickmansworth
    Hertfordshire
    British68128490001
    REES, Michael John David
    Farne House
    Court Barn Lane Birdham
    PO20 7BQ Chichester
    West Sussex
    পরিচালক
    Farne House
    Court Barn Lane Birdham
    PO20 7BQ Chichester
    West Sussex
    United KingdomBritish3612460001
    SILCOX, Benjamin Robert
    Melbourne Close
    AL3 6LU St. Albans
    25
    Hertfordshire
    England
    পরিচালক
    Melbourne Close
    AL3 6LU St. Albans
    25
    Hertfordshire
    England
    United Kingdom British 147139360001
    TORODE, Anne Elizabeth
    51 Staunton Avenue
    PO11 0EW Hayling Island
    Hampshire
    পরিচালক
    51 Staunton Avenue
    PO11 0EW Hayling Island
    Hampshire
    Irish57001360002
    WHITTER, Ellen
    Greenfield Way
    RG45 6TL Crowthorne
    15
    Berkshire
    England
    পরিচালক
    Greenfield Way
    RG45 6TL Crowthorne
    15
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish160031910001
    WILLIAMSON, Jennifer Ruth
    Littlebasing
    Old Basing
    RG24 8AX Basingstoke
    3a
    Hampshire
    England
    পরিচালক
    Littlebasing
    Old Basing
    RG24 8AX Basingstoke
    3a
    Hampshire
    England
    EnglandBritish118918240001

    TAH LTD এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ০২ মে, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ মে, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £28,000.00 and all other monies due or to become due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A deposit account of £28,000.00 plus vat and any other monies credited to that account from time to time.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Paramatric Technology (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ১১ মে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ অক্টো, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ সেপ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ অক্টো, ২০০১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ অক্টো, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ নভে, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ নভে, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to a fixed and floating charge dated 18TH may 1989
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ নভে, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ ফেব, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Credit agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ এপ্রি, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ মে, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £27481.65 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All its right, title and interest in and to all sums payable (see form 395 for full details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Close Brothers Limited
    ব্যবসায়
    • ১১ মে, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ ফেব, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ মে, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ মে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ মে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২০ ফেব, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ ফেব, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ মার্চ, ১৯৮৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital, book and other debts.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ মার্চ, ১৯৮৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২০ ফেব, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ জানু, ১৯৭৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ জানু, ১৯৭৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    50, downing street farnham surrey together with all fixtures.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ জানু, ১৯৭৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৯ ফেব, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0