TOTALFINA BITUMEN LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামTOTALFINA BITUMEN LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01093909
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    TOTALFINA BITUMEN LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    TOTALFINA BITUMEN LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    40 Clarendon Road
    Watford
    WD17 1TQ Hertfordshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    TOTALFINA BITUMEN LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    KELBIT LIMITED০২ ফেব, ১৯৭৩০২ ফেব, ১৯৭৩

    TOTALFINA BITUMEN LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১১

    TOTALFINA BITUMEN LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    সমিতির এবং সংবিধির নথি

    3 পৃষ্ঠাMA

    ১৭ অক্টো, ২০১২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ পরিবর্তনের রেজুলেশন

    RES01
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Capital redemption reserved cancelled & dividend paid 10/10/2012
    RES13

    ১০ এপ্রি, ২০১২ তারিখে Mr Eric Pierre Bozec-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    বার্ষিক রিটার্ন ২০ আগ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    ৩১ অক্টো, ২০১১ তারিখে সচিব হিসাবে Mrs Aminta Liliana Hall-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    ৩১ অক্টো, ২০১১ তারিখে সচিব হিসাবে Lee Ian Young এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    বার্ষিক রিটার্ন ২০ আগ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01

    ১৭ জুন, ২০১১ তারিখে Mr Didier Marie Gerard Harel-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২০ আগ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    ০১ জানু, ২০১০ তারিখে Mr Eric Pierre Bozec-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ জানু, ২০১০ তারিখে Mr Lee Ian Young-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    ০১ জানু, ২০১০ তারিখে Mr Didier Marie Gerard Harel-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    TOTALFINA BITUMEN LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    HALL, Aminta Liliana
    40 Clarendon Road
    Watford
    WD17 1TQ Hertfordshire
    সচিব
    40 Clarendon Road
    Watford
    WD17 1TQ Hertfordshire
    164416390001
    BOZEC, Eric Pierre
    40 Clarendon Road
    Watford
    WD17 1TQ Hertfordshire
    পরিচালক
    40 Clarendon Road
    Watford
    WD17 1TQ Hertfordshire
    United KingdomFrenchOil Company Executive130841580004
    HAREL, Didier Marie Gerard
    40 Clarendon Road
    Watford
    WD17 1TQ Hertfordshire
    পরিচালক
    40 Clarendon Road
    Watford
    WD17 1TQ Hertfordshire
    United KingdomFrenchOil Company Executive161050300001
    LONGLEY, Caryl Annette
    10 Elliot Avenue
    HA4 9LZ Ruislip
    Middlesex
    সচিব
    10 Elliot Avenue
    HA4 9LZ Ruislip
    Middlesex
    BritishSolicitor81303470001
    POYNTER, Russell Gerard
    13 Hopwood Close
    WD17 4LJ Watford
    Hertfordshire
    সচিব
    13 Hopwood Close
    WD17 4LJ Watford
    Hertfordshire
    British79276050002
    SYMONDS, Malcolm Francis
    The Cottage In The Park
    Ashtead Park
    KT21 1LE Ashtead
    Surrey
    সচিব
    The Cottage In The Park
    Ashtead Park
    KT21 1LE Ashtead
    Surrey
    British12463760001
    YOUNG, Lee Ian
    40 Clarendon Road
    Watford
    WD17 1TQ Hertfordshire
    সচিব
    40 Clarendon Road
    Watford
    WD17 1TQ Hertfordshire
    BritishSolicitor132535290001
    BLEASDALE, David
    21 Stokenchurch Street
    SW6 3TS London
    পরিচালক
    21 Stokenchurch Street
    SW6 3TS London
    BritishOil Company Executive83334490001
    GILLESPIE, John
    Scarthmead
    Scarthill Lane
    L40 6HA Ormskirk
    Lancashire
    পরিচালক
    Scarthmead
    Scarthill Lane
    L40 6HA Ormskirk
    Lancashire
    BritishBitumen Company Executive75992790001
    GRONOW, Stephen John
    7 Mellor Brow
    Mellor
    BB2 7EX Blackburn
    Lancashire
    পরিচালক
    7 Mellor Brow
    Mellor
    BB2 7EX Blackburn
    Lancashire
    United KingdomBritishSales Executive29610380001
    HILL, Roland Leslie
    3 Powell Drive
    Billinge
    WN5 7RX Wigan
    Lancashire
    পরিচালক
    3 Powell Drive
    Billinge
    WN5 7RX Wigan
    Lancashire
    BritishIndustrial Chemist17635590002
    HURLEY, John David
    9 Firbank Road
    AL3 6NA St Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    9 Firbank Road
    AL3 6NA St Albans
    Hertfordshire
    BritishOil Company Executive12463770001
    HUTCHISON, Pierre
    Wayside Cottage
    Newbury Street Kintbury
    RG17 9UU Hungerford
    Berkshire
    পরিচালক
    Wayside Cottage
    Newbury Street Kintbury
    RG17 9UU Hungerford
    Berkshire
    EnglandFrenchOil Company Executive90759620002
    JOHNSTON, Ian Campbell
    Dalefields
    Chelford
    SK11 9AH Macclesfield
    Cheshire
    পরিচালক
    Dalefields
    Chelford
    SK11 9AH Macclesfield
    Cheshire
    BritishBitumen Company Executive27700460001
    JONES, Charles Gary
    Little Ethorpe
    76 Packhorse Road
    SL9 8HY Gerrards Cross
    পরিচালক
    Little Ethorpe
    76 Packhorse Road
    SL9 8HY Gerrards Cross
    BritishOil Company Executive78602130001
    JONES, Malcolm Frederick
    16 Gade Avenue
    WD18 7LG Watford
    Hertfordshire
    পরিচালক
    16 Gade Avenue
    WD18 7LG Watford
    Hertfordshire
    BritishOil Co Exec54377090001
    LONGLEY, Caryl Annette
    10 Elliot Avenue
    HA4 9LZ Ruislip
    Middlesex
    পরিচালক
    10 Elliot Avenue
    HA4 9LZ Ruislip
    Middlesex
    BritishSolicitor81303470001
    NICHOLLS, Peter Harrison
    Warrenfield
    Bengeo Street
    SG14 3ES Hertford
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Warrenfield
    Bengeo Street
    SG14 3ES Hertford
    Hertfordshire
    EnglandBritishOil Company Executive14348610001
    SYMONDS, Malcolm Francis
    The Cottage In The Park
    Ashtead Park
    KT21 1LE Ashtead
    Surrey
    পরিচালক
    The Cottage In The Park
    Ashtead Park
    KT21 1LE Ashtead
    Surrey
    BritishSolicitor12463760001
    WARING, Michael Holburt
    12 Stonemead Avenue
    Halebarns
    WA15 0BQ Altrincham
    Cheshire
    পরিচালক
    12 Stonemead Avenue
    Halebarns
    WA15 0BQ Altrincham
    Cheshire
    BritishOil76761390001

    TOTALFINA BITUMEN LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Credit agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০১ মে, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ মে, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the credit application dated 1.5.90.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All its right, title and interest in and to all sums under the insurances as listed on doc M251C.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Close Brothers Limited
    ব্যবসায়
    • ১৬ মে, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৬ সেপ, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Chattels mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০১ এপ্রি, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ এপ্রি, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All and singualr the chattels, plant and machinery and items described in the schedule one slurry seal machiney serial no:- 860020 together with anxilliary equipment two pallets together with anxilliary equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Forward Trust Limited.
    ব্যবসায়
    • ০৩ এপ্রি, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৬ সেপ, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১০ সেপ, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ সেপ, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land & premises at edge green road goldborne greater manchester & the goodwill of the business.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Total Oil Great Britain Limited
    ব্যবসায়
    • ১৩ সেপ, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৬ আগ, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ ফেব, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ ফেব, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Total Oil Great Britain Limited
    ব্যবসায়
    • ২৯ ফেব, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৬ আগ, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ফেব, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ফেব, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (See doc M28). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    ব্যবসায়
    • ২২ ফেব, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০১ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ ডিসে, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ ডিসে, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a factoring agreement dated 1/12/82
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge over all book debts & other debts.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Kellock Factors Limited
    ব্যবসায়
    • ১৬ ডিসে, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৬ সেপ, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ মে, ১৯৭৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ মে, ১৯৭৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Lease hold warehouse, land and buildings at edge green road, near wigan with all fixtures in a lease dated 25TH june 1975.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    ব্যবসায়
    • ০৭ মে, ১৯৭৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০১ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২১ জুল, ১৯৭৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ জুল, ১৯৭৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of a first fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. Together with all fixtures whatsoever for details see doc M24.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    ব্যবসায়
    • ২৯ জুল, ১৯৭৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০১ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0