ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01129454
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • ভবন নির্মাণ প্রকল্প উন্নয়ন (41100) / নির্মাণ

    ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    180 Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    United Kingdom
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES PLC১৬ আগ, ১৯৭৩১৬ আগ, ১৯৭৩

    ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৮

    ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    1 পৃষ্ঠাDS01

    চার্জ 011294540025 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 011294540026 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    ৩১ ডিসে, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Michael Ben Jenkins এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১০ মে, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ১৩ ফেব, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Philip Simon Slavin-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    legacy

    2 পৃষ্ঠাSH20

    ১৩ ডিসে, ২০১৯ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    5 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    The company capital redemption reserve account of the company be cancelled 09/12/2019
    RES13

    ০৭ নভে, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Angus Alexander Dodd এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ছোট কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    18 পৃষ্ঠাAA

    ১০ মে, ২০১৯ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    ছোট কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    18 পৃষ্ঠাAA

    ১০ মে, ২০১৮ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    legacy

    2 পৃষ্ঠাSH20

    ০৩ এপ্রি, ২০১৮ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    5 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    2 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    3 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Share premium a/c cancelled 12/03/2018
    RES13

    ১৫ ফেব, ২০১৮ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    5 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    2 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    HEAZELL, Frances Victoria
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    সচিব
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    215875630001
    SAUNDERS, James Michael Edward
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    পরিচালক
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    EnglandBritish192568400002
    SLAVIN, Philip Simon
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    পরিচালক
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    United KingdomBritish267205160001
    DIXON, Susan Elizabeth
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    সচিব
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    British90007990001
    EASTWOOD, Charlotte Ind
    16 Edna Street
    SW11 3DP London
    সচিব
    16 Edna Street
    SW11 3DP London
    British50099790003
    GIBSON, Timothy David
    52a Grenville Road
    N19 4EH London
    সচিব
    52a Grenville Road
    N19 4EH London
    British50070710001
    HUGHES, Paul
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    সচিব
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    British23950030001
    ODELL, Sandra Judith
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    সচিব
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    175104150001
    ROBSON SKEETE, Gail
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    সচিব
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    British66939460001
    ROBSON SKEETE, Gail
    17 Field Close
    Locks Heath
    SO31 6TX Southampton
    Hampshire
    সচিব
    17 Field Close
    Locks Heath
    SO31 6TX Southampton
    Hampshire
    British58498140001
    WOOLLEY, Peter Thomas Griffith
    2 Fernsleigh Close
    SL9 0HR Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    সচিব
    2 Fernsleigh Close
    SL9 0HR Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British39676720001
    WORTHINGTON, Rebecca Jane
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    সচিব
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    British130493170001
    AL-SAGER, Mohammed Jassem
    Dahiyat Abdullah Al Salem
    Area 4 Street No 43 Viilla 24
    FOREIGN Kuwait City Kuwaiti
    পরিচালক
    Dahiyat Abdullah Al Salem
    Area 4 Street No 43 Viilla 24
    FOREIGN Kuwait City Kuwaiti
    British36413770001
    ARRA, Giorgio
    26 Hereford House
    66 North Row
    W1R 1DE London
    পরিচালক
    26 Hereford House
    66 North Row
    W1R 1DE London
    Italian71142090001
    BROOKER, Alfred Thomas
    Crispin
    The Approach, Dormans Park
    RH19 3NU East Grinstead
    West Sussex
    পরিচালক
    Crispin
    The Approach, Dormans Park
    RH19 3NU East Grinstead
    West Sussex
    EnglandBritish29444930001
    CARTER, Simon Geoffrey
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    পরিচালক
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritish184444990001
    CLARK, James Robert
    Logmore 37 The Avenue
    SM2 7QA Cheam
    Surrey
    পরিচালক
    Logmore 37 The Avenue
    SM2 7QA Cheam
    Surrey
    United KingdomBritish52063220001
    DEAR, Michael Raymond
    16 Calvin Close
    GU15 1DN Camberley
    Surrey
    পরিচালক
    16 Calvin Close
    GU15 1DN Camberley
    Surrey
    British11171470001
    DODD, Angus Alexander
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    পরিচালক
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    EnglandBritish201606390001
    DUGDALE, Edward Stratford
    Tickwood Hall
    TF13 6NZ Much Wenlock
    Shropshire
    পরিচালক
    Tickwood Hall
    TF13 6NZ Much Wenlock
    Shropshire
    EnglandBritish35942980003
    DWYER, Tonianne
    170 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7JG London
    পরিচালক
    170 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7JG London
    United KingdomAustralian94124780001
    ELLIS, Nigel George
    Willmead Farm
    Bovey Tracey
    TQ13 9NP Newton Abbot
    Devon
    পরিচালক
    Willmead Farm
    Bovey Tracey
    TQ13 9NP Newton Abbot
    Devon
    British14185110002
    GAVAGHAN, David Nicholas
    16 Grosvenor Street
    London
    W1K 4QF
    পরিচালক
    16 Grosvenor Street
    London
    W1K 4QF
    United KingdomBritish151855940001
    GREENSLADE, Daniel Mark
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    পরিচালক
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    EnglandBritish196504990001
    HAMILTON STUBBER, James Robert
    1 The Regency
    Hide Place
    SW1P 4HD London
    পরিচালক
    1 The Regency
    Hide Place
    SW1P 4HD London
    United KingdomBritish84913850002
    HOOPER, Patrick Paul
    Thornfield 92 Station Road
    Balsall Common
    CV7 7FL Coventry
    West Midlands
    পরিচালক
    Thornfield 92 Station Road
    Balsall Common
    CV7 7FL Coventry
    West Midlands
    British455570001
    JAMES, Maxwell David Shaw
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    পরিচালক
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    EnglandBritish164108510003
    JENKINS, Michael Ben
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    পরিচালক
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    United KingdomBritish221017630001
    KATZ, Jonathan
    60 Mount Ephraim Lane
    SW16 1JD London
    পরিচালক
    60 Mount Ephraim Lane
    SW16 1JD London
    EnglandBritish33805490001
    KNIGHT, Eric
    7 Boulevard Des Moulins
    MC9800 Monaco
    পরিচালক
    7 Boulevard Des Moulins
    MC9800 Monaco
    Italian55114600003
    LAZARUS, James Nicholas
    Misbourne 47 Foxdell Way
    Chalfont St Peter
    SL9 0PL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Misbourne 47 Foxdell Way
    Chalfont St Peter
    SL9 0PL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish8315580001
    PARRY, John Richard
    High Barn The Paddocks
    Dog Kennel Lane
    WD3 5EE Chorleywood
    Hertfordshire
    পরিচালক
    High Barn The Paddocks
    Dog Kennel Lane
    WD3 5EE Chorleywood
    Hertfordshire
    British2995850001
    RILEY, Michael Edward
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    পরিচালক
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    British94724020002
    SANDERSON, Eric Fenton
    10 Harelaw Road
    EH13 0DR Edinburgh
    Midlothian
    পরিচালক
    10 Harelaw Road
    EH13 0DR Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish126848980001
    SHATTOCK, Nicholas Simon Keith
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    পরিচালক
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    EnglandBritish43632680001

    ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    না
    আইনি ফর্মLimited By Shares
    নিবন্ধিত দেশEngland And Wales
    আইনি কর্তৃপক্ষUnited Kingdom (England And Wales)
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর2694983
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ নভে, ২০১৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ নভে, ২০১৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    None.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Homes and Communities Agency
    ব্যবসায়
    • ০৭ নভে, ২০১৭একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ১৮ জানু, ২০২১একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ নভে, ২০১৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ নভে, ২০১৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Wells Fargo Bank, N.A., London Branch, 90 Long Acre, London, WC2E 9RA (As Common Security Agent for Each of the Secured Parties)
    ব্যবসায়
    • ১৫ নভে, ২০১৬একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ১৮ জানু, ২০২১একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Floating charge security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ মার্চ, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ মার্চ, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and each other chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First floating charge all its assets see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC (The "Security Agent")
    ব্যবসায়
    • ১৭ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ অক্টো, ২০১৬একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ ফেব, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ ফেব, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise ffectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    ব্যবসায়
    • ১৫ ফেব, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    A security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জানু, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ ফেব, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise effectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    ব্যবসায়
    • ০৭ ফেব, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    A security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জানু, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ ফেব, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All rights under any hedging arrangements. By way of floating charge all assets not effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment under the charge. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Capital as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    ব্যবসায়
    • ০১ ফেব, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২২ অক্টো, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ অক্টো, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The company assigns all of its rights under any hedging arrangements; a first floating charge all its assets not at any time otherwise effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    ব্যবসায়
    • ২৫ অক্টো, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ অক্টো, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ নভে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of a first floating charge all its assets not at any time othererwise effectively mortgages charged of assigned. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১১ নভে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ অক্টো, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ নভে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of a first floating charge all its assets not at any time othererwise effectively mortgages charged of assigned. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১১ নভে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage by way of assignment
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ মার্চ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ মার্চ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a legal mortgage dated 25TH march 1999
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the company's rights title and interest in and to a building contract dated 4TH october 1999 made between holmes building PLC (1) and the company (2) (the "building contract").. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Wales PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ মার্চ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ মার্চ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ মার্চ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property k/a land lying to the north of holloway lane harmondsworth hillingdon t/n AGL17932 along with the goodwill of any business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Wales PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ মার্চ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ ডিসে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ ডিসে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever except for any obligation which, if it were so included, would result in a contravention of section 151 of the companies act 1985
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ ডিসে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ মে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ মে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    22 buckingham gate l/b of city of westminster t/n 61747.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ মে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ জানু, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জানু, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H mevile house 8 10 & 12 woodhouse road finchley london N3 t/n NGL429496.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The British Linen Bank Limited
    ব্যবসায়
    • ১৭ জানু, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ ফেব, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ ফেব, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    29 buckingham gate, l/b of city of westminster t/no: 44712.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ ফেব, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Shares charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ জানু, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ জানু, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under each of a credit agreement of even date,the debenture dated 26TH january 1995,the subordination deed dated 23RD january 1995 and this charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    100 ordinary shares of £1 each fully paid up and 50,000 ordinary £1 shares paid up as to 25 pence each in the issued capital; all other shares in english & overseas investments PLC.......all stocks,shares and other securities.............etc.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Deutsche Pfandbrief-Und Hypothekenbank Aktiengesellschaft
    ব্যবসায়
    • ৩১ জানু, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ এপ্রি, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    77 st john street, london EC1.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The British Linen Bank Limited
    ব্যবসায়
    • ০৬ মে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১০ এপ্রি, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ এপ্রি, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The coalyard marsh lane hampton in arden west midlands t/n wm 441272.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ এপ্রি, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১০ এপ্রি, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ এপ্রি, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Enterprise house fentham road hampton in arden west midlands t/nos: wm 294348 & wm 439700.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ এপ্রি, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ জুল, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ জুল, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or blegberry limited to the chargee on any account whatsoever.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a 94 & 94A st john's wood high street london NW8 T.N. ln 104564.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ জুল, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ জুল, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ জুল, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    28/30 coppergate york north yorkshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ জুল, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ জুল, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ জুল, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    5/6 horsemarket darlington durham. Title no:- du 22186.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ জুল, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ জুল, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ জুল, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land at pembroke park waterbeach cambridge cambridgeshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ জুল, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ জুল, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ জুল, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land at maskell road and garratt lane l/b of wandsworth.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ জুল, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ জুল, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ জুল, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    17 st sepulchre gate doncaster south yorkshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ জুল, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0