HENDERSON-BOSTWICK INDUSTRIAL DOORS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামHENDERSON-BOSTWICK INDUSTRIAL DOORS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01129675
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    HENDERSON-BOSTWICK INDUSTRIAL DOORS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (2875) /

    HENDERSON-BOSTWICK INDUSTRIAL DOORS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Halesfield 4
    Telford
    TF7 4AP Salop
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    HENDERSON-BOSTWICK INDUSTRIAL DOORS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    BOSTWICK INTERNATIONAL LIMITED৩১ ডিসে, ১৯৭৬৩১ ডিসে, ১৯৭৬
    FAYLONG LIMITED১৭ আগ, ১৯৭৩১৭ আগ, ১৯৭৩

    HENDERSON-BOSTWICK INDUSTRIAL DOORS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ জুন, ২০১০

    HENDERSON-BOSTWICK INDUSTRIAL DOORS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ জুন, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    সচিব হিসাবে Mr Nigel Homer-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ জুল, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০২ আগ, ২০১০

    ০২ আগ, ২০১০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 500,000
    SH01

    সচিব হিসাবে Mr Nigel Homer-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    সচিব হিসাবে David Ratcliffe এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    পরিচালক হিসাবে Paul Andrews এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    সচিব হিসাবে Paul Andrews এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ জুন, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ জুন, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ জুন, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    2 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    হিসাব ৩০ জুন, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    7 পৃষ্ঠা363s

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    হিসাব ৩০ জুন, ২০০৫ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    6 পৃষ্ঠা363s

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    HENDERSON-BOSTWICK INDUSTRIAL DOORS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    HOMER, Nigel
    Halesfield 4
    Telford
    TF7 4AP Salop
    সচিব
    Halesfield 4
    Telford
    TF7 4AP Salop
    153564400001
    HOMER, Nigel
    Halesfield 4
    Telford
    TF7 4AP Salop
    সচিব
    Halesfield 4
    Telford
    TF7 4AP Salop
    153117000001
    FARBER, Peter
    Huntsmans Close
    WV16 5BE Bridgnorth
    13
    Shropshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Huntsmans Close
    WV16 5BE Bridgnorth
    13
    Shropshire
    United Kingdom
    EnglandSwissDirector And Economist107121150002
    ANDREWS, Paul
    15 The Knotches
    Seifton Batch
    SY7 9LQ Craven Arms
    Shropshire
    সচিব
    15 The Knotches
    Seifton Batch
    SY7 9LQ Craven Arms
    Shropshire
    BritishFinancial Director111433100002
    BRINDLEY, Peter Henry
    1 Albany Close
    West Bergholt
    CO6 3LE Colchester
    Essex
    সচিব
    1 Albany Close
    West Bergholt
    CO6 3LE Colchester
    Essex
    British11552730001
    FARMER, Owen Michael
    17 Kingsclear Park
    GU15 2LS Camberley
    Surrey
    সচিব
    17 Kingsclear Park
    GU15 2LS Camberley
    Surrey
    BritishDirector57247560001
    KEABLE, Alan James
    1 Heron Avenue
    SK16 5QB Dukinfield
    Cheshire
    সচিব
    1 Heron Avenue
    SK16 5QB Dukinfield
    Cheshire
    British53512330001
    MCGARRY, Stephen
    5 Ashurst Drive
    S6 5LL Sheffield
    South Yorkshire
    সচিব
    5 Ashurst Drive
    S6 5LL Sheffield
    South Yorkshire
    BritishFinance Director43205150001
    NEATH, Kerry Daniel
    71 Conway Drive
    Shepshed
    LE12 9PP Loughborough
    Leicestershire
    সচিব
    71 Conway Drive
    Shepshed
    LE12 9PP Loughborough
    Leicestershire
    BritishCompany Director35102000002
    RATCLIFFE, David Morley
    3 Woodberry Avenue
    North Harrow
    HA2 6AU Harrow
    Middlesex
    সচিব
    3 Woodberry Avenue
    North Harrow
    HA2 6AU Harrow
    Middlesex
    British15520590001
    ANDREWS, Paul
    15 The Knotches
    Seifton Batch
    SY7 9LQ Craven Arms
    Shropshire
    পরিচালক
    15 The Knotches
    Seifton Batch
    SY7 9LQ Craven Arms
    Shropshire
    EnglandBritishFinancial Director111433100002
    DAVIES, David
    Ribendell
    39 Woodlands Drive
    CW4 8JH Goostrey
    Cheshire
    পরিচালক
    Ribendell
    39 Woodlands Drive
    CW4 8JH Goostrey
    Cheshire
    BritishDirector72615990001
    DE MARGARY, Bridget Joanna Maria Margaret
    33 Clapham Common
    Northside
    SW4 0RW London
    পরিচালক
    33 Clapham Common
    Northside
    SW4 0RW London
    EnglandBritishCompany Director1380360002
    FARMER, Owen Michael
    17 Kingsclear Park
    GU15 2LS Camberley
    Surrey
    পরিচালক
    17 Kingsclear Park
    GU15 2LS Camberley
    Surrey
    EnglandBritishDirector57247560001
    HALL, David Graham
    Hook Farm
    Bunce Common Road
    RH2 8NS Leigh
    Surrey
    পরিচালক
    Hook Farm
    Bunce Common Road
    RH2 8NS Leigh
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director95446610001
    HOLLOWAY, David John
    25 Edgar Road
    St Cross
    SO23 9TN Winchester
    Hampshire
    পরিচালক
    25 Edgar Road
    St Cross
    SO23 9TN Winchester
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director66183100001
    IRWIN, John David
    Seeleys Orchard 39 Penn Road
    HP9 2LN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Seeleys Orchard 39 Penn Road
    HP9 2LN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector59361420001
    JACQUES, Anthony
    51 Huntly Road
    Talbot Woods
    BH3 7HG Bournemouth
    Dorset
    পরিচালক
    51 Huntly Road
    Talbot Woods
    BH3 7HG Bournemouth
    Dorset
    BritishCompany Director24972030001
    JOWICZ, John Peter
    5 Rushes Mill Foxglove Meadows
    Pelsall
    WS3 4QU Walsall
    West Midlands
    পরিচালক
    5 Rushes Mill Foxglove Meadows
    Pelsall
    WS3 4QU Walsall
    West Midlands
    BritishFinance Director74250200001
    MARTIN, David Ernest
    20 St Johns Crescent
    CM24 8JT Stansted
    Essex
    পরিচালক
    20 St Johns Crescent
    CM24 8JT Stansted
    Essex
    BritishCompany Director31053760001
    MCGARRY, Stephen
    5 Ashurst Drive
    S6 5LL Sheffield
    South Yorkshire
    পরিচালক
    5 Ashurst Drive
    S6 5LL Sheffield
    South Yorkshire
    BritishFinance Director43205150001
    NEATH, Kerry Daniel
    71 Conway Drive
    Shepshed
    LE12 9PP Loughborough
    Leicestershire
    পরিচালক
    71 Conway Drive
    Shepshed
    LE12 9PP Loughborough
    Leicestershire
    BritishCompany Director35102000002
    PEARSON, John Christopher
    58 Millford Avenue
    Urmston
    M41 6JZ Manchester
    Lancashire
    পরিচালক
    58 Millford Avenue
    Urmston
    M41 6JZ Manchester
    Lancashire
    BritishCompany Director20587330001
    ROGERS, David
    Rose Cottage
    Church Eaton
    ST20 0AX Stafford
    Staffordshire
    পরিচালক
    Rose Cottage
    Church Eaton
    ST20 0AX Stafford
    Staffordshire
    United KingdomBritishAccountant34813700001
    SENIOR, Ronald George
    Stable Lodge Church Lane
    Pavenham
    MK43 7PU Bedford
    Bedfordshire
    পরিচালক
    Stable Lodge Church Lane
    Pavenham
    MK43 7PU Bedford
    Bedfordshire
    BritishDirector6893660001
    SWALLOW, Jake Brangwyn Sheridan
    Brickhill House
    North Oakley
    RG26 5TT Tadley
    Hampshire
    পরিচালক
    Brickhill House
    North Oakley
    RG26 5TT Tadley
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director1483180001

    HENDERSON-BOSTWICK INDUSTRIAL DOORS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture between the chargor kaba holdings ag as the parent and the security agent
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ এপ্রি, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ এপ্রি, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys and liabilities due owing or incurred to the secured parties (or any of them) (as defined) by the obligors (as defined) under the finance documents (or any of them) (as defined) on any account whatsoever pursuant to any of the finance documents
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ubs Ag Zurich as Security Agent and Trustee for Itself and the Othersecured Parties (The Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ২০ এপ্রি, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ নভে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ জুল, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ জুল, ১৯৯৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ জুল, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ এপ্রি, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ মে, ১৯৯৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £3,500.00 due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/Hold premises - wharf rd,pinxton,bolsover,derbyshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Concord PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ মে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ এপ্রি, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ মে, ১৯৯৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £36,500.00 due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/Hold premises - somercotes grange close,clover nook industrial estate,normanton.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Concord PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ মে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ এপ্রি, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ মে, ১৯৯৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £36,500.00 due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/Hold premises known as bletchley rd,stockport,gt.manchester.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Concord PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ মে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ ফেব, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ ফেব, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৯ ফেব, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ মে, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0