DISS FASTENERS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামDISS FASTENERS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01131911
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    DISS FASTENERS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (5190) /

    DISS FASTENERS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Anixter House
    1 York Road
    UB8 1RN Uxbridge
    Middlesex
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    DISS FASTENERS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    DISS FASTENER MANUFACTURING COMPANY (NORFOLK) LIMITED(THE)৩০ আগ, ১৯৭৩৩০ আগ, ১৯৭৩

    DISS FASTENERS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে০২ জানু, ২০১১

    DISS FASTENERS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    পূর্ণ হিসাব ০২ জানু, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৯ মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২১ মার্চ, ২০১১

    ২১ মার্চ, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 15,000
    SH01

    সচিব হিসাবে Mr. James Hugh Ellis-Rees-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    পরিচালক হিসাবে Mr. James Hugh Ellis-Rees-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Alexandra Vaizey এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    সচিব হিসাবে Alexandra Vaizey এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ০১ জানু, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৯ মার্চ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে William Robert Banks-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Alexandra Mary Jane Vaizey-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Alexandra Mary Jane Vaizey-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    পূর্ণ হিসাব ০২ জানু, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    16 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ২৮ ডিসে, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    18 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা225

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    3 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    3 পৃষ্ঠা288a

    DISS FASTENERS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    ELLIS-REES, James Hugh, Mr.
    Anixter House
    1 York Road
    UB8 1RN Uxbridge
    Middlesex
    সচিব
    Anixter House
    1 York Road
    UB8 1RN Uxbridge
    Middlesex
    156649310001
    BANKS, William Robert
    Anixter House
    1 York Road
    UB8 1RN Uxbridge
    Middlesex
    পরিচালক
    Anixter House
    1 York Road
    UB8 1RN Uxbridge
    Middlesex
    United KingdomBritishDirector31507290001
    ELLIS-REES, James Hugh, Mr.
    Anixter House
    1 York Road
    UB8 1RN Uxbridge
    Middlesex
    পরিচালক
    Anixter House
    1 York Road
    UB8 1RN Uxbridge
    Middlesex
    EnglandBritishSolicitor156071390001
    BALL, Kenneth Martin
    Arundel 14 De Lucy Close
    IP22 3YL Diss
    Norfolk
    সচিব
    Arundel 14 De Lucy Close
    IP22 3YL Diss
    Norfolk
    British1571960001
    HOMAN-RUSSELL, William Barry
    Heath Barn Cottage Hampers Lane
    Storrington
    RH20 3HY Pulborough
    West Sussex
    সচিব
    Heath Barn Cottage Hampers Lane
    Storrington
    RH20 3HY Pulborough
    West Sussex
    BritishEngineer1227500001
    RILEY, Joseph Kenneth Michael
    22 Fairhaven
    CW2 5GG Wychwood Park
    Cheshire
    সচিব
    22 Fairhaven
    CW2 5GG Wychwood Park
    Cheshire
    BritishChartered Accountant154381500001
    VAIZEY, Alexandra Mary Jane
    Anixter House
    1 York Road
    UB8 1RN Uxbridge
    Middlesex
    সচিব
    Anixter House
    1 York Road
    UB8 1RN Uxbridge
    Middlesex
    BritishDirector83460130003
    AIKEN, William John, Mr.
    55 Lynch Hill Park
    RG28 7NF Whitchurch
    Hampshire
    পরিচালক
    55 Lynch Hill Park
    RG28 7NF Whitchurch
    Hampshire
    United KingdomBritishChartered Accountant40553130001
    BALL, Jane Elizabeth
    Arundel 14 De Lucy Close
    IP22 3YL Diss
    Norfolk
    পরিচালক
    Arundel 14 De Lucy Close
    IP22 3YL Diss
    Norfolk
    BritishCompany Director1571970001
    BALL, Kenneth Martin
    Arundel 14 De Lucy Close
    IP22 3YL Diss
    Norfolk
    পরিচালক
    Arundel 14 De Lucy Close
    IP22 3YL Diss
    Norfolk
    BritishCompany Director1571960001
    BARKER, Martin Raymond
    20 Saint Andrews Road
    Scole
    IP21 4DU Diss
    Norfolk
    পরিচালক
    20 Saint Andrews Road
    Scole
    IP21 4DU Diss
    Norfolk
    BritishGeneral Manager68382050001
    CURSON, Paul Nigel
    The Flint Barn 6 Upper House Farm
    Woodlands, Bramdean
    SO24 0HW Alresford
    Hampshire
    পরিচালক
    The Flint Barn 6 Upper House Farm
    Woodlands, Bramdean
    SO24 0HW Alresford
    Hampshire
    BritishChartered Accountant67639640001
    FORMBY, Paul Madders
    Grange Hall
    The Grange
    GY1 2QJ St Peter Port
    Guernsey
    পরিচালক
    Grange Hall
    The Grange
    GY1 2QJ St Peter Port
    Guernsey
    BritishBusiness Consultant87104890001
    FROST, Paul Douglas
    Links Edge 5 Cornfield Road
    Romiley
    SK6 4LU Stockport
    Cheshire
    পরিচালক
    Links Edge 5 Cornfield Road
    Romiley
    SK6 4LU Stockport
    Cheshire
    EnglandBritishGeneral Manager9386150003
    HOMAN-RUSSELL, William Barry
    Heath Barn Cottage Hampers Lane
    Storrington
    RH20 3HY Pulborough
    West Sussex
    পরিচালক
    Heath Barn Cottage Hampers Lane
    Storrington
    RH20 3HY Pulborough
    West Sussex
    EnglandBritishEngineer1227500001
    RILEY, Joseph Kenneth Michael
    22 Fairhaven
    CW2 5GG Wychwood Park
    Cheshire
    পরিচালক
    22 Fairhaven
    CW2 5GG Wychwood Park
    Cheshire
    EnglandBritishChartered Accountant154381500001
    VAIZEY, Alexandra Mary Jane
    Anixter House
    1 York Road
    UB8 1RN Uxbridge
    Middlesex
    পরিচালক
    Anixter House
    1 York Road
    UB8 1RN Uxbridge
    Middlesex
    United KingdomBritishDirector83460130003

    DISS FASTENERS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ আগ, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ আগ, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Enterprise Finance Europe (UK) LTD
    ব্যবসায়
    • ১১ আগ, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ মে, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ ডিসে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ ডিসে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ups Capital UK LTD
    ব্যবসায়
    • ১৩ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ ফেব, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed and floating charge over all assets
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ এপ্রি, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ এপ্রি, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H and l/h property present and future and all buildings and fixtures, all shares and securities whatsoever held by the company together with all rights benefits and advantages all moneys payable to the company and all other rights the company may have under a business finance agreement dated 12 march 2001...all right title property and interest (if any) that the company may have in and to the debts and to the related rights.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Nmb-Heller Limited
    ব্যবসায়
    • ২৭ এপ্রি, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩১ জানু, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    A composite guarantee and debenture ( the "deed")
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ মার্চ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ এপ্রি, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies obligations and liabilities for the time being due owing or incurred by the company to the chargee the beneficiaries or any of them under or in connection with the loan note instrument (all terms as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited as Security Trustee
    ব্যবসায়
    • ১২ এপ্রি, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ ফেব, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১২ জুল, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ জুল, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ জুল, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ এপ্রি, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ মে, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ জুন, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the goodwill,book debts and patents. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ জুন, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge on book debts
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ ডিসে, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ ডিসে, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge on all book & other debts.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ ডিসে, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৯ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মে, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ মে, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £30,000
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H - unit A8 industrial estate off vinces road diss, norfolk.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Council for Small Industries in Rural Areas
    ব্যবসায়
    • ২২ মে, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১২ জানু, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১০ মে, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ মে, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H unit A8 at gilray rd diss norfolk.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ মে, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৫ নভে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ জানু, ১৯৭৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ জানু, ১৯৭৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank LTD
    ব্যবসায়
    • ২৪ জানু, ১৯৭৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৯ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0