TACO PLASTICS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামTACO PLASTICS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01143506
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    TACO PLASTICS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • প্লাস্টিকের প্যাকিং পণ্য উৎপাদন (22220) / উৎপাদন

    TACO PLASTICS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    C/O Britton Taco Ltd
    Road One Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Cheshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    TACO PLASTICS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    POLYSHRINK LIMITED০৫ নভে, ১৯৭৩০৫ নভে, ১৯৭৩

    TACO PLASTICS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১১

    TACO PLASTICS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    আদালতের আদেশে পুনরুদ্ধার

    3 পৃষ্ঠাAC92
    R4IGB0K1

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01
    A1MZR4WH

    বার্ষিক রিটার্ন ১১ নভে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৬ নভে, ২০১২

    ২৬ নভে, ২০১২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 300
    SH01
    X1M9OP8H

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    1 পৃষ্ঠাAA
    A1DV18W1

    বার্ষিক রিটার্ন ১১ নভে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    XIBEHZQA

    পরিচালক হিসাবে Michael Clark এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01
    XLRACX4W

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    1 পৃষ্ঠাAA
    AEVURRB6

    বার্ষিক রিটার্ন ১১ নভে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    XY7DTP41

    ০৬ নভে, ২০০৯ তারিখে Michael Clark-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01
    XY7DSP40

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    1 পৃষ্ঠাAA
    A2T1NLP3

    বার্ষিক রিটার্ন ১১ নভে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    X3WSAF3G

    ০৯ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Michael Clark-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01
    X3WS9F3F

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    1 পৃষ্ঠাAA
    ACCKEAGM

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a
    X4T3Q4RI

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    1 পৃষ্ঠাAA
    A1BKHXDX

    legacy

    2 পৃষ্ঠা363a

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    1 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    2 পৃষ্ঠা363a

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৫ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    2 পৃষ্ঠা363a

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৪ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    TACO PLASTICS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    GOODMAN, Stephen Tony
    2 Ladyacre
    Bamber Bridge
    PR5 6XN Preston
    Lancashire
    সচিব
    2 Ladyacre
    Bamber Bridge
    PR5 6XN Preston
    Lancashire
    BritishCompany Director42598360003
    GOODMAN, Stephen Tony
    2 Ladyacre
    Bamber Bridge
    PR5 6XN Preston
    Lancashire
    পরিচালক
    2 Ladyacre
    Bamber Bridge
    PR5 6XN Preston
    Lancashire
    UkBritishCompany Director42598360003
    BISHOP, Hugh William
    Barnside 50 High Street
    MK44 1PF Sharnbrook
    Bedfordshire
    সচিব
    Barnside 50 High Street
    MK44 1PF Sharnbrook
    Bedfordshire
    BritishGroup Controller94622690001
    DUERDEN, Michael David
    Northbank House 34 The Dene
    BB2 7QS Blackburn
    Lancashire
    সচিব
    Northbank House 34 The Dene
    BB2 7QS Blackburn
    Lancashire
    British4581740001
    GALE, Vincent Bernard
    19 Burndale Drive
    BL9 8EN Bury
    Lancashire
    সচিব
    19 Burndale Drive
    BL9 8EN Bury
    Lancashire
    British84266460001
    JAMES, Neil
    Coghurst
    74 Pixham Lane
    RH4 1PH Dorking
    Surrey
    সচিব
    Coghurst
    74 Pixham Lane
    RH4 1PH Dorking
    Surrey
    BritishAccountant78877930001
    MOLE, Stephen Richard
    Moor Lane
    Woodford
    SK7 1PW Stockport
    55
    Cheshire
    সচিব
    Moor Lane
    Woodford
    SK7 1PW Stockport
    55
    Cheshire
    BritishFinance Director24121400002
    SEARLE, Richard James
    8 Paddock Orchard Long Mill Lane
    TN15 8NB Platt
    Kent
    সচিব
    8 Paddock Orchard Long Mill Lane
    TN15 8NB Platt
    Kent
    British73033280001
    TAYLOR, Mark Jonathan
    5 Tarvin Close
    SK11 7JJ Macclesfield
    Cheshire
    সচিব
    5 Tarvin Close
    SK11 7JJ Macclesfield
    Cheshire
    BritishFinance Director50778530001
    HACKWOOD SECRETARIES LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004790001
    BEART, Simon Delaval
    43 Fentiman Road
    SW8 1LH London
    পরিচালক
    43 Fentiman Road
    SW8 1LH London
    BritishAccountant28376970001
    BEAUMONT, Nigel Peter
    56 Church Street
    LU7 1BT Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    পরিচালক
    56 Church Street
    LU7 1BT Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    BritishExecutive95868800001
    BISHOP, Hugh William
    Barnside 50 High Street
    MK44 1PF Sharnbrook
    Bedfordshire
    পরিচালক
    Barnside 50 High Street
    MK44 1PF Sharnbrook
    Bedfordshire
    EnglandBritishGroup Controller94622690001
    CLARK, Michael
    C/O Britton Taco Ltd
    Road One Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Cheshire
    পরিচালক
    C/O Britton Taco Ltd
    Road One Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Cheshire
    EnglandBritishDirector92294570002
    COMPTON, Michael John
    Platt Farm Mill Lane
    Heatley Heath
    WA13 9SF Lymm
    Cheshire
    পরিচালক
    Platt Farm Mill Lane
    Heatley Heath
    WA13 9SF Lymm
    Cheshire
    EnglandEnglishDirector4581750001
    JAMES, Neil
    Coghurst
    74 Pixham Lane
    RH4 1PH Dorking
    Surrey
    পরিচালক
    Coghurst
    74 Pixham Lane
    RH4 1PH Dorking
    Surrey
    UkBritishAccountant78877930001
    MANN, Geoffrey Malcolm
    Drake Lane Farm
    CW5 8PD Acton
    Nantwich Cheshire
    পরিচালক
    Drake Lane Farm
    CW5 8PD Acton
    Nantwich Cheshire
    United KingdomBritishDirector163229040001
    MILLICAN, Keith
    Kennet House Brent Street
    Brent Knoll
    TA9 4BB Highbridge
    Somerset
    পরিচালক
    Kennet House Brent Street
    Brent Knoll
    TA9 4BB Highbridge
    Somerset
    BritishChief Financial59839640001
    PARISH, Beth Anne
    10726 W Evans
    80227 Lakewood
    Colorado
    Usa
    পরিচালক
    10726 W Evans
    80227 Lakewood
    Colorado
    Usa
    UsaExecutive55754140001
    PETERS, Raymond Albert
    12 Shearwater Close
    LN6 0XU Lincoln
    Lincolnshire
    পরিচালক
    12 Shearwater Close
    LN6 0XU Lincoln
    Lincolnshire
    United KingdomBritishExecutive70111470001
    RUSSELL, John William
    38 Birchin Lane
    CW5 6JY Nantwich
    Cheshire
    পরিচালক
    38 Birchin Lane
    CW5 6JY Nantwich
    Cheshire
    BritishDirector49879820001
    SAMUEL, Paul Richard Belock
    Moss Cottage Moss Lane
    Tiverton Heath
    CW6 Tarporley
    Cheshire
    পরিচালক
    Moss Cottage Moss Lane
    Tiverton Heath
    CW6 Tarporley
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector16754410001
    SEARLE, Richard James
    8 Paddock Orchard Long Mill Lane
    TN15 8NB Platt
    Kent
    পরিচালক
    8 Paddock Orchard Long Mill Lane
    TN15 8NB Platt
    Kent
    EnglandBritishDirector73033280001
    SELINSKE, Steven
    23834 Village Blacksmith
    TX 78255 San Antonio
    Usa
    পরিচালক
    23834 Village Blacksmith
    TX 78255 San Antonio
    Usa
    AmericanExecutive Vice President57338010001
    SISSON, Jill Bartlett Woodman
    5808 Crestbrook Circle
    80465 Morrison
    Colorado
    Usa
    পরিচালক
    5808 Crestbrook Circle
    80465 Morrison
    Colorado
    Usa
    AmericanGeneral Counsel56560720001
    SMITH, Colin Alfred
    39 Aberdeen Park
    Highbury
    N5 2AR London
    পরিচালক
    39 Aberdeen Park
    Highbury
    N5 2AR London
    EnglandBritishDirector66857520002
    STANLEY, John
    60 Inglewood Close
    Birchwood
    WA3 6UJ Warrington
    Cheshire
    পরিচালক
    60 Inglewood Close
    Birchwood
    WA3 6UJ Warrington
    Cheshire
    BritishDirector4597630001
    TAYLOR, Mark Jonathan
    5 Tarvin Close
    SK11 7JJ Macclesfield
    Cheshire
    পরিচালক
    5 Tarvin Close
    SK11 7JJ Macclesfield
    Cheshire
    BritishFinance Director50778530001
    TAYLOR, Michael John
    Stretton Hall
    Stretton
    SY14 7JA Malpas
    Cheshire
    পরিচালক
    Stretton Hall
    Stretton
    SY14 7JA Malpas
    Cheshire
    BritishDirector16882280002
    WARD, Justin Paul
    53 Saint Johns Avenue
    SW15 6AL London
    পরিচালক
    53 Saint Johns Avenue
    SW15 6AL London
    BritishExecutive78777110002
    WATTERS, Roderick Ian Alistair
    The Mill
    Mill Lane
    RG9 4HB Henley On Thames
    Oxfordshire
    পরিচালক
    The Mill
    Mill Lane
    RG9 4HB Henley On Thames
    Oxfordshire
    AustralianExecutive67175860001
    WHITBREAD, Timothy Lawrece
    Vartry Bungalow
    Kingsland
    HR6 9QJ Leominster
    Herefordshire
    পরিচালক
    Vartry Bungalow
    Kingsland
    HR6 9QJ Leominster
    Herefordshire
    BritishTechnical Director30957380001
    WHITTAKER, Peter Gordon
    58 Kings Court
    Kings Drive
    HA9 9JQ Wembley
    Middlesex
    পরিচালক
    58 Kings Court
    Kings Drive
    HA9 9JQ Wembley
    Middlesex
    BritishManaging Director58201840001
    WILLIAMS, Robin George Walton
    4 Delvino Road
    SW6 4AG London
    পরিচালক
    4 Delvino Road
    SW6 4AG London
    BritishAccountant39500990001
    BRITTON TACO LIMITED
    Castle Court
    41 London Road
    RH2 9RJ Reigate
    Surrey
    কর্পোরেট পরিচালক
    Castle Court
    41 London Road
    RH2 9RJ Reigate
    Surrey
    46203260006

    TACO PLASTICS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১১ অক্টো, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ অক্টো, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to allied dunbar pension services limited michael john taylor and michael john compton being the present trustees of the taco plastics limited (self administered) pension plan.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A fixed charge on all book debts & other debts from time to time due or owing to the company floating charge over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • M J Comptonlimited (Self Administered) Pension Planbeing the Present Trustees of the Taco Plastics
    • M J Taylor
    • Allied Dunbar Pension Services Limited
    ব্যবসায়
    • ২৪ অক্টো, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১২ আগ, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ জুন, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ জুন, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £160,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The assets:-8 x 80 tonne aluminium silos for the storage of low density polyethane and which are located on the property at road one industrial estate, winsford cheshire, england.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Shell Chemicals U.K.Limited
    ব্যবসায়
    • ২৮ জুন, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১২ আগ, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattel mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ আগ, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ সেপ, ১৯৮৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A sheet plastic embossed film extruder.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Societe Generale
    ব্যবসায়
    • ০৯ সেপ, ১৯৮৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৫ জুল, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ এপ্রি, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ এপ্রি, ১৯৮৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undetaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ এপ্রি, ১৯৮৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৫ জুল, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ আগ, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ আগ, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over the companys f/h & l/h property. Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & goodwill uncalled capital. By way of legal mortgage:- (1) l/H. Property at sefton lane industrial estate, maghull, merseyside.title no: MS157913. (2) f/h - property at winsford industrial estate, cheshire. Specific charge over all plant & machinery referred to in schedule (2) at doc M31. (See doc M31 for more details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • County Bank LTD.
    ব্যবসায়
    • ২৮ আগ, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৭ মে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জুল, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ জুল, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over the companys f/h & l/h property and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts goodwill uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ জুল, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৭ মে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ মে, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জুন, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a land at winsford industrial estate winsford cheshire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ জুন, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ মে, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জুন, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Sefton lane industrial estate maghull merseyside title no MS157913 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ জুন, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ৩০ ডিসে, ১৯৯১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0