BARRON AUTOMATION SYSTEMS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামBARRON AUTOMATION SYSTEMS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01148196
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    BARRON AUTOMATION SYSTEMS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7499) /

    BARRON AUTOMATION SYSTEMS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Glendevon House Hawthorn Park
    Coal Road
    LS14 1PQ Leeds
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    BARRON AUTOMATION SYSTEMS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    BARRON CONTROL PANELS LIMITED২৮ নভে, ১৯৭৩২৮ নভে, ১৯৭৩

    BARRON AUTOMATION SYSTEMS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৮

    BARRON AUTOMATION SYSTEMS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    3 পৃষ্ঠা4.71

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ১৪ ডিসে, ২০০৯ তারিখে

    LRESSP

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    3 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    2 পৃষ্ঠা363a

    সমিতির এবং সংবিধির নথি

    10 পৃষ্ঠাMA

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    11 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ গৃহীত করার রেজুলেশন

    RES01

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    2 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৫ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    2 পৃষ্ঠা363a

    BARRON AUTOMATION SYSTEMS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    CROXSON, Neil Michael
    15 Kyle Way
    Nether Poppleton
    YO26 6RH York
    পরিচালক
    15 Kyle Way
    Nether Poppleton
    YO26 6RH York
    UkBritishCfo96469690002
    LASCHKAR, Henri-Paul
    23 Hyde Park Place
    W2 2LP London
    Flat 2
    পরিচালক
    23 Hyde Park Place
    W2 2LP London
    Flat 2
    UkFrenchSvp139160640001
    CARTLIDGE, Gary John
    Hendre Loudwater Lane
    WD3 4AN Rickmansworth
    Hertfordshire
    সচিব
    Hendre Loudwater Lane
    WD3 4AN Rickmansworth
    Hertfordshire
    British11920020001
    EVETTS, John Graham
    72 Sycamore Avenue
    RM14 2HS Upminster
    Essex
    সচিব
    72 Sycamore Avenue
    RM14 2HS Upminster
    Essex
    Pollish/British56188860003
    JAMES, Simon Michael
    37 Brand Hill Drive
    Crofton
    WF4 1PF Wakefield
    Yorkshire
    সচিব
    37 Brand Hill Drive
    Crofton
    WF4 1PF Wakefield
    Yorkshire
    British111338120001
    JENKINSON, Roger Anthony
    Pollensa 3 Fledburgh Drive
    New Hall
    B76 1ED Sutton Coldfield
    West Midlands
    সচিব
    Pollensa 3 Fledburgh Drive
    New Hall
    B76 1ED Sutton Coldfield
    West Midlands
    British985860002
    SABIN, Douglas Harold
    8 Radcliffe Drive
    B62 8PJ Halesowen
    West Midlands
    সচিব
    8 Radcliffe Drive
    B62 8PJ Halesowen
    West Midlands
    British52697160001
    TALLIS, Aleksandra Jadwiga
    6 St Chads Grove
    LS6 3PN Leeds
    West Yorkshire
    সচিব
    6 St Chads Grove
    LS6 3PN Leeds
    West Yorkshire
    Polish34638000004
    TRIGGER, Roy
    48 Bartel Close
    Leverstock Green
    HP3 8LY Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    সচিব
    48 Bartel Close
    Leverstock Green
    HP3 8LY Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British11920010002
    CARTLIDGE, Alison Mai
    Hendre Loudwater Lane
    WD3 4AN Rickmansworth
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Hendre Loudwater Lane
    WD3 4AN Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritishSchool Teacher12921200001
    CARTLIDGE, Gary John
    Hendre Loudwater Lane
    WD3 4AN Rickmansworth
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Hendre Loudwater Lane
    WD3 4AN Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector11920020001
    CARTLIDGE, Gary John
    Hendre Loudwater Lane
    WD3 4AN Rickmansworth
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Hendre Loudwater Lane
    WD3 4AN Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChemical Engineer11920020001
    FORRESTER, Andrew John
    The Shieling
    70 Tiddington Road
    CV37 7BA Stratford Upon Avon
    পরিচালক
    The Shieling
    70 Tiddington Road
    CV37 7BA Stratford Upon Avon
    United KingdomBritishCompany Director97001960001
    LEE, Michael William George
    Forleas Hotley Bottom Lane
    Prestwood
    HP16 9PL Great Missenden
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Forleas Hotley Bottom Lane
    Prestwood
    HP16 9PL Great Missenden
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector14069700001
    LEE, Michael William George
    Forleas Hotley Bottom Lane
    Prestwood
    HP16 9PL Great Missenden
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Forleas Hotley Bottom Lane
    Prestwood
    HP16 9PL Great Missenden
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector14069700001
    MC NAB, William Douglas
    57 Pelican Road
    Pamber Heath
    RG26 6EL Basingstoke
    Hampshire
    পরিচালক
    57 Pelican Road
    Pamber Heath
    RG26 6EL Basingstoke
    Hampshire
    BritishDirector23845420001
    MC NAB, William Douglas
    57 Pelican Road
    Pamber Heath
    RG26 6EL Basingstoke
    Hampshire
    পরিচালক
    57 Pelican Road
    Pamber Heath
    RG26 6EL Basingstoke
    Hampshire
    BritishCompany Director23845420001
    MUGFORD, Mary Elizabeth
    Hendre Loudwater Lane
    WD3 4AN Rickmansworth
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Hendre Loudwater Lane
    WD3 4AN Rickmansworth
    Hertfordshire
    Great BritainBritishSecretary12921220001
    MUGFORD, Stanley Sidney George
    Hendre Loudwater Lane
    WD3 4AN Rickmansworth
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Hendre Loudwater Lane
    WD3 4AN Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishElectrical Engineer12921230001
    MULLEN, Kenneth John
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    United KingdomScottishCompany Director146642810001
    NICHOLS, Matt Ward, Mr.
    18 Sweetpool Lane
    Hagley
    DY8 2XH Stourbridge
    West Midlands
    পরিচালক
    18 Sweetpool Lane
    Hagley
    DY8 2XH Stourbridge
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Manager177829370001
    PASSMAN, Jonathan Richard
    Stonefield Close
    Wigston Park Walsgrave
    CV2 2PZ Coventry
    6
    পরিচালক
    Stonefield Close
    Wigston Park Walsgrave
    CV2 2PZ Coventry
    6
    BritishHead Of Legal122460330002
    WISHART, John Oliver
    14 Edwards Avenue
    South Ruislip
    HA4 6UZ Ruislip
    Middlesex
    পরিচালক
    14 Edwards Avenue
    South Ruislip
    HA4 6UZ Ruislip
    Middlesex
    BritishEngineer12921240001

    BARRON AUTOMATION SYSTEMS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ মার্চ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ মার্চ, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ মার্চ, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ জানু, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ মার্চ, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ মার্চ, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ মার্চ, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২১ জানু, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    BARRON AUTOMATION SYSTEMS LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১৪ ডিসে, ২০০৯ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ৩০ অক্টো, ২০১০ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    David Frederick Wilson
    Begbies Traynor
    Glendevon House
    LS14 1PQ Hawthorn Park
    Coal Road Leeds
    অভ্যাসকারী
    Begbies Traynor
    Glendevon House
    LS14 1PQ Hawthorn Park
    Coal Road Leeds
    Julian Pitts
    Glendevon House Hawthorn Park
    Coal Road
    LS14 1PQ Leeds
    অভ্যাসকারী
    Glendevon House Hawthorn Park
    Coal Road
    LS14 1PQ Leeds

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0