GREENHILL CHEMICAL PRODUCTS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামGREENHILL CHEMICAL PRODUCTS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01153782
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    GREENHILL CHEMICAL PRODUCTS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    GREENHILL CHEMICAL PRODUCTS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Yule Catto Building
    Temple Fields
    CM20 2BH Harlow
    Essex
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    GREENHILL CHEMICAL PRODUCTS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১১

    GREENHILL CHEMICAL PRODUCTS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    বার্ষিক রিটার্ন ০৩ নভে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৬ নভে, ২০১২

    ২৬ নভে, ২০১২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 200
    SH01

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ১৩ জুল, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Adrian Michael Whitfield এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    ১৩ জুল, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Richard Atkinson-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    33 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ গৃহীত করার রেজুলেশন

    RES01
    capital

    শেয়ারের অধিকার বা নাম পরিবর্তনের রেজুলেশন

    RES12

    শেয়ার শ্রেণীর নাম বা পদবী পরিবর্তন

    2 পৃষ্ঠাSH08

    কোম্পানির উদ্দেশ্যের বিবৃতি

    2 পৃষ্ঠাCC04

    বার্ষিক রিটার্ন ০৩ নভে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    15 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৩ নভে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    15 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৩ নভে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    15 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৫ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    GREENHILL CHEMICAL PRODUCTS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    ATKINSON, Richard
    Stomps
    Bacon End
    CM6 1JW Dunmow
    Essex
    সচিব
    Stomps
    Bacon End
    CM6 1JW Dunmow
    Essex
    British60376890003
    ATKINSON, Richard
    Bacon End
    CM6 1JW Dunmow
    Stomps
    Essex
    United Kingdom
    পরিচালক
    Bacon End
    CM6 1JW Dunmow
    Stomps
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Secretary60376890003
    BURNETT, Andrew David
    25 Ennismore Green
    LU2 8UP Luton
    Bedfordshire
    পরিচালক
    25 Ennismore Green
    LU2 8UP Luton
    Bedfordshire
    United KingdomBritishAccountant56579020001
    BIRD, Kenneth Rodney Ferne
    11 Granary Court
    Bell Street
    CM21 9QH Sawbridgeworth
    Herts
    সচিব
    11 Granary Court
    Bell Street
    CM21 9QH Sawbridgeworth
    Herts
    British8101030002
    GRANT, Robert Murray
    The Nook Bush End
    Takeley
    CM22 6NN Bishops Stortford
    Hertfordshire
    সচিব
    The Nook Bush End
    Takeley
    CM22 6NN Bishops Stortford
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary10658540002
    MCLEISH, Allister Patrick
    1 St Johns Road
    CM24 8JP Stansted Mountfitchet
    Essex
    সচিব
    1 St Johns Road
    CM24 8JP Stansted Mountfitchet
    Essex
    British3251540001
    WATKINS, Malcolm Peter
    Broadlands Hall Drive
    Doveridge
    DE6 5LG Ashbourne
    Derbyshire
    সচিব
    Broadlands Hall Drive
    Doveridge
    DE6 5LG Ashbourne
    Derbyshire
    British27597820001
    BELL, John
    The Willows
    New Street, Elsham
    DN20 0RP Brigg
    North East Lincolnshire
    পরিচালক
    The Willows
    New Street, Elsham
    DN20 0RP Brigg
    North East Lincolnshire
    BritishCompany Director20266390002
    BOWDEN, Shaun Michael Peter
    4 Chatterton Avenue
    Fitzwilliam Court
    WS3 8EF Lichfield
    Staffordshire
    পরিচালক
    4 Chatterton Avenue
    Fitzwilliam Court
    WS3 8EF Lichfield
    Staffordshire
    BritishCompany Director30031950006
    CUMMINS, Sean Vincent
    15 Brooke Gardens
    CM23 5JF Bishops Stortford
    Hertfordshire
    পরিচালক
    15 Brooke Gardens
    CM23 5JF Bishops Stortford
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant165086580001
    FISHER, Michael John
    34 Elstead Lane
    Blackfordby
    DE11 8AJ Swadlincote
    Derbyshire
    পরিচালক
    34 Elstead Lane
    Blackfordby
    DE11 8AJ Swadlincote
    Derbyshire
    BritishAccountant32884730001
    GUNN, David James
    17 Saffron Close
    Barton Under Needwood
    DE13 8DL Burton On Trent
    Staffordshire
    পরিচালক
    17 Saffron Close
    Barton Under Needwood
    DE13 8DL Burton On Trent
    Staffordshire
    BritishCompany Director62095640001
    JACKSON, Martyn Andrew
    24 Rydal Gardens
    LE65 1FJ Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    পরিচালক
    24 Rydal Gardens
    LE65 1FJ Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    BritishSales Director35342630002
    MCLAUCHLAN, Alistair Douglas
    Old College House
    34 Dam Street
    WS13 6AA Lichfield
    Staffordshire
    পরিচালক
    Old College House
    34 Dam Street
    WS13 6AA Lichfield
    Staffordshire
    BritishDirector39558600002
    STEVENS, Ralph
    Windermere 55 Ashdale Close
    DE15 9HN Burton On Trent
    Staffordshire
    পরিচালক
    Windermere 55 Ashdale Close
    DE15 9HN Burton On Trent
    Staffordshire
    BritishDirector17811650001
    WALKER, Alexander
    Little Firle
    23 Avenue Road
    CM23 5NT Bishops Stortford
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Little Firle
    23 Avenue Road
    CM23 5NT Bishops Stortford
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector46645250002
    WALKER, Colin Peter
    Hill Farm Barn
    Tatenhill Common Tangemore
    Burton On Trent
    Staffordshire
    পরিচালক
    Hill Farm Barn
    Tatenhill Common Tangemore
    Burton On Trent
    Staffordshire
    BritishCompany Director20130660002
    WATKINS, Malcolm Peter
    Broadlands Hall Drive
    Doveridge
    DE6 5LG Ashbourne
    Derbyshire
    পরিচালক
    Broadlands Hall Drive
    Doveridge
    DE6 5LG Ashbourne
    Derbyshire
    United KingdomBritishAccountant27597820001
    WHITFIELD, Adrian Michael
    Arden View
    The Orchard, Wilmcote
    CV37 9XF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    পরিচালক
    Arden View
    The Orchard, Wilmcote
    CV37 9XF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    United KingdomBritishCompany Director71426000002
    WOOD, John Howard
    24 Carnoustie
    B77 4NN Tamworth
    Staffordshire
    পরিচালক
    24 Carnoustie
    B77 4NN Tamworth
    Staffordshire
    BritishTechnical/Commercial Director87227660001

    GREENHILL CHEMICAL PRODUCTS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ জানু, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ জানু, ১৯৮৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H premises off rawdon road, moira, county of leicester, and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ জানু, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ সেপ, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ অক্টো, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over the company's estate or interest in all f/h or l/h properties and the proceeds of sale thereof. Fixed & floating charge - undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ অক্টো, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    Single debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ সেপ, ১৯৮০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ অক্টো, ১৯৮০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill stocks & shares uncalled capital. See doc M19. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hambros Bank LTD
    ব্যবসায়
    • ২০ অক্টো, ১৯৮০একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0