ERINACEOUS MANAGED SERVICES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামERINACEOUS MANAGED SERVICES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01166863
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    ERINACEOUS MANAGED SERVICES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7470) /
    • (7487) /

    ERINACEOUS MANAGED SERVICES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    KPMG LLP
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    ERINACEOUS MANAGED SERVICES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    EURICA! SERVICES LIMITED০৯ আগ, ২০০০০৯ আগ, ২০০০
    CARE SERVICES LIMITED০৯ এপ্রি, ১৯৯৬০৯ এপ্রি, ১৯৯৬
    CARE CONTRACT SERVICES LIMITED০২ মার্চ, ১৯৯২০২ মার্চ, ১৯৯২
    C.C.A. CONTRACT SERVICES LIMITED০২ ফেব, ১৯৮৯০২ ফেব, ১৯৮৯
    C.C.A. (OFFICE & FACTORY CLEANERS) LIMITED১৬ এপ্রি, ১৯৭৪১৬ এপ্রি, ১৯৭৪

    ERINACEOUS MANAGED SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৫

    ERINACEOUS MANAGED SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ১২ মে, ২০১১ তারিখে প্রশাসন থেকে দ্রবণে স্থানান্তরের নোটিশ

    30 পৃষ্ঠা2.35B

    ১৩ অক্টো, ২০১০ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    27 পৃষ্ঠা2.24B

    প্রশাসনের সময় বর্ধনের নোটিশ

    1 পৃষ্ঠা2.31B

    ১৩ এপ্রি, ২০১০ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    29 পৃষ্ঠা2.24B

    ১৩ অক্টো, ২০০৯ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    41 পৃষ্ঠা2.24B

    প্রশাসনের সময় বর্ধনের নোটিশ

    1 পৃষ্ঠা2.31B

    ১৩ এপ্রি, ২০০৯ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    44 পৃষ্ঠা2.24B

    প্রশাসনের সময় বর্ধনের নোটিশ

    1 পৃষ্ঠা2.31B

    ১৩ অক্টো, ২০০৮ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    39 পৃষ্ঠা2.24B

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    145 পৃষ্ঠা2.17B

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ 2.14B

    14 পৃষ্ঠা2.16B

    প্রশাসনের সময় বর্ধনের নোটিশ

    1 পৃষ্ঠা2.18B

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    প্রশাসক নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা2.12B

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    2 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    4 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed eurica! Services LIMITED\certificate issued on 19/01/07
    2 পৃষ্ঠাCERTNM

    অডিটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাAUD

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৫ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    2 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    ERINACEOUS MANAGED SERVICES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BELLIS, Juliet Mary Susan
    4 Grange Hill
    SE25 6SX London
    সচিব
    4 Grange Hill
    SE25 6SX London
    BritishSolicitor69991160002
    JOHNSON, Robin Simon
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    সচিব
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    British11498320001
    DAVIS, Nigel Peter
    6 Boundary Park
    KT13 9RR Weybridge
    Surrey
    পরিচালক
    6 Boundary Park
    KT13 9RR Weybridge
    Surrey
    EnglandBritishDirector93673010002
    NOEL, Maurice
    Stone Lea
    9 Pannal Ash Road
    HG2 9AA Harrogate
    North Yorkshire
    সচিব
    Stone Lea
    9 Pannal Ash Road
    HG2 9AA Harrogate
    North Yorkshire
    British30297610002
    INTERIOR PLC
    15 Appold Street
    EC2A 2NH London
    কর্পোরেট সচিব
    15 Appold Street
    EC2A 2NH London
    85384120001
    ISG OCCUPANCY LIMITED
    15 Appold Street
    EC2A 2NH London
    কর্পোরেট সচিব
    15 Appold Street
    EC2A 2NH London
    96456580001
    BELLIS, Neil Graham
    4 Grange Hill
    SE25 6SX London
    পরিচালক
    4 Grange Hill
    SE25 6SX London
    BritishBarrister61569970002
    BODNAR-HORVATH, Robert Edmund Paul
    20 Harold Road
    SE19 3PL London
    পরিচালক
    20 Harold Road
    SE19 3PL London
    EnglandBritishDirector46232460002
    CUMMINGS, Lucy
    13 Plympton Street
    NW8 8AB London
    পরিচালক
    13 Plympton Street
    NW8 8AB London
    BritishManagement Consultant80559730001
    DAWE, Michael
    Thornhill Lodge
    279 Boxley Road
    ME14 2ES Maidstone
    Kent
    পরিচালক
    Thornhill Lodge
    279 Boxley Road
    ME14 2ES Maidstone
    Kent
    BritishDirector72833980001
    DOVE, Peter Stephen
    28 Melody Road
    SW18 2QF London
    পরিচালক
    28 Melody Road
    SW18 2QF London
    UkBritishChartered Surveyor141661060001
    GRUNDY, David Brian
    Al Manzel Main Street
    Gilmorton
    LE17 5NX Lutterworth
    Leicestershire
    পরিচালক
    Al Manzel Main Street
    Gilmorton
    LE17 5NX Lutterworth
    Leicestershire
    BritishDirector17236980001
    HOLDSWORTH, Richard David
    Hillcrest
    Gravelly Hill Lane, Weeton
    LS17 0EX Leeds
    পরিচালক
    Hillcrest
    Gravelly Hill Lane, Weeton
    LS17 0EX Leeds
    EnglandBritishContract Cleaning Executive15105150001
    LAWTHER, Samuel David
    41 Earls Court Square
    SW5 9BY London
    পরিচালক
    41 Earls Court Square
    SW5 9BY London
    EnglandBritishDirector154579210001
    LEVINE, Colin Alexander
    52 Cross Road
    KT20 5ST Tadworth
    Surrey
    পরিচালক
    52 Cross Road
    KT20 5ST Tadworth
    Surrey
    BritishContract Services Executive17236970001
    MIDDLETON, John Thomas George
    Redberry House Gargrave Road
    Broughton
    BD23 3AQ Skipton
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Redberry House Gargrave Road
    Broughton
    BD23 3AQ Skipton
    North Yorkshire
    BritishDirector58637590002
    NOEL, Maurice
    Stone Lea
    9 Pannal Ash Road
    HG2 9AA Harrogate
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Stone Lea
    9 Pannal Ash Road
    HG2 9AA Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishContract Cleaning Executive30297610002
    PEARSON, Michael
    60 Barmouth Road
    SW18 2DR Wandsworth
    Greater London
    পরিচালক
    60 Barmouth Road
    SW18 2DR Wandsworth
    Greater London
    EnglandBritishAccountant67026480004
    SQUIRE, Julian Francis
    Saffrons Huntersfield
    Sherston
    SN16 0LS Malmesbury
    Wiltshire
    পরিচালক
    Saffrons Huntersfield
    Sherston
    SN16 0LS Malmesbury
    Wiltshire
    EnglandBritishChief Executive50574110001
    STACEY, Edward John
    Orchard Barn Main Street
    Stretton-Under-Fosse
    CV23 0PE Rugby
    Warwickshire
    পরিচালক
    Orchard Barn Main Street
    Stretton-Under-Fosse
    CV23 0PE Rugby
    Warwickshire
    United KingdomBritishHr Director74099840001
    STANLEY, Hugh Duncan
    Sandale Lodge
    Rosslyn Lane, Cuddington
    CW8 2JZ Northwich
    Cheshire
    পরিচালক
    Sandale Lodge
    Rosslyn Lane, Cuddington
    CW8 2JZ Northwich
    Cheshire
    BritishManaging Director71365340001
    WESTON, Gordon Leslie
    Dendron Reading Road North
    GU13 8HR Fleet
    Hampshire
    পরিচালক
    Dendron Reading Road North
    GU13 8HR Fleet
    Hampshire
    BritishContract Services Executive2506160001
    WILSON, Richard Philip
    6 Eastbrook Road
    Blackheath
    SE3 8BP London
    পরিচালক
    6 Eastbrook Road
    Blackheath
    SE3 8BP London
    BritishOperations Director77399730001

    ERINACEOUS MANAGED SERVICES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Group debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ জুল, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ আগ, ২০০৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Finance Parties(The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ০৩ আগ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ আগ, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ আগ, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২০ আগ, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Security deed of accession
    তৈরি করা হয়েছে ০২ সেপ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ সেপ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies and liabilities now or hereafter advanced by or due owing or incurred to the chargee by the company and each of the obligors in whatsoever manner
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১০ সেপ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ ফেব, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১০ ডিসে, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ ডিসে, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H and l/h properties present and future with fixtures (inc trade fixtures) fixed plant and machinery goodwill and uncalled capital present and future. Undertaking all other property and assets present and future inc. Heritable property and assets in scotland. Fixed and floating charge.(see doc.M14).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ ডিসে, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৭ সেপ, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মে, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মে, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H 61 washway road, sale, greater manchester.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ মে, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৭ সেপ, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Single debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১০ মার্চ, ১৯৭৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ মার্চ, ১৯৭৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    66A, bingley road, saltaire, shipley, west yorkshire fixed & floating charge on f/h & l/h properties present & future with fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery, goodwill, & uncalled capital present and futureundertaking & all other property & assets present & future including heritable property and assets in scotland. (See doc. M12 for details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ মার্চ, ১৯৭৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৭ সেপ, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Second legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ জুন, ১৯৭৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ জুন, ১৯৭৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H office & shop at 66, bingley rd, shipley.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ জুন, ১৯৭৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৭ সেপ, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    ERINACEOUS MANAGED SERVICES LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১৪ এপ্রি, ২০০৮প্রশাসন শুরু
    ১২ মে, ২০১১প্রশাসন শেষ
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Richard John Hill
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    অভ্যাসকারী
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    James Robert Tucker
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    অভ্যাসকারী
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0