EDWARDS VACUUM LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামEDWARDS VACUUM LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01175680
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    EDWARDS VACUUM LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • হেড অফিসের কার্যক্রম (70100) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    EDWARDS VACUUM LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    EDWARDS VACUUM LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    BOC (EUROPE) HOLDINGS LIMITED২৮ জুন, ১৯৭৪২৮ জুন, ১৯৭৪

    EDWARDS VACUUM LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৩

    EDWARDS VACUUM LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    EDWARDS VACUUM LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    4 পৃষ্ঠা4.71

    ২০ অক্টো, ২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Manor Royal Crawley West Sussex RH10 9LW থেকে 15 Canada Square London E14 5GLপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ২৮ সেপ, ২০১৫ তারিখে

    LRESSP

    বার্ষিক রিটার্ন ২৬ জানু, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৯ জানু, ২০১৫

    ২৯ জানু, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 5,331,060
    SH01

    অডিটরের পদত্যাগ

    2 পৃষ্ঠাAUD

    অডিটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাAUD

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    16 পৃষ্ঠাAA

    ০১ জুল, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Neil Anthony Lavender Jones-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    সচিব হিসাবে Sally Suzanne Patrick-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    সচিব হিসাবে Sarah Larkins এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    পরিচালক হিসাবে Finbarr Crowley এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৯ এপ্রি, ২০১৪ তারিখে Gareth Valentine Harte-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    চার্জ 1 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    14 পৃষ্ঠাMR04

    বার্ষিক রিটার্ন ২৬ জানু, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৫ ফেব, ২০১৪

    ০৫ ফেব, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 5,331,060
    SH01

    পরিচালক হিসাবে Alex Jan Christiaan Bongaerts-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    সচিব হিসাবে Michael Anscombe এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    পরিচালক হিসাবে Gareth Valentine Harte-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে David Smith এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৬ জানু, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    সচিব হিসাবে Mr Michael Anscombe-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    EDWARDS VACUUM LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    PATRICK, Sally Suzanne
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    সচিব
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    189305960001
    BONGAERTS, Alex Christiaan Jan
    Manor Royal
    RH10 9LW Crawley
    Crawley Business Quarter
    West Sussex
    United Kingdom
    পরিচালক
    Manor Royal
    RH10 9LW Crawley
    Crawley Business Quarter
    West Sussex
    United Kingdom
    BelgiumBelgianDirector117532230001
    HARTE, Gareth Valentine
    Manor Royal
    RH10 9LW Crawley
    West Sussex
    England
    পরিচালক
    Manor Royal
    RH10 9LW Crawley
    West Sussex
    England
    EnglandIrishChartered Accountant184063640002
    LAVENDER JONES, Neil Anthony
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    পরিচালক
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    EnglandBritishGroup Vp, General Vacuum181954440001
    ANSCOMBE, Michael
    Manor Royal
    Crawley
    RH10 9LW West Sussex
    সচিব
    Manor Royal
    Crawley
    RH10 9LW West Sussex
    166792050001
    BAKER, Ian Kenneth Hood
    33 Atfield Grove
    GU20 6DP Windlesham
    Surrey
    সচিব
    33 Atfield Grove
    GU20 6DP Windlesham
    Surrey
    British3994580001
    HUNT, Carol Anne
    The Boc Group
    Chertsey Road
    GU20 6HJ Windlesham
    Surrey
    সচিব
    The Boc Group
    Chertsey Road
    GU20 6HJ Windlesham
    Surrey
    British40992870003
    LARKINS, Sarah Louise
    11 Bluebell Road
    Lindford
    GU35 0YN Bordon
    Hampshire
    সচিব
    11 Bluebell Road
    Lindford
    GU35 0YN Bordon
    Hampshire
    British99307280001
    PAVEY, David Gordon
    28 Malthouse Close
    Church Crookham
    GU13 0TB Fleet
    Hampshire
    সচিব
    28 Malthouse Close
    Church Crookham
    GU13 0TB Fleet
    Hampshire
    British3878440002
    ROWLANDS, Melanie Jane
    Venthams Farm Cottages
    Froxfield
    GU32 1DH Nr Petersfield
    Spott Cottage 66
    সচিব
    Venthams Farm Cottages
    Froxfield
    GU32 1DH Nr Petersfield
    Spott Cottage 66
    British135393430001
    SMALL, Jeremy Peter
    Cherry Trees
    West Heath
    GU24 0JQ Pirbright
    Surrey
    সচিব
    Cherry Trees
    West Heath
    GU24 0JQ Pirbright
    Surrey
    BritishCompany Secretary67168210001
    BRACKFIELD, Andrew Christopher
    The Linde Group
    Chertsey Road
    GU20 6HJ Windlesham
    Surrey
    পরিচালক
    The Linde Group
    Chertsey Road
    GU20 6HJ Windlesham
    Surrey
    BritishSolicitor118706260001
    BRADLEY, Christopher
    Woodlands
    Foxhollow Drive
    SL2 3HB Farnham Common
    Bucks
    পরিচালক
    Woodlands
    Foxhollow Drive
    SL2 3HB Farnham Common
    Bucks
    United KingdomBritishAccountant182213840001
    CHIPCHASE, Graham Andrew
    Brook Cottage
    Kings Saltern Road
    SO41 3QH Lymington
    Hampshire
    পরিচালক
    Brook Cottage
    Kings Saltern Road
    SO41 3QH Lymington
    Hampshire
    BritishChartered Accountant64473880001
    CHOW, Chung Kong, Sir
    Flat 10
    20 Lowndes Square
    SW1X 9HD London
    পরিচালক
    Flat 10
    20 Lowndes Square
    SW1X 9HD London
    BritishMd And Chief Executive/Gases37736600002
    CLUBB, Ian Mcmaster
    Pond House
    EN5 4PS Hadley Green
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Pond House
    EN5 4PS Hadley Green
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant3485960001
    CONNELL, William Edward
    Maedan Merrywood Copse
    65 Portsmouth Road
    GU15 1JD Camberley
    Surrey
    পরিচালক
    Maedan Merrywood Copse
    65 Portsmouth Road
    GU15 1JD Camberley
    Surrey
    BritishGroup Controller The Boc Group21334820002
    CROWLEY, Finbarr Peter
    Manor Royal
    Crawley
    RH10 9LW West Sussex
    পরিচালক
    Manor Royal
    Crawley
    RH10 9LW West Sussex
    United KingdomIrishGroup Financial Controller88126760001
    DEEMING, Nicholas
    The Boc Group Plc
    Chertsey Road
    GU20 6HJ Windlesham
    Surrey
    পরিচালক
    The Boc Group Plc
    Chertsey Road
    GU20 6HJ Windlesham
    Surrey
    BritishSolicitor64399320009
    DYER, Alexander Patrick
    5 Lowndes Court
    Lowndes Square
    SW1X 9JJ London
    পরিচালক
    5 Lowndes Court
    Lowndes Square
    SW1X 9JJ London
    AmericanDeputy Chairman & Chief Execut34949950004
    FERGUSON, Alan Murray
    The Boc Group
    Chertsey Road
    GU20 6HJ Windlesham
    Surrey
    পরিচালক
    The Boc Group
    Chertsey Road
    GU20 6HJ Windlesham
    Surrey
    BritishGroup Finance Director108042900001
    HUNTON, Nigel David
    Roughwoods Brantridge Forest
    High Street
    RH17 6JY Balcombe
    West Sussex
    পরিচালক
    Roughwoods Brantridge Forest
    High Street
    RH17 6JY Balcombe
    West Sussex
    EnglandBritishChief Executive Officer166879980001
    ISAAC, Anthony Eric
    The Boc Group
    Chertsey Road
    GU20 6HJ Windlesham
    Surrey
    পরিচালক
    The Boc Group
    Chertsey Road
    GU20 6HJ Windlesham
    Surrey
    BritishChief Executive4882700004
    MASTERS JR, Jerry Kent
    The Boc Group
    Chertsey Road
    GU20 6HJ Windlesham
    Surrey
    পরিচালক
    The Boc Group
    Chertsey Road
    GU20 6HJ Windlesham
    Surrey
    AmericanChief Executive I & Sp103851600001
    MEDORI, Rene
    Woodhaven Green
    Wood Lane St George's Hill
    KT13 0JU Weybridge
    Surrey
    পরিচালক
    Woodhaven Green
    Wood Lane St George's Hill
    KT13 0JU Weybridge
    Surrey
    FrenchGroup Finance Director106115110001
    RICH, Patrick Jean-Jacques
    95 Eaton Terrace
    SW1W 8TW London
    পরিচালক
    95 Eaton Terrace
    SW1W 8TW London
    FrenchNon Executive Chairman4255470002
    ROSENKRANZ, Franklin Daniel
    Windrush
    Coombe End
    KT2 7DQ Kingston-Upon-Thames
    Surrey
    পরিচালক
    Windrush
    Coombe End
    KT2 7DQ Kingston-Upon-Thames
    Surrey
    United KingdomBritishChief Executive3878460001
    SAITH, Vijay Kumar
    Pendennis
    Pyrford Road
    KT14 6RQ West Byfleet
    Surrey
    পরিচালক
    Pendennis
    Pyrford Road
    KT14 6RQ West Byfleet
    Surrey
    BritishDeputy Finance Director The Bo23840930001
    SMITH, David Miles
    Manor Royal
    Crawley
    RH10 9LW West Sussex
    পরিচালক
    Manor Royal
    Crawley
    RH10 9LW West Sussex
    EnglandBritishChief Financial Officer153009420003
    SPENCE, Patrick Charles Gordon
    The Boc Group
    Chertsey Road
    GU20 6HJ Windlesham
    Surrey
    পরিচালক
    The Boc Group
    Chertsey Road
    GU20 6HJ Windlesham
    Surrey
    BritishChartered Accountant79853340004
    STUART, Gloria Jean
    Appin Lodge
    Long Hill The Sands
    GU10 1NQ Farnham
    Surrey
    পরিচালক
    Appin Lodge
    Long Hill The Sands
    GU10 1NQ Farnham
    Surrey
    United KingdomBritishSolicitor39220810002
    TARALLO, Angelo Nicholas
    Park Cottage
    Broomfield Park
    SL5 0JT Sunningdale
    Berkshire
    পরিচালক
    Park Cottage
    Broomfield Park
    SL5 0JT Sunningdale
    Berkshire
    AmericanCe-Legal Affairs & Co Secretar33159800001
    WALSH, John Lawrence
    The Boc Group
    Chertsey Road
    GU20 6HJ Windlesham
    Surrey
    পরিচালক
    The Boc Group
    Chertsey Road
    GU20 6HJ Windlesham
    Surrey
    AmericanChief Executive I & Sp77090210003

    EDWARDS VACUUM LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Share pledge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জুল, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ আগ, ২০০৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the loan party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All of its right, title and interest in, to and under its pledged shares and all dividends, see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Deutsche Bank Ag, New York Branch
    ব্যবসায়
    • ১২ আগ, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Deed of accession to a first lien debenture dated 31 may 2007 and
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ আগ, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ সেপ, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company formerly known as boc (europe) holdings limited to any lender counterparty or other person under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Deutsche Bank Ag New York Branch as Agent and Trustee for the Secured Parties
    ব্যবসায়
    • ১২ সেপ, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Deed of accession
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ আগ, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ সেপ, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company formerly known as boc (europe) holdings limited to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Deutsche Bank Ag New York Branch as Agent and Trustee for the Secured Parties
    ব্যবসায়
    • ১২ সেপ, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ এপ্রি, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)

    EDWARDS VACUUM LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২৯ জুল, ২০১৬ভেঙে গেছে
    ২৮ সেপ, ২০১৫ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Allan Watson Graham
    Kpmg Restructuring 15 Canada Square
    E14 5GL London
    অভ্যাসকারী
    Kpmg Restructuring 15 Canada Square
    E14 5GL London
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    অভ্যাসকারী
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0