PREGIS INTERNATIONAL LTD

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামPREGIS INTERNATIONAL LTD
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01200088
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    PREGIS INTERNATIONAL LTD এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদন (22290) / উৎপাদন

    PREGIS INTERNATIONAL LTD কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Aspect One
    Gunnels Wood Road
    SG1 2DG Stevenage
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    PREGIS INTERNATIONAL LTD এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    FP INTERNATIONAL (UK) LIMITED১৬ সেপ, ২০০২১৬ সেপ, ২০০২
    FLO-PAK (U.K.) LIMITED১৩ ফেব, ১৯৭৫১৩ ফেব, ১৯৭৫

    PREGIS INTERNATIONAL LTD এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০২১

    PREGIS INTERNATIONAL LTD এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ০১ জুন, ২০২৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Cornelis Johannes Maria Oostrom এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ জুন, ২০২৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Leon Poppegaai এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১০ মে, ২০২৩ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ০৩ নভে, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Leon Poppegaai-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২১ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    ১০ মে, ২০২২ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    ২৪ ডিসে, ২০২১ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Pregis Europe Limited এর বিবরণের পরিবর্তন

    2 পৃষ্ঠাPSC05

    legacy

    3 পৃষ্ঠাGUARANTEE2

    legacy

    1 পৃষ্ঠাAGREEMENT2

    legacy

    3 পৃষ্ঠাGUARANTEE2

    legacy

    1 পৃষ্ঠাAGREEMENT2

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    ১০ মে, ২০২১ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    ০১ জুন, ২০২০ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Fpi Holding Company B.V. এর বন্ধ

    1 পৃষ্ঠাPSC07

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    ০১ জুন, ২০২০ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Pregis Europe Limited এর বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাPSC02

    ১০ মে, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ১১ মে, ২০২০ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Victory House 400 Pavilion Drive Northampton Business Park Northampton NN4 7PA থেকে Aspect One Gunnels Wood Road Stevenage SG1 2DGপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩০ সেপ, ২০১৯ থেকে ৩১ ডিসে, ২০১৯ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    57 পৃষ্ঠাPARENT_ACC

    legacy

    1 পৃষ্ঠাAGREEMENT2

    PREGIS INTERNATIONAL LTD এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BAUDHUIN, Kevin
    Lake Cook Road
    60015 Deerfield
    1650
    Illinois
    United States
    পরিচালক
    Lake Cook Road
    60015 Deerfield
    1650
    Illinois
    United States
    United StatesAmerican204740650001
    LAVANWAY, Donald Keith
    Lake Cook Road
    60015 Deerfield
    1650
    Illinois
    United States
    পরিচালক
    Lake Cook Road
    60015 Deerfield
    1650
    Illinois
    United States
    United StatesAmerican204740660001
    BLOOD, James
    605 Pisces Lane
    Foster City
    California Ca 94404
    Usa
    সচিব
    605 Pisces Lane
    Foster City
    California Ca 94404
    Usa
    American69366890001
    GOODMAN, Stephen Tony
    4 Orchard Drive
    Off Royton Drive Whittle-Le-Woods
    PR7 1XJ Chorley
    Lancashire
    সচিব
    4 Orchard Drive
    Off Royton Drive Whittle-Le-Woods
    PR7 1XJ Chorley
    Lancashire
    British42598360002
    YOUNG, George Hunter
    Penn 11 Plough Hill
    Cuffley
    EN6 4DN Potters Bar
    Hertfordshire
    সচিব
    Penn 11 Plough Hill
    Cuffley
    EN6 4DN Potters Bar
    Hertfordshire
    British9667110001
    BRIGHTMAN, Geoffrey William
    38 Willow Drive
    Bourton Grange
    MK18 7JH Buckingham
    পরিচালক
    38 Willow Drive
    Bourton Grange
    MK18 7JH Buckingham
    British34946240001
    CAMPS, Rex
    c/o Sarah Higgins
    Pavilion Drive
    NN4 7PA Northampton
    400
    England
    পরিচালক
    c/o Sarah Higgins
    Pavilion Drive
    NN4 7PA Northampton
    400
    England
    NetherlandsDutch196700920001
    CLARK, Michael
    Abbotts Wood Hill Road
    Penwortham
    PR1 9XH Preston
    Lancs
    পরিচালক
    Abbotts Wood Hill Road
    Penwortham
    PR1 9XH Preston
    Lancs
    British3138650001
    CONNOR, Peter
    Carillon
    Bell Lane Syresham
    NN13 5HP Brackley
    Northamptonshire
    পরিচালক
    Carillon
    Bell Lane Syresham
    NN13 5HP Brackley
    Northamptonshire
    British10181590001
    DAVIES, David William
    77 Mably Grove
    OX12 9XW Wantage
    Oxfordshire
    পরিচালক
    77 Mably Grove
    OX12 9XW Wantage
    Oxfordshire
    United KingdomBritish98272270001
    FERNANDEZ, Dennis
    19684 Ashton Court
    Saratoga
    Santa Clara Ca 95070
    Usa
    পরিচালক
    19684 Ashton Court
    Saratoga
    Santa Clara Ca 95070
    Usa
    American69366850001
    GOODMAN, Stephen Tony
    4 Orchard Drive
    Off Royton Drive Whittle-Le-Woods
    PR7 1XJ Chorley
    Lancashire
    পরিচালক
    4 Orchard Drive
    Off Royton Drive Whittle-Le-Woods
    PR7 1XJ Chorley
    Lancashire
    British42598360002
    GRAHAM, Arthur
    700 Westridge Drive
    Portola Valley
    California Ca 94028
    Usa
    পরিচালক
    700 Westridge Drive
    Portola Valley
    California Ca 94028
    Usa
    UsaAmerican69366730001
    JACKSON, Steven
    c/o Sarah Higgins
    Pavilion Drive
    NN4 7PA Northampton
    400
    England
    পরিচালক
    c/o Sarah Higgins
    Pavilion Drive
    NN4 7PA Northampton
    400
    England
    UsaAmerican196714870001
    LANE, Gordon Stuart
    6 Park Road
    High Barnet
    EN5 5SQ Barnet
    Hertfordshire
    পরিচালক
    6 Park Road
    High Barnet
    EN5 5SQ Barnet
    Hertfordshire
    United KingdomBritish551970006
    MACFARLANE OF BEARSDEN, Lord
    50 Manse Road
    Bearsden
    G61 3PN Glasgow
    Strathclyde
    Scotland
    পরিচালক
    50 Manse Road
    Bearsden
    G61 3PN Glasgow
    Strathclyde
    Scotland
    British51933510001
    MACKIE, William Paterson
    Clearwater 1 Queens Point
    Shandon
    G84 8QZ Helensburgh
    Dunbartonshire
    Scotland
    পরিচালক
    Clearwater 1 Queens Point
    Shandon
    G84 8QZ Helensburgh
    Dunbartonshire
    Scotland
    British51933540001
    MARIA, Cornelis Johannes
    6422 Pd Heerlen
    Heerlen
    Nijverheidsweg 4
    Netherlands
    পরিচালক
    6422 Pd Heerlen
    Heerlen
    Nijverheidsweg 4
    Netherlands
    NetherlandsDutch255123480001
    MATTHEWS, John Robert
    14 Brick Kiln Close
    NN12 6TG Towcester
    Northamptonshire
    পরিচালক
    14 Brick Kiln Close
    NN12 6TG Towcester
    Northamptonshire
    British10181580001
    MOHENG, Jean Charles
    5 Rue Henry Monnier
    FOREIGN Paris
    75009
    France
    পরিচালক
    5 Rue Henry Monnier
    FOREIGN Paris
    75009
    France
    FranceFrench113500440001
    NEZWEK, Joe
    c/o Sarah Higgins
    Pavilion Drive
    NN4 7PA Northampton
    400
    England
    পরিচালক
    c/o Sarah Higgins
    Pavilion Drive
    NN4 7PA Northampton
    400
    England
    United StatesAmerican196719920001
    OOSTROM, Cornelis Johannes Maria
    6422 Pd
    Heerlen
    Nijverheidsweg 4
    Netherlands
    পরিচালক
    6422 Pd
    Heerlen
    Nijverheidsweg 4
    Netherlands
    NetherlandsDutch255316200001
    POPPEGAAI, Leon
    Walkern Road
    SG1 3QP Stevenage
    Richmond House
    Hertfordshire
    England
    পরিচালক
    Walkern Road
    SG1 3QP Stevenage
    Richmond House
    Hertfordshire
    England
    NetherlandsDutch305565750001
    VAN LEUSDEN, Casper Hubertus Antonius Titus
    400 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7PA Northampton
    Victory House
    পরিচালক
    400 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7PA Northampton
    Victory House
    NetherlandsDutch227961200001
    WALLACE, Richard Anthony
    3 Wolverton Road
    Marston Green
    B37 7XJ Solihull
    West Midlands
    পরিচালক
    3 Wolverton Road
    Marston Green
    B37 7XJ Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish92603420001
    YOUNG, George Hunter
    Penn 11 Plough Hill
    Cuffley
    EN6 4DN Potters Bar
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Penn 11 Plough Hill
    Cuffley
    EN6 4DN Potters Bar
    Hertfordshire
    EnglandBritish9667110001

    PREGIS INTERNATIONAL LTD এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Walkern Road
    SG1 3QP Stevenage
    Richmond House
    England
    ০১ জুন, ২০২০
    Walkern Road
    SG1 3QP Stevenage
    Richmond House
    England
    না
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    নিবন্ধিত দেশUk
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর09981936
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    Fpi Holding Company B.V.
    Nijverheidsweg 4
    6422 Pd
    Heerlen
    Nijverheidsweg 4
    Netherlands
    ০৯ মে, ২০১৬
    Nijverheidsweg 4
    6422 Pd
    Heerlen
    Nijverheidsweg 4
    Netherlands
    হ্যাঁ
    আইনি ফর্মB.V.
    নিবন্ধিত দেশNederlands
    আইনি কর্তৃপক্ষCompany Act In Holland
    নিবন্ধিত স্থানDutch Chamber Of Commerce
    নিবন্ধন নম্বর14052380
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।

    PREGIS INTERNATIONAL LTD এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ অক্টো, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ নভে, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The land adjoining buckingham road, brackley. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ নভে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ নভে, ২০১৩সমস্ত সম্পত্তি বা উদ্যোগ চার্জ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে (MR05)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ অক্টো, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ নভে, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The land on the south side of buckingham road, brackley and the land and buildings on the west side of boundary road and on the south side of buckingham road, brackley. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ নভে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ নভে, ২০১৩সমস্ত সম্পত্তি বা উদ্যোগ চার্জ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে (MR05)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ অক্টো, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ নভে, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ নভে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ নভে, ২০১৩সমস্ত সম্পত্তি বা উদ্যোগ চার্জ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে (MR05)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ এপ্রি, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ এপ্রি, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ এপ্রি, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ নভে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ এপ্রি, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ এপ্রি, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/Hold property known as land/blds on the west side of boundary road and on south side of buckingham rd,brackley,northamptonshire; t/nos HN12102 and HN11988.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ এপ্রি, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ নভে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0