STEAMHAMMER LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামSTEAMHAMMER LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01211110
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    STEAMHAMMER LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    STEAMHAMMER LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    STEAMHAMMER LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    KETLON (U.K.) LIMITED০৬ মে, ১৯৭৫০৬ মে, ১৯৭৫

    STEAMHAMMER LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১১

    STEAMHAMMER LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ স্থগিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাSOAS(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    4 পৃষ্ঠাDS01

    legacy

    2 পৃষ্ঠাSH20

    ০৪ সেপ, ২০১২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    5 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    2 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    5 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Share prem a/c cancelled 24/08/2012
    RES13

    বার্ষিক রিটার্ন ০৭ জুন, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৭ জুন, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Graham Philip Brisley Veal-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Kevin Blades এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৭ জুন, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Thomas Doerr এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Adrian David Gray-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    3 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    STEAMHAMMER LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    কর্পোরেট সচিব
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    94529700001
    GRAY, Adrian David
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    পরিচালক
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    United KingdomBritish146072380001
    JONES, Maurice Delon
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    পরিচালক
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    UsaAmerican134328700001
    KACHMER, Michael James
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    পরিচালক
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    United StatesAmerican136570610001
    VEAL, Graham Philip Brisley
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    পরিচালক
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    EnglandBritish43215170003
    BURROWES, Rosemary Anne
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    সচিব
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    British49687740001
    HOOPER, David Ross
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    সচিব
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    British17023730001
    SHAW, Roger
    182 Ramsgate Road
    CT10 2EW Broadstairs
    Kent
    সচিব
    182 Ramsgate Road
    CT10 2EW Broadstairs
    Kent
    British62309470001
    SYMS, Rhonda Sneddon
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    সচিব
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    British16978550002
    BENSLEY, Brian
    The Coppice
    20 Neville Park
    TN4 8NN Tunbridge Wells
    Kent
    পরিচালক
    The Coppice
    20 Neville Park
    TN4 8NN Tunbridge Wells
    Kent
    British41841490002
    BLADES, Kevin Nicholas
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    পরিচালক
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    EnglandBritish79449700002
    BOWKETT, Alan John
    Croxton Park
    Croxton
    PE19 6SY St Neots
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    Croxton Park
    Croxton
    PE19 6SY St Neots
    Cambridgeshire
    EnglandBritish33301630002
    BRAY, Kenneth Ivor
    Garden Cottage Church Street
    Denton
    NG32 1LE Grantham
    Lincolnshire
    পরিচালক
    Garden Cottage Church Street
    Denton
    NG32 1LE Grantham
    Lincolnshire
    British45153770001
    BUTLER, Peter Robert
    Gifford House
    22 Chalklands Howe Green
    CM2 7TH Chelmsford
    Essex
    পরিচালক
    Gifford House
    22 Chalklands Howe Green
    CM2 7TH Chelmsford
    Essex
    British34707070001
    CUTHBERTSON, George Brian
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    পরিচালক
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish6996370001
    DIXON, Peter John Bellett, Sir
    34 Canonbury Park North
    N1 2JJ London
    পরিচালক
    34 Canonbury Park North
    N1 2JJ London
    United KingdomBritish4902740001
    DOERR, Thomas
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    পরিচালক
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    United States134081280001
    GILL, Martin John
    24 Parkwood Road
    Wimbledon
    SW19 7AQ London
    পরিচালক
    24 Parkwood Road
    Wimbledon
    SW19 7AQ London
    EnglandBritish58291030001
    HOOPER, David Ross
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    British17023730002
    MULHALL, Denis Joseph
    Fitzgeorge House
    Fitzgeorge Avenue
    KT3 4SH New Malden
    Surrey
    পরিচালক
    Fitzgeorge House
    Fitzgeorge Avenue
    KT3 4SH New Malden
    Surrey
    EnglandBritish,Irish32235150003
    O'CONNOR, Patrick Finbarr
    66 Cumberland Mills Square
    Saunders Ness Road
    E14 3BJ Isle Of Dogs
    London
    মনোনীত পরিচালক
    66 Cumberland Mills Square
    Saunders Ness Road
    E14 3BJ Isle Of Dogs
    London
    British/Irish900010100001
    SIMON, Avram Ben
    11 Cenacle Close
    West Heath Road
    NW3 7UE London
    পরিচালক
    11 Cenacle Close
    West Heath Road
    NW3 7UE London
    EnglandBritish10668930001
    BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    কর্পোরেট পরিচালক
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310650003
    S & W BERISFORD LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    কর্পোরেট পরিচালক
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310610006

    STEAMHAMMER LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002
    তৈরি করা হয়েছে ১১ এপ্রি, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ এপ্রি, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    ব্যবসায়
    • ২৫ এপ্রি, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ মার্চ, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ফেব, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ মার্চ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    ব্যবসায়
    • ০৮ মার্চ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ মার্চ, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent)
    তৈরি করা হয়েছে ২০ নভে, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ নভে, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ নভে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ মার্চ, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of gurantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ মে, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ মে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from thecompany and/or wichman bennett machine tool company limited to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The several properties specified or form M395, together with (see form M395, ref M520C per full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Berisford International PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ মে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২২ এপ্রি, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Gurantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ মে, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ জানু, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from transmake limited to the chargee under the terms of the loan facility dated 24 may'85
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land & buildings at paddock wood kent title no. 528918 and adjacent industrial units title no's K.347491,K.407742,K.343687K.354594 And K.493938. also l/h land at paddock wood title no.K33621 fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinerty including stock in trade.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • S & W Berisford PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ জানু, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২২ এপ্রি, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattel mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ ডিসে, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ ডিসে, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 3/4/84
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    One okuma latle LC20-r-2SC nc lathe (ncmt no 1527 serial no 0912 together with swarf conveyor system, cutting tools transfer conveyor system and central processing unit including display and interface.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Security Pacific International Leasing (Europe) Inc.
    ব্যবসায়
    • ০৫ ডিসে, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৪ ডিসে, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattel mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ এপ্রি, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ এপ্রি, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 3RD april 1984 and/or this deed.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    One ohuma LC20R-25C N.C. lathe (nomt number 1489 serial number 0884) together with swarf conveyer systems, aitting tool, transfer conveyer system and central processing unit including display and intenface.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Security Pacific International Leasing (Europe) Inc.
    ব্যবসায়
    • ০৫ এপ্রি, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৪ ডিসে, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattel mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ জুল, ১৯৮৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ জুল, ১৯৮৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £250,000 and other monies due under the terms of the charge.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Build no goods serial no 2024 churchill 5815 rigid hobber - 2036 chirchill 5815 rigid hobber - 2026 chirchill 5815 rigid hobber - 2035 churchill 5815 rigid hobber H966 1028 wickman 71/4 x 6" chucker 620806 1029 wickman 71/4 x 6" chucker 550206.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lombard North Central PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ জুল, ১৯৮৩একটি চার্জের নিবন্ধন
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ জানু, ১৯৮৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ জানু, ১৯৮৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific aquitable charge over all f/hold & l/hold properties. Fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill licenses together with the machinery and equipment specified in the debenture. Legal mortgage over l/hold land on the north and south sides of lucknow road, paddock wood, tunbridge wells, kent. Title no. K528918.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Trust Company of Canada.
    ব্যবসায়
    • ২৭ জানু, ১৯৮৩একটি চার্জের নিবন্ধন
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ জানু, ১৯৮৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ জানু, ১৯৮৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed & floating charges over undertaking and all property including l/hold land on the north and south sides of lucknow road, paddock wood, tunbridge wells kent. Title no. K528918.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Govenor & Company of the Bank of Ireland.
    ব্যবসায়
    • ২৭ জানু, ১৯৮৩একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ নভে, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ নভে, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £2,500,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H lying on the north & south sides of lucknow road padolock wood dunbridge wells title no. K528918.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Norwich General Trust Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ নভে, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    Supplemental charge
    তৈরি করা হয়েছে ২১ জুন, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ জুন, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    Further securing the monies secured by the principal deed dated 16 dec'81.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Specific charge all bookdebts & other debts at present or in future owing to the company for full details please see doc M21.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Allied Irish Investment Bank
    ব্যবসায়
    • ২৩ জুন, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ মে, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ মে, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £4808,000.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Various spindle bar automotic with tooling and accesseries. For full details please see document M20.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Allied Irish Finance Company Limited
    ব্যবসায়
    • ২৭ মে, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ ডিসে, ১৯৮১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ ডিসে, ১৯৮১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific fixed charge over all plant & machinery present & future undertaking and all assets present and future and specfically including the leasehold land with buildings now or hereafter situate thereon bying on the north side of hucksnow road paddocks wood, tunbridge well kent.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • N. V. Tlavenburg's Banks.
    ব্যবসায়
    • ৩০ ডিসে, ১৯৮১একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ ডিসে, ১৯৮১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ ডিসে, ১৯৮১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    8 eldon way paddocks wood, kent (leasehold) title no. K347491 44 eldon way paddocks wood, kent (leasehold) title no. K354594.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • N. V Tlavenburg's Banks
    ব্যবসায়
    • ৩০ ডিসে, ১৯৮১একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ ডিসে, ১৯৮১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ ডিসে, ১৯৮১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    22 to 36 (even numbers) eldon way paddocls wood, tunbridge wells, kent (leasehold). Title no. K493938.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • N.V Tlavenburg's Banks.
    ব্যবসায়
    • ৩০ ডিসে, ১৯৮১একটি চার্জের নিবন্ধন
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ ডিসে, ১৯৮১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ ডিসে, ১৯৮১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All estates or interests many f/hold and l/hold property. All stocks, shares and other securities or other interests, goodwill, all its other property, assets and rights and all undertaking & other property, assets & rights.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Allied Irish Investment Banks Limited
    ব্যবসায়
    • ২৪ ডিসে, ১৯৮১একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ ডিসে, ১৯৮১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ ডিসে, ১৯৮১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/Hold property, land & buildings at hucknow road, paddocls wood, tunbridge wells, kent.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Allied Irish Investment Bank Limited
    ব্যবসায়
    • ২৪ ডিসে, ১৯৮১একটি চার্জের নিবন্ধন
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ অক্টো, ১৯৮০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ অক্টো, ১৯৮০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £207,000
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    One wickman 1 3/8" six spindle bar automatic no 590071. one cone aut omotic machine company conomatic 4" six spindle bar automatic no.833652. One wickman 2 1/4" six spindle automotic no. 601327. threewickman 1" six spindle bar automatics nos. 610122,560243 & 551040 (see doc M14).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Allied Irish Finance Company Limited.
    ব্যবসায়
    • ১৫ অক্টো, ১৯৮০একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0