VIRGIN STUDIOS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামVIRGIN STUDIOS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01214591
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    VIRGIN STUDIOS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    VIRGIN STUDIOS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    364-366 Kensington High Street
    W14 8NS London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    VIRGIN STUDIOS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    MANOR STUDIOS (HOLDINGS) LIMITED৩১ ডিসে, ১৯৭৬৩১ ডিসে, ১৯৭৬
    VIRGIN RECORDING STUDIOS (HOLDINGS) LIMITED০২ জুন, ১৯৭৫০২ জুন, ১৯৭৫

    VIRGIN STUDIOS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৪

    VIRGIN STUDIOS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    9 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৫ জানু, ২০১৬

    ১৫ জানু, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    ১৩ ফেব, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr David Richard James Sharpe-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৩ ফেব, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Adam Martin Barker-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৫ জানু, ২০১৫

    ০৫ জানু, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর সংক্ষিপ্ত ৩১ মার্চ, ২০১৪ থেকে ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০২ জানু, ২০১৪

    ০২ জানু, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    ২৭ সেপ, ২০১৩ তারিখে Mr Richard Michael Constant-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২৮ সেপ, ২০১২ তারিখে Mr Richard Michael Constant-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০৮ ফেব, ২০১৩ তারিখে Mr Andrew Brown-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০৮ ফেব, ২০১৩ তারিখে Mr Boyd Johnston Muir-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা 5Th Floor 6 St. Andrew Street London EC4A 3AE United Kingdom থেকে পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    সচিব হিসাবে Mrs Abolanle Abioye-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    সচিব হিসাবে Tmf Corporate Administration Services Limited এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    পরিচালক হিসাবে David Kassler এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Mr Boyd Johnston Muir-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    VIRGIN STUDIOS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    ABIOYE, Abolanle
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    সচিব
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    174414410001
    BARKER, Adam Martin
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    পরিচালক
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    EnglandBritishLawyer162279360001
    BROWN, Andrew
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    পরিচালক
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    EnglandBritishInternational Chief Financial Officer163199590001
    CONSTANT, Richard Michael
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    পরিচালক
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    United KingdomBritishGeneral Counsel43836310003
    MUIR, Boyd Johnston
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    পরিচালক
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    United StatesBritishEvp & Cfo172824510001
    SHARPE, David Richard James
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    পরিচালক
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    EnglandIrishChief Operating Officer166109150001
    HANSON, Ian Lawrence
    House On The Hill
    Beechwood Drive
    SL7 2DH Marlow
    Buckinghamshire
    সচিব
    House On The Hill
    Beechwood Drive
    SL7 2DH Marlow
    Buckinghamshire
    BritishDirector Legal & Business Affa99645000001
    HOPKINS, Gareth John
    Ashwells Lodge Cock Lane
    Tylers Green
    HP10 8DS Penn
    Buckinghamshire
    সচিব
    Ashwells Lodge Cock Lane
    Tylers Green
    HP10 8DS Penn
    Buckinghamshire
    BritishCompany Secretary43090870002
    RITCHIE, Ian
    66 Cherwell Drive
    Marston
    OX3 0LZ Oxford
    Oxfordshire
    সচিব
    66 Cherwell Drive
    Marston
    OX3 0LZ Oxford
    Oxfordshire
    British68246050001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    কর্পোরেট সচিব
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    39182980003
    TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    6 St Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th Floor
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    6 St Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th Floor
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর06902863
    140723560001
    ALEXANDER, Stephen Harold
    39 Wandle Road
    SW17 7DL London
    পরিচালক
    39 Wandle Road
    SW17 7DL London
    United KingdomBritishOperational Md126427510001
    BATES, Antony Jeffrey
    Kingsmere House
    The Starlings
    KT22 0QN Oxshott
    Surrey
    পরিচালক
    Kingsmere House
    The Starlings
    KT22 0QN Oxshott
    Surrey
    BritishFinance Director36860990001
    BENGE, Martin
    59 Blandford Road
    W4 1EA London
    পরিচালক
    59 Blandford Road
    W4 1EA London
    BritishVice President Emi Studios41219460001
    BENNETT, Stephen Thomas
    3 Lime Chase
    Fryern Road
    RH20 4LX Storrington
    West Sussex
    পরিচালক
    3 Lime Chase
    Fryern Road
    RH20 4LX Storrington
    West Sussex
    BritishHr Director64111720001
    CHADD, Andrew Peter
    The Old Pheasantry
    Woodcock Hill
    RH19 2RB Felbridge
    West Sussex
    পরিচালক
    The Old Pheasantry
    Woodcock Hill
    RH19 2RB Felbridge
    West Sussex
    United KingdomBritishDirector133578890002
    D'URBANO, David
    Heathfield Gardens
    W4 4JX London
    36
    পরিচালক
    Heathfield Gardens
    W4 4JX London
    36
    United KingdomUsaFinance Director167402770002
    DAVIDSON, Ian Philip
    Old Orchard 17 Drakes Close
    KT10 8PQ Esher
    Surrey
    পরিচালক
    Old Orchard 17 Drakes Close
    KT10 8PQ Esher
    Surrey
    BritishDirector Of Operations60138310001
    EMBEREY, Ivor Lloyd
    31 Niton Street
    Fulham
    SW6 6NH London
    পরিচালক
    31 Niton Street
    Fulham
    SW6 6NH London
    BritishFinance Director32565970003
    FAXON, Roger Conant
    Ninth Avenue
    4th Floor
    NY 10011 New York
    75
    Usa
    পরিচালক
    Ninth Avenue
    4th Floor
    NY 10011 New York
    75
    Usa
    UsaAmericanChairman & Ceo Emi Music Publishing161824550001
    FRENCH, Julian
    25 Chesterton Road
    W10 5LY London
    পরিচালক
    25 Chesterton Road
    W10 5LY London
    EnglandBritish,AmericanBusiness Affairs Director75990700002
    HANSON, Ian Lawrence
    House On The Hill
    Beechwood Drive
    SL7 2DH Marlow
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    House On The Hill
    Beechwood Drive
    SL7 2DH Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector Legal & Business Affa99645000001
    HOPKINS, Gareth John
    Ashwells Lodge Cock Lane
    Tylers Green
    HP10 8DS Penn
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Ashwells Lodge Cock Lane
    Tylers Green
    HP10 8DS Penn
    Buckinghamshire
    BritishLegal Director43090870002
    JEFFRIES, Barbara
    Ashbank
    Heyford Road
    OX6 8SH Middleton Stoney
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Ashbank
    Heyford Road
    OX6 8SH Middleton Stoney
    Oxfordshire
    BritishCompany Director11923020001
    KASSLER, David Nicholas
    Wrights Lane
    W8 5SW London
    27
    United Kingdom
    পরিচালক
    Wrights Lane
    W8 5SW London
    27
    United Kingdom
    EnglandBritish,AmericanConsultant139908820001
    KENNEDY, Christopher John
    31 Bath Road
    Chiswick
    W4 1LJ London
    পরিচালক
    31 Bath Road
    Chiswick
    W4 1LJ London
    United KingdomBritishFinance Director62227310005
    KENNEDY, Christopher John
    31 Bath Road
    Chiswick
    W4 1LJ London
    পরিচালক
    31 Bath Road
    Chiswick
    W4 1LJ London
    United KingdomBritishFinance Director62227310005
    MACMILLAN, Wallace
    34 Copperfields
    West Wycombe Road
    HP12 4AN High Wycombe
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    34 Copperfields
    West Wycombe Road
    HP12 4AN High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director41094270001
    MORRIS, Justin Henry
    Walnut Cottage
    Village Road
    TW20 8UG Thorpe
    Surrey
    পরিচালক
    Walnut Cottage
    Village Road
    TW20 8UG Thorpe
    Surrey
    United KingdomBritishCfo Emi Music Uk & Ireland102903550001
    NAUGHTON, Shane Paul
    Wrights Lane
    W8 5SW London
    27
    United Kingdom
    পরিচালক
    Wrights Lane
    W8 5SW London
    27
    United Kingdom
    EnglandIrishChartered Accountant150186560001
    PEDERSEN, Kenneth James
    16 Queensdale Place
    W11 4SQ London
    পরিচালক
    16 Queensdale Place
    W11 4SQ London
    AmericanAccountant28934360001
    PRIOR, Ruth Catherine
    Wrights Lane
    W8 5SW London
    27
    United Kingdom
    পরিচালক
    Wrights Lane
    W8 5SW London
    27
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant161825160001
    PUNJA, Riaz
    Apartment 31 Albert Bridge House
    127 Albert Bridge Road
    SW11 4PA London
    পরিচালক
    Apartment 31 Albert Bridge House
    127 Albert Bridge Road
    SW11 4PA London
    United KingdomBritishCompany Director58870910002
    ROLING, Christopher John
    82 Oak End Way
    SL9 8DB Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    82 Oak End Way
    SL9 8DB Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British AmericanManaging Director119379800001
    TOWNSEND, Kenneth Norman
    8 Goddington Road
    SL8 5TZ Bourne End
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    8 Goddington Road
    SL8 5TZ Bourne End
    Buckinghamshire
    BritishRecording Executive16390630001

    VIRGIN STUDIOS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A recorded music division security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০১ অক্টো, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ অক্টো, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the obligors and the participating employers on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All of its copyrights which are governed by english law, all of its music contracts and exploitation contracts, and all receivables relating to any copyright asset. Floating charge all of its assets see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citibank N.A. London Branch (The Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ১০ অক্টো, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ ডিসে, ২০১১বিবৃতি যে সম্পত্তির একটি অংশ বা সমস্ত চার্জ মুক্তি পেয়েছে (MG04)
    • ২৬ নভে, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    A deed of accession and charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ জানু, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ জানু, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the obligors and the participating employers under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citibank, N.A., London Branch (The Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ৩১ জানু, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ ডিসে, ২০১১বিবৃতি যে সম্পত্তির একটি অংশ বা সমস্ত চার্জ মুক্তি পেয়েছে (MG04)
    • ২৬ নভে, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ অক্টো, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ নভে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent and trustee for the banks) under the terms of a loan agreement of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Glebe cottage benbury road shipton-upon-cherwell oxfordshire together with all buildings and fixtures (including trade and tenants fixtures) title no on 98777.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Standard Chartered Bank
    ব্যবসায়
    • ০৬ নভে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ৩০ জুল, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ অক্টো, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ নভে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent and turstee for the banks) under the terms of a loan agreement of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    115 thessaly road london SW8 title no sgl 150130 together with all buildings and fixtures (including trade and tenants fixtures).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Standard Chartered Bank
    ব্যবসায়
    • ০৬ নভে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ৩০ জুল, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ অক্টো, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ নভে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent and trustee for the banks) under the tersm of a loan agreement of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Shipton manor shipton-upon-cherwell title no on 98890 together with all buildings and fixtures (including trade and tenants fixtures).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Standerd Chartered Bank
    ব্যবসায়
    • ০৬ নভে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ৩০ জুল, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ অক্টো, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ নভে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent and rrustee for the banks) under the terms of a loan agreement of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    4, st stephens avenue stepherds bush. London W12 title no ln 202802 together with all buildings and fixtures (including trade and tenants fixtures).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Standerd Chartered Bank
    ব্যবসায়
    • ০৬ নভে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ৩০ জুল, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ অক্টো, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ নভে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent and trustee for the banks) under the terms of a loan agreement of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Lower ground and basement floors 150, goldhawk road london W12 title no. Ngl 628172 together with all buildings and fixtures (including trade and tenants fixtures).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Standerd Chertered Bank
    ব্যবসায়
    • ০৬ নভে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ৩০ জুল, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ অক্টো, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ নভে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent and trustee for the banks) under the terms of a loan agreement of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The property k/a attenaeum godolphin road being land of the rear of 140/150 goldhawk road london W12 and 150 goldhawk road london W12 title no ngl 322516 together with all buildings and fixtures (including trade and tenants fixtures).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Standerd Chartered Bank
    ব্যবসায়
    • ০৬ নভে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ৩০ জুল, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ অক্টো, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ নভে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent and trustee for the banks) under the terms of a loan agreement of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    14IA, goldhawk road, london W12 title no 237591 together with all buildings and fixtures (including trade and tenants fixtures).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Standerd Chartered Bank
    ব্যবসায়
    • ০৬ নভে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ৩০ জুল, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ অক্টো, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ নভে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent and trustee for the banks) under the terms of a loan agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    142, goldhainok road, london W12 title no ngl 632832 together with all buildings and fixtures (including trade and tenants fixtures.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Standerd Chartered Bank
    ব্যবসায়
    • ০৬ নভে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ৩০ জুল, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ অক্টো, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ নভে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent and trustee for the banks) under the terms of a loan agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    1, godolphin road, london W12 title no ngl 343371 together with all buildings and fixtures (including trade and tenants fixtures).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Standered Chartered Bank
    ব্যবসায়
    • ০৬ নভে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ৩০ জুল, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মার্চ, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ মার্চ, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the secured parties under the terms of a credit agreement dated 11/11/88 and pursuant to a guarantee of eve date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citibank N.A.
    ব্যবসায়
    • ১৭ মার্চ, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ আগ, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ আগ, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys due or to become from the company trust deed and/or any of the other existing companies as defined in the charge to citibank N.A. as trustee & for further securing all moneys due or to become due from virgin atlantic aisways limited to citibank N.A.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (See doc m 20 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citibank N.A.as Trustee for the Beneficiances
    ব্যবসায়
    • ২১ আগ, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ অক্টো, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ নভে, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over the companys f/h or l/h properties fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Coutts & Company
    ব্যবসায়
    • ০৭ নভে, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১২ এপ্রি, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ এপ্রি, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    115 thessaly road, battersea, london SW8 title no sgl 150130 and/ror the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Coutts & Company Bankers
    ব্যবসায়
    • ১২ এপ্রি, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0