MSQ PROPERTY LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামMSQ PROPERTY LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01257888
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    MSQ PROPERTY LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    MSQ PROPERTY LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    c/o MSQ PARTNERS LIMITED
    90 Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    MSQ PROPERTY LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    ARKEN P.O.P. LIMITED২১ নভে, ২০০৬২১ নভে, ২০০৬
    COUTTS ARKEN DISPLAY LIMITED০৩ এপ্রি, ২০০১০৩ এপ্রি, ২০০১
    ARKEN DISPLAY SOLUTIONS LIMITED ২২ ডিসে, ১৯৯৯২২ ডিসে, ১৯৯৯
    LOPPING DISPLAY HOLDINGS LIMITED১১ মে, ১৯৭৬১১ মে, ১৯৭৬

    MSQ PROPERTY LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে২৮ ফেব, ২০১৭

    MSQ PROPERTY LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২৮ ফেব, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    ০৬ মার্চ, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত পরিদর্শন স্থান 15th Floor 6 Bevis Marks London EC3A 7BA এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD03

    পূর্ণ হিসাব ২৯ ফেব, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৬ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৪ মার্চ, ২০১৬

    ২৪ মার্চ, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 97,004
    SH01

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা 10 Rathbone Place London W1T 1HP England থেকে 15th Floor 6 Bevis Marks London EC3A 7BA এ পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা C/O Msq Partners Limited 90 Tottenham Court Road London W1T 4TJ এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD04

    পূর্ণ হিসাব ২৮ ফেব, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৬ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৯ মার্চ, ২০১৫

    ০৯ মার্চ, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 97,004
    SH01

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত পরিদর্শন স্থান 10 Rathbone Place London W1T 1HP এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD03

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা 10 Rathbone Place London W1T 1HP এ পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    অডিট ছাড় সহায়ক হিসাব ২৮ ফেব, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    29 পৃষ্ঠাPARENT_ACC

    legacy

    1 পৃষ্ঠাAGREEMENT2

    legacy

    3 পৃষ্ঠাGUARANTEE2

    চার্জ 012578880017 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 14 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 16 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 15 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    ১৩ আগ, ২০১৪ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা C/O Msq Partners Ltd 6 York Street London W1U 6PL থেকে C/O Msq Partners Limited 90 Tottenham Court Road London W1T 4TJপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৬ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৬ মার্চ, ২০১৪

    ০৬ মার্চ, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 97,004
    SH01

    অডিট ছাড় সহায়ক হিসাব ২৮ ফেব, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    MSQ PROPERTY LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    SHAH, Ashish
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    সচিব
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    164763320002
    REID, Peter David
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    পরিচালক
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    EnglandBritishDirector147274580002
    YARDLEY, Daniel John
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    পরিচালক
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer180507300001
    ALEXANDER, Charles Stuart
    24 Waveney Close
    Kennet Street
    E1W 2JL London
    সচিব
    24 Waveney Close
    Kennet Street
    E1W 2JL London
    BritishAccountant66329190001
    BRIGDEN, Colin John
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    সচিব
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    147329570001
    CLARKE, Martin John
    105 Congleton Road
    SK11 7XD Macclesfield
    Cheshire
    সচিব
    105 Congleton Road
    SK11 7XD Macclesfield
    Cheshire
    British53461320002
    MULVEY, Patrick Brendan
    Amberley
    Newmarket Road Hare Street Village
    SG9 0EU Buntingford
    Hertfordshire
    সচিব
    Amberley
    Newmarket Road Hare Street Village
    SG9 0EU Buntingford
    Hertfordshire
    British66697290001
    PENN, John Robert
    Wish Cottage Avey Lane
    High Beech
    IG10 4AB Loughton
    Essex
    সচিব
    Wish Cottage Avey Lane
    High Beech
    IG10 4AB Loughton
    Essex
    British7147450001
    WINFIELD, Bruce Malcolm
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    সচিব
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    British147948820001
    ALEXANDER, Charles Stuart
    24 Waveney Close
    Kennet Street
    E1W 2JL London
    পরিচালক
    24 Waveney Close
    Kennet Street
    E1W 2JL London
    BritishAccountant66329190001
    ANDREW, Vincent Leo
    The Maltings
    Brewery Yard
    NN14 3BT Subborough
    Northants
    পরিচালক
    The Maltings
    Brewery Yard
    NN14 3BT Subborough
    Northants
    BritishDirector116947660001
    ATHERTON, Graham John
    9 The Severals
    Bury Road
    CB8 7YN Newmarket
    Suffolk
    পরিচালক
    9 The Severals
    Bury Road
    CB8 7YN Newmarket
    Suffolk
    BritishDirector62061040006
    BELL, Patrick Charles
    Coles Barn
    Belchamp Otten
    CO10 7BG Sudbury
    Suffolk
    পরিচালক
    Coles Barn
    Belchamp Otten
    CO10 7BG Sudbury
    Suffolk
    United KingdomBritishDirector71758630001
    BURNS, Graeme Ian, Mr.
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    পরিচালক
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    United KingdomBritishAccountant75720570001
    CAHN, Christopher Charles
    39 Anchorage Point
    Cuba Street
    E14 8NF London
    পরিচালক
    39 Anchorage Point
    Cuba Street
    E14 8NF London
    BritishDirector85328320001
    COX, Adrian
    Montemayor The Old Golf House
    3a Brandon Road
    IP24 3ND Thetford
    Norfolk
    পরিচালক
    Montemayor The Old Golf House
    3a Brandon Road
    IP24 3ND Thetford
    Norfolk
    United KingdomBritishDirector80097630004
    ESSEX, Robert Thomas Tickler
    21 Rylett Road
    W12 9SS London
    পরিচালক
    21 Rylett Road
    W12 9SS London
    EnglandBritishDirector7666390002
    EVANS, John Russell
    6 Poyntz Gardens
    Dallington
    NN5 7RY Northampton
    Northamptonshire
    পরিচালক
    6 Poyntz Gardens
    Dallington
    NN5 7RY Northampton
    Northamptonshire
    BritishDirector46914950002
    FRANCE, George
    Brook House
    Lower Dean
    PE28 0LL Huntingdon
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    Brook House
    Lower Dean
    PE28 0LL Huntingdon
    Cambridgeshire
    BritishDirector76684220001
    HARRIS, Graeme Richard
    35 Allerton Road
    N16 5UF London
    পরিচালক
    35 Allerton Road
    N16 5UF London
    EnglandBritishDirector56342040002
    HEMPSALL, Andrew Mark
    Aldgate Court
    Station Road
    PE9 3AY Ketton
    13
    Rutland
    পরিচালক
    Aldgate Court
    Station Road
    PE9 3AY Ketton
    13
    Rutland
    EnglandBritishDirector194699020001
    HUTCHINSON, David William
    6 Burwell Road
    PE19 7QQ St. Neots
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    6 Burwell Road
    PE19 7QQ St. Neots
    Cambridgeshire
    BritishCompany Director117495430001
    JARVIS, Trevor William
    Markham House Colethorpe Lane
    Barrow
    IP29 5BG Bury St Edmunds
    Suffolk
    পরিচালক
    Markham House Colethorpe Lane
    Barrow
    IP29 5BG Bury St Edmunds
    Suffolk
    EnglandBritishCompany Director63112430001
    KEEN, David Alan
    60 Garnetts
    Takeley
    CM22 6RN Bishops Stortford
    Hertfordshire
    পরিচালক
    60 Garnetts
    Takeley
    CM22 6RN Bishops Stortford
    Hertfordshire
    BritishDirector/Accountant16642410001
    KINGDON, Martin Anthony
    Sheridan House
    Castle Street, Keinton Mandeville
    TA11 6DX Somerton
    Somerset
    পরিচালক
    Sheridan House
    Castle Street, Keinton Mandeville
    TA11 6DX Somerton
    Somerset
    BritishDirector67712160001
    MIDDLETON, Arthur Jeremy Barritt
    Corbar Hall
    Corbar Road
    SK17 6TF Buxton
    পরিচালক
    Corbar Hall
    Corbar Road
    SK17 6TF Buxton
    EnglandBritishCompany Director72455560001
    MULVEY, Patrick Brendan
    Amberley
    Newmarket Road Hare Street Village
    SG9 0EU Buntingford
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Amberley
    Newmarket Road Hare Street Village
    SG9 0EU Buntingford
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector66697290001
    OLIVER, David Martin
    Spring Barn
    College Court
    PE28 9QS Hilton
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    Spring Barn
    College Court
    PE28 9QS Hilton
    Cambridgeshire
    BritishFinance Director76827470001
    PENN, John Robert
    Wish Cottage Avey Lane
    High Beech
    IG10 4AB Loughton
    Essex
    পরিচালক
    Wish Cottage Avey Lane
    High Beech
    IG10 4AB Loughton
    Essex
    BritishAdvertising Executive7147450001
    PENN, Mary Elizabeth
    Wish Cottage Avey Lane
    High Beech
    IG10 4AB Loughton
    Essex
    পরিচালক
    Wish Cottage Avey Lane
    High Beech
    IG10 4AB Loughton
    Essex
    BritishSecretary7147460001
    PENN, Robert John
    South Lodge
    Hamilton Court
    CB8 0NG Newmarket
    Suffolk
    পরিচালক
    South Lodge
    Hamilton Court
    CB8 0NG Newmarket
    Suffolk
    BritishDirector66696660001
    PETTLER, Mark
    C/O Media Square Plc, Clarence
    Mill, Clarence Road
    SK10 5JZ Bollington
    Cheshire
    পরিচালক
    C/O Media Square Plc, Clarence
    Mill, Clarence Road
    SK10 5JZ Bollington
    Cheshire
    EnglandBritishDirector137907750002
    PITMAN, Giles William
    Penny Cottage
    Albury
    SG11 2LX Ware
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Penny Cottage
    Albury
    SG11 2LX Ware
    Hertfordshire
    BritishCompany Director13341960001
    SCUTT, Tracy Ellen
    39 Shelford Road
    CB2 2LZ Cambridge
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    39 Shelford Road
    CB2 2LZ Cambridge
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishSales And Marketing Director65111610001
    WEALD, Raymond William
    2 Rendlesham Close Wengeo Lane
    SG12 0DR Ware
    Herts
    পরিচালক
    2 Rendlesham Close Wengeo Lane
    SG12 0DR Ware
    Herts
    BritishMarketing Executive11890880001

    MSQ PROPERTY LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Msq Holdings Limited
    90 Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    C/O Msq Partners Limited
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    90 Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    C/O Msq Partners Limited
    England
    না
    আইনি ফর্মPrivate Company Limited By Shares
    নিবন্ধিত দেশUk
    আইনি কর্তৃপক্ষUk (England + Wales)
    নিবন্ধিত স্থানUk (England) - Companies House
    নিবন্ধন নম্বর01382912
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    MSQ PROPERTY LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ সেপ, ২০১৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ অক্টো, ২০১৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Notification of addition to or amendment of charge.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    ব্যবসায়
    • ০৪ অক্টো, ২০১৩একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ০২ সেপ, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Supplemental debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ ফেব, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ২০১২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ২৩ ফেব, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০২ সেপ, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ ডিসে, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ ডিসে, ২০১১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum standing to the credit of an account whether in sterling or any other currency or currency unit and the debt from time to time owing by the bank represented by that sum see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ ডিসে, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০২ সেপ, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ ডিসে, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ ডিসে, ২০১১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ ডিসে, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০২ সেপ, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ডিসে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ ডিসে, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Money in a deposit account.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • L.J.A. Miers & Company Limited
    ব্যবসায়
    • ২৩ ডিসে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ ফেব, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ নভে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ নভে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land k/a plot 10 studlands park industrial estate, studlands park avenue, newmarket, suffolk t/no's SK89605 and SK96605 and land and buildings on the north east side of exning road, studlands park industrial estate t/no SK200747. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১৭ নভে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ ডিসে, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ অক্টো, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property at plot 10, studlands park industrial estate, studlands park avenue, newmarket, suffolk, t/no SK89605, SK96605 and SK20074. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ অক্টো, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ ফেব, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ অক্টো, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ অক্টো, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ ফেব, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২১ আগ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ আগ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ আগ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ অক্টো, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ ডিসে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ জানু, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    0.95 acres of land at studlands park industrial estate comprised in the conveyance dated 1 april 1986 and made between lopping display holdings limited (1) and arken display limited (2).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ জানু, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ অক্টো, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ জুন, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ জুন, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ জুন, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ অক্টো, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ অক্টো, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ নভে, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Phase iii unit 10 studlands park, industrial estate, exning road, newmarket, suffolk.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ নভে, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০১ অক্টো, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ সেপ, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ সেপ, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a hase 3 at unit 10, studlands park industrial estate, exning road, newmarket, suffolk and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ সেপ, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০১ অক্টো, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ মে, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ জুন, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    Securing £316,000 and all other moneys due or to become due from the company to charge star insurance company limited
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that f/hold land and buildings thereon as unit 10 studlands park industrial estate, studlands park avenue. Newmarket suffolk being the whole of the land remaining in and contained in a conveyance.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Eagle Star Insurance Company Limited
    ব্যবসায়
    • ০২ জুন, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০১ অক্টো, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Further guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ এপ্রি, ১৯৮৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ মে, ১৯৮৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ মে, ১৯৮৩একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০১ অক্টো, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ জুল, ১৯৮১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ জুল, ১৯৮১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property being 3 & 1 acres of land at studlords park industrial development newmarket, suffolk.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ জুল, ১৯৮১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০১ অক্টো, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ জুন, ১৯৮১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ জুন, ১৯৮১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts & uncalled capital. With all buildings fixtures (incl. Trade fixtures) fixed plant machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ জুন, ১৯৮১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০১ অক্টো, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0