COLUMBIA RIBBON MANUFACTURING COMPANY LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCOLUMBIA RIBBON MANUFACTURING COMPANY LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01277895
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    COLUMBIA RIBBON MANUFACTURING COMPANY LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (3002) /

    COLUMBIA RIBBON MANUFACTURING COMPANY LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    COLUMBIA RIBBON MANUFACTURING COMPANY LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    COLUMBIA RIBBON & CARBON MANUFACTURING COMPANY LIMITED০২ মার্চ, ১৯৯৫০২ মার্চ, ১৯৯৫
    KOLOK MANUFACTURING COMPANY LIMITED৩১ ডিসে, ১৯৭৮৩১ ডিসে, ১৯৭৮
    ALPHA OMICRON LIMITED২০ সেপ, ১৯৭৬২০ সেপ, ১৯৭৬

    COLUMBIA RIBBON MANUFACTURING COMPANY LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩০ সেপ, ২০১১
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩০ জুন, ২০১২
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০১০

    COLUMBIA RIBBON MANUFACTURING COMPANY LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ০৭ সেপ, ২০১২ তারিখে প্রশাসন থেকে দ্রবণে স্থানান্তরের নোটিশ

    14 পৃষ্ঠা2.35B

    ১৫ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    12 পৃষ্ঠা2.24B

    ক্রেডিটরদের সভার ফলাফল

    30 পৃষ্ঠা2.23B

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    29 পৃষ্ঠা2.17B

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ 2.14B

    10 পৃষ্ঠা2.16B

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    প্রশাসক নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা2.12B

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৯ সেপ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৬ অক্টো, ২০১০

    ২৬ অক্টো, ২০১০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    legacy

    8 পৃষ্ঠাMG01

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৯ সেপ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    2 পৃষ্ঠা363a

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    2 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    9 পৃষ্ঠা395

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৫ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    2 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৪ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    7 পৃষ্ঠা363s

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৩ পর্যন্ত তৈরি

    19 পৃষ্ঠাAA

    COLUMBIA RIBBON MANUFACTURING COMPANY LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    REECE, Martin John
    56 Ridge Way
    TN8 6AR Edenbridge
    Kent
    সচিব
    56 Ridge Way
    TN8 6AR Edenbridge
    Kent
    British76493570001
    MCCARRON, Patrick John
    45 Winsford Road
    Catford
    SE6 4LS London
    পরিচালক
    45 Winsford Road
    Catford
    SE6 4LS London
    United KingdomBritishCompany Director95215360001
    REECE, Martin John
    56 Ridge Way
    TN8 6AR Edenbridge
    Kent
    পরিচালক
    56 Ridge Way
    TN8 6AR Edenbridge
    Kent
    United KingdomBritishCompany Director76493570001
    SIMON, Michael John
    Staffhurst Barn
    Nr Whitehouse Farm
    TN8 6QG Edenbridge
    Kent
    পরিচালক
    Staffhurst Barn
    Nr Whitehouse Farm
    TN8 6QG Edenbridge
    Kent
    United KingdomBritishCompany Director95215450001
    BURDETT, Roger Leonard
    2 Pennyfields Boulevard
    NG10 3QJ Long Eaton
    Nottinghamshire
    সচিব
    2 Pennyfields Boulevard
    NG10 3QJ Long Eaton
    Nottinghamshire
    British53792200005
    DUCKWORTH, Simon Charles
    8 Newtons Croft Crescent
    Barlborough
    S43 4WA Chesterfield
    Derbyshire
    সচিব
    8 Newtons Croft Crescent
    Barlborough
    S43 4WA Chesterfield
    Derbyshire
    British44867860001
    HALE, Vivien Joan
    Keeley 12 Gables Meadow
    Holmer Green
    HP15 6RT High Wycombe
    Buckinghamshire
    সচিব
    Keeley 12 Gables Meadow
    Holmer Green
    HP15 6RT High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishAccountant56115110001
    NEAL, Peter Richard
    Coppers
    Cox Hill Boxford
    CO10 5HR Sudbury
    Suffolk
    সচিব
    Coppers
    Cox Hill Boxford
    CO10 5HR Sudbury
    Suffolk
    British11209680002
    PORTER, Michael James Robert
    Woodfield House
    Halifax Road Hipperholme
    HX3 8HD Halifax
    West Yorkshire
    সচিব
    Woodfield House
    Halifax Road Hipperholme
    HX3 8HD Halifax
    West Yorkshire
    British22243580001
    RIDLEY, John Henry Wallace
    52 Park Lane
    DY12 2EU Bewdley
    Worcestershire
    সচিব
    52 Park Lane
    DY12 2EU Bewdley
    Worcestershire
    British1746550001
    HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    কর্পোরেট সচিব
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    67382580002
    BARKER, Philip Dennison
    7 Brecks Gardens
    Kippax
    LS25 7LP Leeds
    পরিচালক
    7 Brecks Gardens
    Kippax
    LS25 7LP Leeds
    United KingdomBritishDirector40070580001
    BAXTER, Alan John
    Endon Hays Farm Dingle Lane
    Rushton Spencer
    SK11 0RX Macclesfield
    Cheshire
    পরিচালক
    Endon Hays Farm Dingle Lane
    Rushton Spencer
    SK11 0RX Macclesfield
    Cheshire
    BritishCompany Director35520050002
    BOWERS, Eric John
    The Viewlands
    Longridge Dunston
    ST18 9AL Stafford
    Staffordshire
    পরিচালক
    The Viewlands
    Longridge Dunston
    ST18 9AL Stafford
    Staffordshire
    BritishFinance Director57549940001
    BULLOCK, Paul Richard
    1 Millview
    Alwalton
    PE7 3UW Peterborough
    পরিচালক
    1 Millview
    Alwalton
    PE7 3UW Peterborough
    BritishCompany Director44329700001
    BURDETT, Roger Leonard
    2 Pennyfields Boulevard
    NG10 3QJ Long Eaton
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    2 Pennyfields Boulevard
    NG10 3QJ Long Eaton
    Nottinghamshire
    BritishChief Executive53792200005
    FLETCHER, Anthony Trevor
    Higher Oaklands Farm House
    Barrowford
    BB9 6QZ Nelson
    পরিচালক
    Higher Oaklands Farm House
    Barrowford
    BB9 6QZ Nelson
    BritishCompany Director113788270001
    GUMIENNY, Marek Stefan
    13 Lambolle Road
    Belsize Park
    NW3 4HS London
    পরিচালক
    13 Lambolle Road
    Belsize Park
    NW3 4HS London
    BritishInvestment Manager66370740001
    HALE, Vivien Joan
    Keeley 12 Gables Meadow
    Holmer Green
    HP15 6RT High Wycombe
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Keeley 12 Gables Meadow
    Holmer Green
    HP15 6RT High Wycombe
    Buckinghamshire
    EnglandBritishAccountant56115110001
    HANCOX, Roger Frederic
    Lower Leys 46 Mount Road
    Tettenhall Wood
    WV6 8HW Wolverhampton
    West Midlands
    পরিচালক
    Lower Leys 46 Mount Road
    Tettenhall Wood
    WV6 8HW Wolverhampton
    West Midlands
    BritishCompany Director1597600001
    JAMESON, Barry
    Cherry Cottage 2 Beechwood Lane
    Culcheth
    WA3 4HJ Warrington
    Lancashire
    পরিচালক
    Cherry Cottage 2 Beechwood Lane
    Culcheth
    WA3 4HJ Warrington
    Lancashire
    United KingdomBritishCompany Director13452550001
    MCCORKELL, Henry Nigel Pakenham
    The Hatch
    Gaunts Common
    BH21 4JB Wimborne
    Dorset
    পরিচালক
    The Hatch
    Gaunts Common
    BH21 4JB Wimborne
    Dorset
    EnglandEnglishCompany Director13447260001
    MILLSON, Stephen John
    24 Green Dragon Lane
    N21 2LD London
    পরিচালক
    24 Green Dragon Lane
    N21 2LD London
    United KingdomBritishCompany Director72703870002
    PHILLIPS, Alan Jeffrey
    11 Augustine Way
    Charlton
    SP10 4EG Andover
    Hampshire
    পরিচালক
    11 Augustine Way
    Charlton
    SP10 4EG Andover
    Hampshire
    BritishDirector12668990001
    PORTER, Michael James Robert
    Woodfield House
    Halifax Road Hipperholme
    HX3 8HD Halifax
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Woodfield House
    Halifax Road Hipperholme
    HX3 8HD Halifax
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant22243580001

    COLUMBIA RIBBON MANUFACTURING COMPANY LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ জুল, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ জুল, ২০১০
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bibby Financial Services Limited
    ব্যবসায়
    • ২৮ জুল, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ জুল, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ আগ, ২০০৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ আগ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ জুন, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ জুল, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and any of the other companies named therein (the group companies) to the chargee as agent and trustee for the beneficiaries (as defined) and/or any of the beneficiaries under or in connection with the facilities agreement and/or any other senior finance document
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ জুল, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ আগ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০২ জানু, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ জানু, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ জানু, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ জুল, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Single debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১২ আগ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ আগ, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Please see doc for further details,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC,
    ব্যবসায়
    • ২৫ আগ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ মে, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ মার্চ, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ মার্চ, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৪ আগ, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ফেব, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ মার্চ, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Specific & floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book & other debts stocks, shares of other securities. (See doc M14).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Country Bank Limited
    ব্যবসায়
    • ০৪ মার্চ, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৪ আগ, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ অক্টো, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ অক্টো, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed & floating charge over all book debts & other debts (see docm M13).. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ অক্টো, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন

    COLUMBIA RIBBON MANUFACTURING COMPANY LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১৬ সেপ, ২০১১প্রশাসন শুরু
    ০৭ সেপ, ২০১২প্রশাসন শেষ
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Simon Robert Thomas
    Moorfields Corporate Recovery 34 Park Cross Street
    LS1 2QH Leeds
    West Yorkshire
    অভ্যাসকারী
    Moorfields Corporate Recovery 34 Park Cross Street
    LS1 2QH Leeds
    West Yorkshire
    Robert Harry Pick
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    অভ্যাসকারী
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0