ROGER LITTLE LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামROGER LITTLE LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01283734
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    ROGER LITTLE LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • প্লাম্বিং, তাপ এবং এয়ার-কন্ডিশনার ইনস্টলেশন (43220) / নির্মাণ

    ROGER LITTLE LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Dyno Rod Unit 15 Haigh Park
    Whitehill Industrial Estate
    SK4 1QR Stockport
    Cheshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    ROGER LITTLE LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১৪

    ROGER LITTLE LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    ROGER LITTLE LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    চার্জ 4 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৬ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৮ এপ্রি, ২০১৪

    ২৮ এপ্রি, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 5,000
    SH01

    ০১ নভে, ২০১৩ তারিখে Mr Philip John Savage-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ নভে, ২০১৩ তারিখে Philip John Savage-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৬ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৬ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    14 পৃষ্ঠাAR01

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    ০১ মার্চ, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Nicola Kirwan এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ মার্চ, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Gerard Kirwan এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    legacy

    5 পৃষ্ঠাMG01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৬ মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    16 পৃষ্ঠাAR01

    ১৩ জানু, ২০১১ তারিখে Philip John Savage-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH01

    ১৩ জানু, ২০১১ তারিখে Philip John Savage-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH03

    ১৩ জানু, ২০১১ তারিখে Philip John Savage-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৬ মার্চ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    16 পৃষ্ঠাAR01

    ROGER LITTLE LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    SAVAGE, Philip John
    Fraser Street
    OL6 6LL Ashton-Under-Lyne
    16
    Lancashire
    England
    সচিব
    Fraser Street
    OL6 6LL Ashton-Under-Lyne
    16
    Lancashire
    England
    British100819360001
    SAVAGE, Philip John
    Fraser Street
    OL6 6LL Ashton-Under-Lyne
    16
    Lancashire
    England
    পরিচালক
    Fraser Street
    OL6 6LL Ashton-Under-Lyne
    16
    Lancashire
    England
    EnglandBritishDirector100819360002
    SAVAGE, Suzanne
    7 Birtles Close
    Richmond Park
    SK16 5RZ Dukinfield
    Cheshire
    পরিচালক
    7 Birtles Close
    Richmond Park
    SK16 5RZ Dukinfield
    Cheshire
    EnglandBritishDirector100819830001
    LITTLE, Simon Harvey
    Moorside Farm
    Onecote
    ST13 7SD Leek
    Staffordshire
    সচিব
    Moorside Farm
    Onecote
    ST13 7SD Leek
    Staffordshire
    British3906590003
    DALE, Ian Arthur
    34 Mow Lane
    Gillow Heath
    ST8 6QD Biddulph
    Staffordshire
    পরিচালক
    34 Mow Lane
    Gillow Heath
    ST8 6QD Biddulph
    Staffordshire
    BritishCompany Director11333070001
    KIRWAN, Gerard
    9 Norfolk Avenue
    SK4 5AG Heaton Chapel
    Cheshire
    পরিচালক
    9 Norfolk Avenue
    SK4 5AG Heaton Chapel
    Cheshire
    BritishDrain Services126141860001
    KIRWAN, Nicola
    9 Norfolk Avenue
    SK4 5AG Heaton Chapel
    Cheshire
    পরিচালক
    9 Norfolk Avenue
    SK4 5AG Heaton Chapel
    Cheshire
    BritishDirector126141750001
    LITTLE, Roger Harvey
    Woodlands Shrigley Fold Road
    Swanscoe Higher Hurdsfield
    SK10 5SZ Macclesfield
    Cheshire
    পরিচালক
    Woodlands Shrigley Fold Road
    Swanscoe Higher Hurdsfield
    SK10 5SZ Macclesfield
    Cheshire
    BritishCompany Director3906600001
    LITTLE, Simon Harvey
    Moorside Farm
    Onecote
    ST13 7SD Leek
    Staffordshire
    পরিচালক
    Moorside Farm
    Onecote
    ST13 7SD Leek
    Staffordshire
    BritishCompany Secretary/Director3906590003

    ROGER LITTLE LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২১ ডিসে, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জানু, ২০১২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £369,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Gerald Kirwan and Nicola Kirwan
    ব্যবসায়
    • ১১ জানু, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১৯ নভে, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    All assets debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ মে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ মে, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited (The Security Holder)
    ব্যবসায়
    • ১২ মে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ মে, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ নভে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ নভে, ১৯৯৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ নভে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ মে, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ মে, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Yorkshire Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ মে, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ নভে, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0