C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামC.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01303919
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অ-বিশেষায়িত পাইকারি বাণিজ্য (46900) / হোলসেল এবং খুচরা বিক্রয়; মোটর গাড়ি এবং মোটরসাইকেল মেরামত

    C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    c/o C/O ATLANTIC PLASTICS LIMITED
    Coytrahene Close
    Brackla Industrial Estate
    CF31 2AX Bridgend
    Mid Glamorgan
    Wales
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০১৩

    C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ সেপ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৪ সেপ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৫ অক্টো, ২০১৩

    ১৫ অক্টো, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 30,000
    SH01

    পরিচালক হিসাবে Mr Mark Vernon Hodgens-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Saul Godfrey এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Marcus Billman এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Dr Ansgar Nonn-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Kris Holla এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৪ সেপ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Mr Marcus Billman-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Oliver Gosemann এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Mr Kris Holla-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Mr Oliver Frank Gosemann-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৪ সেপ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD04

    পরিচালক হিসাবে Jan Van Ooijen এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    অডিটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাAUD

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা Eversheds House 70 Great Bridgewater Street Manchester M1 5ES United Kingdom থেকে পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    18 পৃষ্ঠাAA

    সচিব হিসাবে Mr James Fry-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    FRY, James
    c/o C/O Atlantic Plastics Limited
    Close
    Brackla Industrial Estate
    CF31 2AX Bridgend
    Coytrahene
    Mid Glamorgan
    Wales
    সচিব
    c/o C/O Atlantic Plastics Limited
    Close
    Brackla Industrial Estate
    CF31 2AX Bridgend
    Coytrahene
    Mid Glamorgan
    Wales
    158470000001
    HODGENS, Mark Vernon
    Coytrahene Close
    Brackla Industrial Estate
    CF31 2AX Bridgend
    Atlantic Plastics Limited
    Mid Glamorgan
    Wales
    পরিচালক
    Coytrahene Close
    Brackla Industrial Estate
    CF31 2AX Bridgend
    Atlantic Plastics Limited
    Mid Glamorgan
    Wales
    EnglandBritish94971440002
    NONN, Ansgar, Dr
    Senefelder Strasse 2
    63110 Rodgau
    Talis Management Holding Gmbh
    Germany
    পরিচালক
    Senefelder Strasse 2
    63110 Rodgau
    Talis Management Holding Gmbh
    Germany
    GermanyGerman177013380001
    HUNT, Nigel Thomas
    84 Fabis Close
    Walton Park
    DE11 9SN Swadlincote
    Derbyshire
    সচিব
    84 Fabis Close
    Walton Park
    DE11 9SN Swadlincote
    Derbyshire
    British39559640001
    MARTIN, Terry
    18 Ashford Crescent
    EN3 7HU Enfield
    Middlesex
    সচিব
    18 Ashford Crescent
    EN3 7HU Enfield
    Middlesex
    British69720220001
    MATTHEWS, Darren Jon
    60 Whitemoor Drive
    Monkspath
    B90 4UL Shirley
    West Midlands
    সচিব
    60 Whitemoor Drive
    Monkspath
    B90 4UL Shirley
    West Midlands
    British112391130001
    WALKER, Lesley
    5 Brookside
    Birch Cross, Marchington
    ST14 8NU Uttoxeter
    Staffordshire
    সচিব
    5 Brookside
    Birch Cross, Marchington
    ST14 8NU Uttoxeter
    Staffordshire
    British57030200002
    BILLMAN, Marcus
    Senefelder Strasse 2
    63110 Rodgau
    Talis Management Holding Gmbh
    Germany
    পরিচালক
    Senefelder Strasse 2
    63110 Rodgau
    Talis Management Holding Gmbh
    Germany
    United KingdomSwedish142246880001
    CATT, Nicholas William
    Farquhar Street
    SG14 3BP Hertford
    Little Eaves 6
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Farquhar Street
    SG14 3BP Hertford
    Little Eaves 6
    Hertfordshire
    EnglandBritish128624750001
    DAWES, Michael William
    The Nook
    Alton
    ST10 4BH Stoke On Trent
    Staffordshire
    পরিচালক
    The Nook
    Alton
    ST10 4BH Stoke On Trent
    Staffordshire
    British21194340001
    DURY, Paul John Edwin
    45 St Johns Treet
    DE6 1GP Ashbourne
    Derbyshire
    পরিচালক
    45 St Johns Treet
    DE6 1GP Ashbourne
    Derbyshire
    British46194000001
    EDMONDS, David Henry
    One Carrington House
    Buxton Road
    DE6 1EX Ashbourne
    Derbyshire
    পরিচালক
    One Carrington House
    Buxton Road
    DE6 1EX Ashbourne
    Derbyshire
    British73468520001
    GODFREY, Saul Gideon
    Charwood Close
    WD7 9LH Shenley
    12
    Hertfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Charwood Close
    WD7 9LH Shenley
    12
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish103524290001
    GOSEMANN, Oliver Frank
    Senefelder Strasse 2
    63100 Rodgau
    Talis Management Holding Gmbh
    Germany
    পরিচালক
    Senefelder Strasse 2
    63100 Rodgau
    Talis Management Holding Gmbh
    Germany
    GermanyGerman167850440001
    HOLLA, Kris
    Senefelder Strasse 2
    63100 Rodgau
    Talis Management Holding Gmbh
    Germany
    পরিচালক
    Senefelder Strasse 2
    63100 Rodgau
    Talis Management Holding Gmbh
    Germany
    GermanyAmerican167994810001
    KING, Stuart Derek
    68 Wenallt Road
    Rhiwbina
    CF4 6SE Cardiff
    South Glamorgan
    পরিচালক
    68 Wenallt Road
    Rhiwbina
    CF4 6SE Cardiff
    South Glamorgan
    British40173530001
    MACKEY, Damian
    18 Clinton Road
    CF64 3JD Penarth
    South Glamorgan
    পরিচালক
    18 Clinton Road
    CF64 3JD Penarth
    South Glamorgan
    Australian125261330001
    MCKENDRY, Francis James
    26/28 Avenue Raymond Poincarre
    FOREIGN Paris
    75116
    France
    পরিচালক
    26/28 Avenue Raymond Poincarre
    FOREIGN Paris
    75116
    France
    FranceBritish124595550001
    NICHOLAS, David Charles
    Lillingstone House
    84 Knowle Wood Road Dorridge
    B93 8JP Solihull
    West Midlands
    পরিচালক
    Lillingstone House
    84 Knowle Wood Road Dorridge
    B93 8JP Solihull
    West Midlands
    British96403410001
    POLINE, Olivier Pierre
    30 Allee Du Chateau
    69780 Mioms
    France
    পরিচালক
    30 Allee Du Chateau
    69780 Mioms
    France
    French112391190001
    TURNER, Stanley
    The Maples
    The Park
    B79 9DF Elford
    Staffordshire
    পরিচালক
    The Maples
    The Park
    B79 9DF Elford
    Staffordshire
    EnglandBritish70686150004
    VAN OOIJEN, Jan Roelf
    Heeckerenlaan 5
    7531 HW Enschede
    7531 Hw
    Netherlands
    পরিচালক
    Heeckerenlaan 5
    7531 HW Enschede
    7531 Hw
    Netherlands
    Dutch125281750001
    WALKER, Lesley
    5 Brookside
    Birch Cross, Marchington
    ST14 8NU Uttoxeter
    Staffordshire
    পরিচালক
    5 Brookside
    Birch Cross, Marchington
    ST14 8NU Uttoxeter
    Staffordshire
    EnglandBritish57030200002
    WARD, Marcus Gordon Waddie
    Rue De Tenbosch 85
    Flat 113
    FOREIGN Brussels
    1050
    Belgium
    পরিচালক
    Rue De Tenbosch 85
    Flat 113
    FOREIGN Brussels
    1050
    Belgium
    British74246040001
    WHELDON, Stephen
    11 Ashfield Park
    NE16 4SQ Whickham
    Tyne & Wear
    পরিচালক
    11 Ashfield Park
    NE16 4SQ Whickham
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish93126410001
    WILLIAMS, Andrew
    79 The Crescent
    WS1 2DA Walsall
    পরিচালক
    79 The Crescent
    WS1 2DA Walsall
    British39210390001

    C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ জানু, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জানু, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ জানু, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ এপ্রি, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২০ আগ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ আগ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a land and garage premises and part garage premises on the west side of woodland road swadlincote derbyshire t/no's;-DY3354 DY3355. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৭ আগ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ এপ্রি, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ মার্চ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ এপ্রি, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft
    ব্যবসায়
    • ২০ এপ্রি, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ মে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ অক্টো, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ অক্টো, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land & premises woodland road swadlincote t/no DY3354 & DY3355.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ অক্টো, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ এপ্রি, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ মার্চ, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ মার্চ, ১৯৮৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge on all book & other debts now & from time to time due or owing to the company.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ মার্চ, ১৯৮৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৯ এপ্রি, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ অক্টো, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ অক্টো, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Freehold land & premises k/a 115 and 117 hearthcote road, swadlincote, derbyshire. Title no: dy 82283.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ অক্টো, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৯ এপ্রি, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ ডিসে, ১৯৭৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ ডিসে, ১৯৭৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Floating charge on the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ ডিসে, ১৯৭৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৯ এপ্রি, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0