HALLITE POLYTEK LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামHALLITE POLYTEK LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01308929
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    HALLITE POLYTEK LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • প্রাথমিক রূপে প্লাস্টিক উৎপাদন (20160) / উৎপাদন

    HALLITE POLYTEK LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    HALLITE POLYTEK LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    HALLITE DEVELOPMENTS LIMITED৩১ ডিসে, ১৯৮০৩১ ডিসে, ১৯৮০
    HALLITE BELLOWS LIMITED৩১ ডিসে, ১৯৭৭৩১ ডিসে, ১৯৭৭
    TRUSHELFCO (NO. 134) LIMITED১৫ এপ্রি, ১৯৭৭১৫ এপ্রি, ১৯৭৭

    HALLITE POLYTEK LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ আগ, ২০১৭

    HALLITE POLYTEK LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    8 পৃষ্ঠাLIQ13

    ০৯ জানু, ২০২১ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    8 পৃষ্ঠাLIQ03

    ০৯ জানু, ২০২০ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    8 পৃষ্ঠাLIQ03

    ০৬ ফেব, ২০১৯ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Hesslewood Country Office Park Ferriby Road Hessle East Yorkshire HU13 0PW থেকে C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor Lowgate House Lowgate Hull HU1 1ELপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    5 পৃষ্ঠাLIQ01

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ১০ জানু, ২০১৯ তারিখে

    LRESSP

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ০৮ জানু, ২০১৯ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1.00
    3 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    The company share premium account cancelled 13/12/2018
    RES13
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    ১২ ডিসে, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Richard William Hewlett এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১২ ডিসে, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Vijay Markanday এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১০ সেপ, ২০১৮ তারিখে Mr William John Pratt-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০৪ আগ, ২০১৮ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩১ আগ, ২০১৮ থেকে ৩১ ডিসে, ২০১৮ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    ৩১ আগ, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি করা অনডিট করা সংক্ষিপ্ত হিসাব

    7 পৃষ্ঠাAA

    ১৬ মার্চ, ২০১৮ তারিখে Mr William John Pratt-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০৫ মার্চ, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Simon Alan Davies এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৪ আগ, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ আগ, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    ০৪ আগ, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ আগ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৪ আগ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৪ আগ, ২০১৫

    ০৪ আগ, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100,000
    SH01

    HALLITE POLYTEK LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BRADBURY, Debra
    Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor
    সচিব
    Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor
    British72879990002
    CALEY, Andrew Maitland
    Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor
    পরিচালক
    Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor
    United KingdomBritish49060800002
    PRATT, William John
    Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor
    পরিচালক
    Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor
    United KingdomBritish194710300003
    GILLETT, Christopher Joseph
    White Lodge
    12 Ashurst Road
    KT20 5EU Tadworth
    Surrey
    সচিব
    White Lodge
    12 Ashurst Road
    KT20 5EU Tadworth
    Surrey
    British69961270001
    HARDACRE, Eian Clark
    6 Wilcot Close
    Bisley
    GU24 9DE Woking
    Surrey
    সচিব
    6 Wilcot Close
    Bisley
    GU24 9DE Woking
    Surrey
    British119450490001
    LYALL, Gordon John
    Hildegarth
    New Yatt
    OX8 6TF Witney
    Oxfordshire
    সচিব
    Hildegarth
    New Yatt
    OX8 6TF Witney
    Oxfordshire
    British15413660003
    MARKANDAY, Vijay
    20 Birchdale
    SL9 7JA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    সচিব
    20 Birchdale
    SL9 7JA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British49523130001
    WELLER, Christopher
    3 Halfway Cottages
    Bath Road
    RG20 8NG Newbury
    Berkshire
    সচিব
    3 Halfway Cottages
    Bath Road
    RG20 8NG Newbury
    Berkshire
    British80664920001
    BENNETT, Peter Ian
    24 Coulter Close
    Cuffley
    EN6 4RR Potters Bar
    Hertfordshire
    পরিচালক
    24 Coulter Close
    Cuffley
    EN6 4RR Potters Bar
    Hertfordshire
    British4154020001
    CHAFFIN, Peter
    The Croft 21 The Ridgeway
    TN10 4NH Tonbridge
    Kent
    পরিচালক
    The Croft 21 The Ridgeway
    TN10 4NH Tonbridge
    Kent
    British1508410001
    DAVIES, Simon Alan
    28 Stonebridge Field
    Eton
    SL4 6PS Windsor
    Berkshire
    পরিচালক
    28 Stonebridge Field
    Eton
    SL4 6PS Windsor
    Berkshire
    British44598860003
    GILLETT, Christopher Joseph
    White Lodge
    12 Ashurst Road
    KT20 5EU Tadworth
    Surrey
    পরিচালক
    White Lodge
    12 Ashurst Road
    KT20 5EU Tadworth
    Surrey
    Great BritainBritish69961270001
    HARDACRE, Eian Clark
    6 Wilcot Close
    Bisley
    GU24 9DE Woking
    Surrey
    পরিচালক
    6 Wilcot Close
    Bisley
    GU24 9DE Woking
    Surrey
    EnglandBritish119450490001
    HEWLETT, Richard William
    34 Bradford Drive
    KT19 0AH Epsom
    Surrey
    পরিচালক
    34 Bradford Drive
    KT19 0AH Epsom
    Surrey
    British59434460001
    HOWIE, Andrew Wright
    4 Tregarth Place
    GU21 3JY Woking
    Surrey
    পরিচালক
    4 Tregarth Place
    GU21 3JY Woking
    Surrey
    British15413650001
    JONES, David Henry
    Neen Court
    DY14 0AH Neen Sollars
    Worcestershire
    পরিচালক
    Neen Court
    DY14 0AH Neen Sollars
    Worcestershire
    United KingdomBritish101383260001
    KINGSNORTH, Robert Stanley
    The Dolphins 23 Kingsley Avenue
    GU15 2NA Camberley
    Surrey
    পরিচালক
    The Dolphins 23 Kingsley Avenue
    GU15 2NA Camberley
    Surrey
    British58131230001
    LYALL, Gordon John
    Hildegarth
    New Yatt
    OX8 6TF Witney
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Hildegarth
    New Yatt
    OX8 6TF Witney
    Oxfordshire
    British15413660003
    MARKANDAY, Vijay
    20 Birchdale
    SL9 7JA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    20 Birchdale
    SL9 7JA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British49523130001
    MUMFORD, Michael Charles
    Crookhaugh
    3 Rydens Avenue
    KT12 3JB Walton On Thames
    Surrey
    পরিচালক
    Crookhaugh
    3 Rydens Avenue
    KT12 3JB Walton On Thames
    Surrey
    British18807630002
    PAVER, Michael
    27 Cavendish Meads
    SL5 9TB Ascot
    Berkshire
    পরিচালক
    27 Cavendish Meads
    SL5 9TB Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish10035580002
    PERRY, Richard John
    Hesslewood Country Office Park
    Ferriby Road
    HU13 0PW Hessle
    East Yorkshire
    পরিচালক
    Hesslewood Country Office Park
    Ferriby Road
    HU13 0PW Hessle
    East Yorkshire
    United KingdomBritish40260860002
    RUBERY, Steven Henry
    16 Whynot Lane
    SP10 3ES Andover
    Hampshire
    পরিচালক
    16 Whynot Lane
    SP10 3ES Andover
    Hampshire
    British15413670001
    WELLER, Christopher
    3 Halfway Cottages
    Bath Road
    RG20 8NG Newbury
    Berkshire
    পরিচালক
    3 Halfway Cottages
    Bath Road
    RG20 8NG Newbury
    Berkshire
    British80664920001
    WESTON, Peter Maurice
    28 Curley Hill Road
    GU18 5YQ Lightwater
    Surrey
    পরিচালক
    28 Curley Hill Road
    GU18 5YQ Lightwater
    Surrey
    EnglandBritish112416950001
    WILKINS, Christopher Stuart Henry
    Banktop House
    Hopton Lane Hopton
    ST18 0AH Stafford
    Staffordshire
    পরিচালক
    Banktop House
    Hopton Lane Hopton
    ST18 0AH Stafford
    Staffordshire
    United KingdomBritish127017930001

    HALLITE POLYTEK LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Hesslewood Country Office Park
    Ferriby Road
    HU13 0PW Hessle
    Unit 5
    East Yorkshire
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Hesslewood Country Office Park
    Ferriby Road
    HU13 0PW Hessle
    Unit 5
    East Yorkshire
    England
    না
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর01104611
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    HALLITE POLYTEK LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ সেপ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ সেপ, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ সেপ, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ এপ্রি, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জানু, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ ফেব, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or in connection with the agreement (as defined in the original debenture)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Samuel Montagu & Co. Limitedas Agent and Trustee for Itself the Arranger and for the Banks (As Defined)
    ব্যবসায়
    • ২১ ফেব, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩১ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ মার্চ, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent & trustee for itself, the arranger & the banks (as defined in the original debenture being 2 debentures dated 27.7.89 & 1.9.89) an any account whatsoever under the terms of the agreement (as defined in the original debenture)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Samuel Montagu & Co Limited
    ব্যবসায়
    • ১৩ মার্চ, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ৩১ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ সেপ, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ সেপ, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company as agent and trustee for itself, the arranger and for the danks under the terms of the agreement and ancilliary facility and/or any other security documents
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (For full details see doc. M372).. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Samuel Montagu & Company Limited
    ব্যবসায়
    • ০৫ সেপ, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ৩১ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee & second debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ আগ, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ সেপ, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of a facility agreement dated 27/7/89
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • First Britannia Mezzanine Capital B.V.(For Itself and as Trustee for the Lendes)
    ব্যবসায়
    • ০৫ সেপ, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ৩১ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee & second debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ জুল, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ আগ, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    See doc for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • First Britannia Mezzanine Capital B.V.
    ব্যবসায়
    • ১৭ আগ, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ৩১ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee & second debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ জুল, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ আগ, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from and/or all or any of the other companies named therein under the terms of a mezzanine loan agreement dated 27TH july 1989 and the deed. The company to the chargee.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (See form 395 - ref M541C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Frist Britannia Mezzenine Capital B.V.(As Trustee for the Lenders.)
    ব্যবসায়
    • ০৭ আগ, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ৩১ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ জুল, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ আগ, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agrent and trustee for itself the arrange and for the banks) on any account whatsoever under the terms of a facility agreement dated 27.7.89, the ancillary facility and the security documents (as defined in the facility agreement).
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    For further details see doc M106).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Samuel Montagu & Co. Limited.
    ব্যবসায়
    • ০৭ আগ, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ৩১ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    HALLITE POLYTEK LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১০ জানু, ২০১৯ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ১৫ ডিসে, ২০২১ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Sarah Louise Burge
    First Floor Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    অভ্যাসকারী
    First Floor Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0