ENERGY AND WASTE SYSTEMS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামENERGY AND WASTE SYSTEMS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01336193
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    ENERGY AND WASTE SYSTEMS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    ENERGY AND WASTE SYSTEMS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Portland House Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    ENERGY AND WASTE SYSTEMS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    SABELLIAN LIMITED২৭ অক্টো, ১৯৭৭২৭ অক্টো, ১৯৭৭

    ENERGY AND WASTE SYSTEMS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৪

    ENERGY AND WASTE SYSTEMS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    6 পৃষ্ঠা4.71

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ১৮ ডিসে, ২০১৫ তারিখে

    LRESSP

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    ২৭ আগ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Lafarge Tarmac Directors (Uk) Limited এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৭ আগ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Michael John Choules-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৭ আগ, ২০১৫ তারিখে Lafarge Tarmac Secretaries (Uk) Limited-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH04

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ এপ্রি, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২১ এপ্রি, ২০১৫

    ২১ এপ্রি, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2,907,632
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Andrew Bolter এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Mrs Fiona Puleston Penhallurick-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ এপ্রি, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৪ এপ্রি, ২০১৪

    ০৪ এপ্রি, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2,907,632
    SH01

    ১৫ এপ্রি, ২০১৩ তারিখে Lafarge Tarmac Secretaries (Uk) Limited-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH04

    ০৩ ডিসে, ২০১৩ তারিখে Mr Andrew Christopher Bolter-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    পরিচালক হিসাবে Deborah Grimason এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    23 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের স্মারকলিপি এবং/অথবা নিবন্ধের রেজুলেশন

    RES01

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ এপ্রি, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    ১৫ এপ্রি, ২০১৩ তারিখে Lafarge Secretaries (Uk) Limited-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH04

    ১৫ এপ্রি, ২০১৩ তারিখে Lafarge Directors (Uk) Limited-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH02

    ২৮ মার্চ, ২০১৩ তারিখে Lafarge Secretaries (Uk) Limited-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH04

    ২৮ মার্চ, ২০১৩ তারিখে Lafarge Directors (Uk) Limited-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH02

    পরিচালক হিসাবে Mr Andrew Christopher Bolter-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ENERGY AND WASTE SYSTEMS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    TARMAC SECRETARIES (UK) LIMITED
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর532256
    9859690020
    CHOULES, Michael John
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    পরিচালক
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United KingdomBritishAccountant178681090001
    PENHALLURICK, Fiona Puleston
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    পরিচালক
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director147397910001
    BLYDE, William David
    26 Henley Deane
    DA11 8SX Gravesend
    Kent
    সচিব
    26 Henley Deane
    DA11 8SX Gravesend
    Kent
    BritishAccountant11292060001
    BLYDE, William David
    26 Henley Deane
    DA11 8SX Gravesend
    Kent
    সচিব
    26 Henley Deane
    DA11 8SX Gravesend
    Kent
    BritishAccountant11292060001
    ELLIOTT, Raymond Alfred
    4 Church Close
    Rushton
    NN14 1SB Kettering
    Northamptonshire
    সচিব
    4 Church Close
    Rushton
    NN14 1SB Kettering
    Northamptonshire
    BritishCompany Solicitor34102870003
    FOLLOWS, Penelope Kim
    59 High Street
    Bovingdon
    HP3 0HP Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    সচিব
    59 High Street
    Bovingdon
    HP3 0HP Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British53539320001
    FRANKLIN, Gordon Francis
    The Cottage Little End
    Hunningham
    CV33 9DT Leamington Spa
    Warwickshire
    সচিব
    The Cottage Little End
    Hunningham
    CV33 9DT Leamington Spa
    Warwickshire
    British29905900001
    GRIMASON, Deborah
    Rosa's Cottage
    13 Church Road
    PE28 2RJ Warboys
    Cambridgeshire
    সচিব
    Rosa's Cottage
    13 Church Road
    PE28 2RJ Warboys
    Cambridgeshire
    BritishLegal Director & Company Secre120668330001
    MOTTRAM, Clive Jonathan
    Granite House
    Granite Way, Syston
    LE7 1PL Leicester
    Company Secretariat Department
    Leicestershire
    United Kingdom
    সচিব
    Granite House
    Granite Way, Syston
    LE7 1PL Leicester
    Company Secretariat Department
    Leicestershire
    United Kingdom
    British101320990002
    SIMS, Alan Francis
    Woodmarsh 23 Bratton Road
    West Ashton
    BA14 6AZ Trowbridge
    Wiltshire
    সচিব
    Woodmarsh 23 Bratton Road
    West Ashton
    BA14 6AZ Trowbridge
    Wiltshire
    BritishFinancial Director29129840001
    SIMS, Alan Francis
    Woodmarsh 23 Bratton Road
    West Ashton
    BA14 6AZ Trowbridge
    Wiltshire
    সচিব
    Woodmarsh 23 Bratton Road
    West Ashton
    BA14 6AZ Trowbridge
    Wiltshire
    BritishFinancial Director29129840001
    BAUMANN, Christopher John
    31 Old Slade Lane
    SL0 9DY Richings Park
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    31 Old Slade Lane
    SL0 9DY Richings Park
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishMechanical Engineer102220130001
    BOLTER, Andrew Christopher
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    পরিচালক
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant146583270001
    COLLIGNON, Marie-Cecile
    Bickenhill Lane
    B37 7BQ Solihull
    Portland House
    Birmingham
    United Kingdom
    পরিচালক
    Bickenhill Lane
    B37 7BQ Solihull
    Portland House
    Birmingham
    United Kingdom
    FranceFrenchSolicitor163152100001
    ELLIOTT, Raymond Alfred
    4 Church Close
    Rushton
    NN14 1SB Kettering
    Northamptonshire
    পরিচালক
    4 Church Close
    Rushton
    NN14 1SB Kettering
    Northamptonshire
    BritishCompany Solicitor34102870003
    FENNELL, Sonia
    Granite House
    Granite Way, Syston
    LE7 1PL Leicester
    Company Secretariat Department
    Leicestershire
    পরিচালক
    Granite House
    Granite Way, Syston
    LE7 1PL Leicester
    Company Secretariat Department
    Leicestershire
    EnglandBritishChartered Secretary9591230004
    FRANKLIN, Gordon Francis
    The Cottage Little End
    Hunningham
    CV33 9DT Leamington Spa
    Warwickshire
    পরিচালক
    The Cottage Little End
    Hunningham
    CV33 9DT Leamington Spa
    Warwickshire
    EnglandBritishCompany Secretary29905900001
    GRIMASON, Deborah
    Bickenhill Lane
    B37 7BQ Solihuill
    Portland House
    West Midlands
    United Kingdom
    পরিচালক
    Bickenhill Lane
    B37 7BQ Solihuill
    Portland House
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor120668330001
    GRIMASON, Deborah
    Rosa's Cottage
    13 Church Road
    PE28 2RJ Warboys
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    Rosa's Cottage
    13 Church Road
    PE28 2RJ Warboys
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishLegal Director & Company Secre120668330001
    LANYON, Phillip Thomas Edward
    Granite House
    Granite Way, Syston
    LE7 1PL Leicester
    Company Secretariat Department
    Leicestershire
    পরিচালক
    Granite House
    Granite Way, Syston
    LE7 1PL Leicester
    Company Secretariat Department
    Leicestershire
    United KingdomBritishDirector Of Uk Financial Shared Services153614170001
    LEE, Frank Jozef
    Ramblers 33 Marley Combe Road
    GU27 3SN Haslemere
    Surrey
    পরিচালক
    Ramblers 33 Marley Combe Road
    GU27 3SN Haslemere
    Surrey
    BritishCompany Director29129850001
    MILLS, Peter William Joseph
    RH4 1TH Dorking
    Regent House
    Surrey
    United Kingdom
    পরিচালক
    RH4 1TH Dorking
    Regent House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector Of Financial Services50416220001
    MOTTRAM, Clive Jonathan
    Granite House
    Granite Way, Syston
    LE7 1PL Leicester
    Company Secretariat Department
    Leicestershire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Granite House
    Granite Way, Syston
    LE7 1PL Leicester
    Company Secretariat Department
    Leicestershire
    United Kingdom
    EnglandBritishLegal Director & Company Secretary101320990002
    POWELL, Rebecca Joan
    Granite House
    Granite Way, Syston
    LE7 1PL Leicester
    Company Secretariat Department
    Leicestershire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Granite House
    Granite Way, Syston
    LE7 1PL Leicester
    Company Secretariat Department
    Leicestershire
    United Kingdom
    EnglandBritishSolicitor159214660001
    REID, Ian Maclean
    Newstead House
    The Green
    LE17 4SG Bitteswell
    Leicestershire
    পরিচালক
    Newstead House
    The Green
    LE17 4SG Bitteswell
    Leicestershire
    BritishManaging Director10964750002
    ROSE, Clifford Harvey
    Windgarth Bristol Road
    Churchill
    BS19 5NL Bristol
    Avon
    পরিচালক
    Windgarth Bristol Road
    Churchill
    BS19 5NL Bristol
    Avon
    BritishChartered Civil Engineer29129860001
    SAUNDERS, Malcolm Richard
    Greenway House Wormcliffe Lane
    Ashley Box
    SN14 9AP Corsham
    Wiltshire
    পরিচালক
    Greenway House Wormcliffe Lane
    Ashley Box
    SN14 9AP Corsham
    Wiltshire
    BritishCivil Engineer37427530002
    SIMS, Alan Francis
    Woodmarsh 23 Bratton Road
    West Ashton
    BA14 6AZ Trowbridge
    Wiltshire
    পরিচালক
    Woodmarsh 23 Bratton Road
    West Ashton
    BA14 6AZ Trowbridge
    Wiltshire
    BritishFinancial Director29129840001
    SIMS, Alan Francis
    Woodmarsh 23 Bratton Road
    West Ashton
    BA14 6AZ Trowbridge
    Wiltshire
    পরিচালক
    Woodmarsh 23 Bratton Road
    West Ashton
    BA14 6AZ Trowbridge
    Wiltshire
    BritishFinancial Director29129840001
    SLACK, John Christopher
    34 Weymouth Road
    BA11 1HH Frome
    Somerset
    পরিচালক
    34 Weymouth Road
    BA11 1HH Frome
    Somerset
    BritishCivil Engineer29129880001
    TAPP, Richard Francis
    33 Station Road
    Earls Barton
    NN6 0NT Northampton
    Northamptonshire
    পরিচালক
    33 Station Road
    Earls Barton
    NN6 0NT Northampton
    Northamptonshire
    BritishSolicitor31629120001
    WADLOW, Ralph
    12 High Street
    ME19 6AL East Malling
    Kent
    পরিচালক
    12 High Street
    ME19 6AL East Malling
    Kent
    BritishProject Management-Mba Busines55199490001
    WARD, Ian Geoffrey, Dr
    10 Conifer Avenue
    Hartley
    DA3 8BX Longfield
    Kent
    পরিচালক
    10 Conifer Avenue
    Hartley
    DA3 8BX Longfield
    Kent
    BritishChartered Chemist11292070001
    YOUNG, Ian Morton, Dr
    8 Ringwood Avenue
    Hazel Grove
    SK7 5HH Stockport
    Cheshire
    পরিচালক
    8 Ringwood Avenue
    Hazel Grove
    SK7 5HH Stockport
    Cheshire
    BritishMarketing Director39859990001

    ENERGY AND WASTE SYSTEMS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২১ মে, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ মে, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement of even date.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital stocks, shares etc. benefit of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Keatway Limited.
    ব্যবসায়
    • ২৭ মে, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ নভে, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ নভে, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over the company's f/h & l/h properties and(or the proceeds of sale thereof. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts & the benefit of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ নভে, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন

    ENERGY AND WASTE SYSTEMS LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১৮ ডিসে, ২০১৫ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ২১ ডিসে, ২০১৬ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    অভ্যাসকারী
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    অভ্যাসকারী
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0