KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামKEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01356836
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • তারের পণ্য, চেইন এবং স্প্রিংস উত্পাদন (25930) / উৎপাদন
    • অন্যান্য ইলেকট্রনিক এবং বৈদ্যুতিক তার এবং কেবল উত্পাদন (27320) / উৎপাদন

    KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    4 Stirling Court
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    Herts
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    PLESSEY WIRING SYSTEMS LIMITED৩১ ডিসে, ১৯৭৮৩১ ডিসে, ১৯৭৮
    PLESSEY GROUP SERVICES LIMITED০৯ মার্চ, ১৯৭৮০৯ মার্চ, ১৯৭৮

    KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ জুন, ২০১১

    KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    19 পৃষ্ঠাLIQ14

    ১৬ এপ্রি, ২০১৬ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    17 পৃষ্ঠা4.68

    ১৯ অক্টো, ২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Brook Point 1412-1420 High Road Whetstone London N20 9BH থেকে 4 Stirling Court Stirling Way Borehamwood Herts WD6 2BTপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ১৬ এপ্রি, ২০১৫ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    19 পৃষ্ঠা4.68

    ১৬ এপ্রি, ২০১৪ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    19 পৃষ্ঠা4.68

    ০১ এপ্রি, ২০১৪ পর্যন্ত রসিদ এবং অর্থপ্রদানের স্বেচ্ছাসেবী ব্যবস্থার সুপারভাইজারের সারসংক্ষেপ

    8 পৃষ্ঠা1.3

    স্বেচ্ছাসেবী ব্যবস্থার সমাপ্তির নোটিশ

    8 পৃষ্ঠা1.4

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য অসামান্য রেজোলিউশন

    LRESEX

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    600

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ 4.19

    22 পৃষ্ঠা4.20

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Company place voluntary creditors liquidation/appoint liquidator 27/03/2013
    RES13

    legacy

    5 পৃষ্ঠাMG01

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ জানু, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    14 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২০ ফেব, ২০১৩

    ২০ ফেব, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2,718,215
    SH01

    পরিচালক হিসাবে William Gimson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    হিসাব রেফারেন্স তারিখ পরিবর্তন

    3 পৃষ্ঠাAA01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    23 পৃষ্ঠাAA

    রেজিস্ট্রারকে নোটিশ কোম্পানির স্বেচ্ছাসেবী ব্যবস্থার কার্যকরী

    8 পৃষ্ঠা1.1

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ বন্ধ করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাDISS40

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    পরিচালক হিসাবে Richard Martin এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Andrew Mckerrow এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    legacy

    6 পৃষ্ঠাMG02

    KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    HALCO SECRETARIES LIMITED
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    কর্পোরেট সচিব
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর2503744
    146855460001
    GIMSON, John Peter
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    4 Stirling Court
    Herts
    পরিচালক
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    4 Stirling Court
    Herts
    EnglandBritish89639570001
    EDGE, Geoffrey
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    সচিব
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    British2055530001
    ELLARD, Sarah Louise
    3 Glenney Close
    PO13 8FD Lee On The Solent
    Hampshire
    সচিব
    3 Glenney Close
    PO13 8FD Lee On The Solent
    Hampshire
    British43855640009
    LEIGHTON, Iain Gordon Kerr
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    সচিব
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    British42841660001
    VINE, Sylvia Elizabeth Faith
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    সচিব
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    British3801050001
    WILLIFER, Mark Eamon
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    সচিব
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    British33089100003
    AUSTIN, Brian Sergio, Mr.
    Innovis House
    108 High Street
    RH10 1AS Crawley
    West Sussex
    পরিচালক
    Innovis House
    108 High Street
    RH10 1AS Crawley
    West Sussex
    EnglandBritish83674480001
    BILLINGTON, Philip Gordon
    25 Carbis Close
    Port Solent Cosham
    PO6 4TW Portsmouth
    Hampshire
    পরিচালক
    25 Carbis Close
    Port Solent Cosham
    PO6 4TW Portsmouth
    Hampshire
    British18247670001
    BOWEN, Malcolm Alvin
    29 Purn Road
    Bleadon
    BS24 9JQ Weston Super Mare
    Avon
    পরিচালক
    29 Purn Road
    Bleadon
    BS24 9JQ Weston Super Mare
    Avon
    British27471100001
    CLEARY, Michael John
    22 Main Road
    Naphill
    HP14 4QB High Wycombe
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    22 Main Road
    Naphill
    HP14 4QB High Wycombe
    Buckinghamshire
    British1525670001
    DAVIES, Arthur Thomas
    Charlecote 4 Stag Gates
    Blackfield
    SO45 1SR Southampton
    Hants
    পরিচালক
    Charlecote 4 Stag Gates
    Blackfield
    SO45 1SR Southampton
    Hants
    British24258700001
    EVANS, David Roger
    Yoxhall Lodge
    10 Worsley Road
    PO5 3DY Southsea
    Hampshire
    পরিচালক
    Yoxhall Lodge
    10 Worsley Road
    PO5 3DY Southsea
    Hampshire
    EnglandBritish4471420003
    GIBBS, Raymond John
    Bridge House
    7 Uxbridge Close
    SO31 7LP Sarisbury Soton
    Hampshire
    পরিচালক
    Bridge House
    7 Uxbridge Close
    SO31 7LP Sarisbury Soton
    Hampshire
    British85421380001
    GIMSON, William Peter Critchley
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    পরিচালক
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    United Kingdom British 162987980001
    HOLLAND, Richard Andrew
    Cedarcroft
    Twyning Green
    GL20 6DQ Tewkesbury
    Gloucestershire
    পরিচালক
    Cedarcroft
    Twyning Green
    GL20 6DQ Tewkesbury
    Gloucestershire
    EnglandBritish107177720001
    LYNN, John James
    House On The Corner
    Cricklade Street, Poulton
    GL7 5HW Cirencester
    Gloucestershire
    পরিচালক
    House On The Corner
    Cricklade Street, Poulton
    GL7 5HW Cirencester
    Gloucestershire
    British69883500001
    MACDERMOTT, Philip
    179 Sternhold Avenue
    SW2 4PF London
    পরিচালক
    179 Sternhold Avenue
    SW2 4PF London
    British25679470001
    MARTIN, Richard
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    পরিচালক
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    EnglandBritish27471110004
    MCKERROW, Andrew James
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    পরিচালক
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    EnglandBritish83845420002
    MOLONY, Peter John
    Mill House
    Great Elm
    BA11 3NY Frome
    Somerset
    পরিচালক
    Mill House
    Great Elm
    BA11 3NY Frome
    Somerset
    British42803990001
    RAINBIRD, Graham Dennis
    23 Barcote Close
    Redhouse
    SN25 2BH Swindon
    Wiltshire
    পরিচালক
    23 Barcote Close
    Redhouse
    SN25 2BH Swindon
    Wiltshire
    British83845440002
    RAYNER, Paul Adrian
    48 Kilham Lane
    SO22 5QD Winchester
    Hampshire
    পরিচালক
    48 Kilham Lane
    SO22 5QD Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritish45628680002
    RAYNER, Paul Adrian
    The Well House
    Collins Lane Hursley
    SO21 2JX Winchester
    Hampshire
    পরিচালক
    The Well House
    Collins Lane Hursley
    SO21 2JX Winchester
    Hampshire
    British45628680001
    SHORE, David Alan
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    পরিচালক
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    United KingdomBritish116529450001
    STOPPS, Ian Robert, Mr.
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    পরিচালক
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    United KingdomBritish154207190001
    WHITEHORN, Justin Michael
    Lower Farm House
    Upper Milton Milton Under Wychwood
    OX7 6EX Chipping Norton
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Lower Farm House
    Upper Milton Milton Under Wychwood
    OX7 6EX Chipping Norton
    Oxfordshire
    EnglandBritish42825970001
    WILLIFER, Mark Eamon
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    পরিচালক
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    United KingdomBritish33089100003

    KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ মার্চ, ২০১৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ২০১৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the charge holder on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property including goodwill, debts, uncalled capital see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Champlain Cable Corporation
    ব্যবসায়
    • ০৬ মার্চ, ২০১৩একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Full form debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ জুল, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ জুল, ২০১১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Leumi Abl Limited
    ব্যবসায়
    • ১৯ জুল, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ২৪ মার্চ, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ আগ, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ আগ, ২০১০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Leumi Abl Limited
    ব্যবসায়
    • ২৫ আগ, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ২৪ মার্চ, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ সেপ, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ অক্টো, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    ব্যবসায়
    • ০৫ অক্টো, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ নভে, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ নভে, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ নভে, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Venture Finance PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ নভে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ আগ, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ ফেব, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ ফেব, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All obligations and liabilities due or to become due from the obligors to the chargee under or pursuant to the financing documents (all terms defined therein)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties
    ব্যবসায়
    • ১৪ ফেব, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ নভে, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over book debts
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ ডিসে, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ ডিসে, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific charge over all book debts and other debts as from time to time be due or owing to the company. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ ডিসে, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ ফেব, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ এপ্রি, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মে, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to the principal charge dated 18/12/89
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ মে, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ মার্চ, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ সেপ, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ অক্টো, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ অক্টো, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৫ মার্চ, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ ডিসে, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ জানু, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge on all book & other debts floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ জানু, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৫ মার্চ, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ জুল, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ জুল, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First fixed charge as all book and otherdebts floating charge on all the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ জুল, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৫ মার্চ, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ১০ আগ, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ আগ, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First food charge over all book & other debts with 9 floating charge over (see doc 34). undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ আগ, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন

    KEMBREY WIRING SYSTEMS LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১৯ জুল, ২০১২সিভিএ অনুমোদনের সভার তারিখ
    ০১ এপ্রি, ২০১৪সিভিএ সম্পন্ন বা সমাপ্তির তারিখ
    কর্পোরেট স্বেচ্ছাসেবী ব্যবস্থা (সিভিএ)
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Eric Walls
    C12 Marquis Court Marquis Way
    Team Valley
    NE11 0RU Gateshead
    অভ্যাসকারী
    C12 Marquis Court Marquis Way
    Team Valley
    NE11 0RU Gateshead
    2
    তারিখপ্রকার
    ১৭ এপ্রি, ২০১৩ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ৩০ সেপ, ২০১৭ভেঙে গেছে
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    John Stephen Kelmanson
    Brook Point 1412-1420 High Road
    N20 9BH London
    অভ্যাসকারী
    Brook Point 1412-1420 High Road
    N20 9BH London
    Alexander Kinninmonth
    Highfield Court Tollgate
    Chandlers Ford
    SO53 3TZ Eastleigh
    Hampshire
    অভ্যাসকারী
    Highfield Court Tollgate
    Chandlers Ford
    SO53 3TZ Eastleigh
    Hampshire

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0