ANKER SYSTEMS

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামANKER SYSTEMS
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট আনলিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01365105
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    ANKER SYSTEMS এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    ANKER SYSTEMS কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Oracle Parkway
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Berkshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    ANKER SYSTEMS এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    ANKER SYSTEMS LIMITED৩১ মার্চ, ২০০০৩১ মার্চ, ২০০০
    RIVA SYSTEMS LIMITED২৬ সেপ, ১৯৮৮২৬ সেপ, ১৯৮৮
    RIVA TURNKEY COMPUTER SYSTEMS LIMITED৩১ ডিসে, ১৯৭৮৩১ ডিসে, ১৯৭৮
    BENCHWORLD LIMITED২৫ এপ্রি, ১৯৭৮২৫ এপ্রি, ১৯৭৮

    ANKER SYSTEMS এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ জুন, ২০১৬

    ANKER SYSTEMS এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Re-registration 22/12/2016
    RES13

    সীমিত থেকে অসীম পুনঃ নিবন্ধনের শংসাপত্র

    1 পৃষ্ঠাCERT3

    পুনঃনিবন্ধন সম্মতি

    1 পৃষ্ঠাFOA-RR

    পুনঃনিবন্ধন সমিতির এবং সংবিধির নথি

    38 পৃষ্ঠাMAR

    পুনঃনিবন্ধন একটি ব্যক্তিগত সীমিত কোম্পানি থেকে একটি ব্যক্তিগত সীমাহীন কোম্পানিতে

    1 পৃষ্ঠাRR05

    ০৫ ডিসে, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    22 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৫ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৭ ডিসে, ২০১৫

    ০৭ ডিসে, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 500,001
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    25 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৫ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০২ জানু, ২০১৫

    ০২ জানু, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 500,001
    SH01

    ২৬ নভে, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Stephen Walder এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৬ নভে, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Cynthia Russo এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৬ নভে, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Frank Peter Ward এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৬ নভে, ২০১৪ তারিখে সচিব হিসাবে Stephen Walder এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ২৬ নভে, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Kaweh Niroomand এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৬ নভে, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Oracle Corporation Nominees Limited-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP02

    ২৬ নভে, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr David James Hudson-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০১ ডিসে, ২০১৪ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 6-8 the Grove Slough Berkshire SL1 1QP থেকে Oracle Parkway Thames Valley Park Reading Berkshire RG6 1RAপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    25 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৫ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০২ জানু, ২০১৪

    ০২ জানু, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 500,001
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    25 পৃষ্ঠাAA

    ANKER SYSTEMS এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    HUDSON, David James
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Oracle Parkway
    Berkshire
    England
    পরিচালক
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Oracle Parkway
    Berkshire
    England
    EnglandBritish100987010002
    ORACLE CORPORATION NOMINEES LIMITED
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Oracle Parkway
    Berkshire
    England
    কর্পোরেট পরিচালক
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Oracle Parkway
    Berkshire
    England
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর03062158
    118326710001
    ALEXANDER, Neil Brough
    Brook House Osbaston
    SY10 8HT Oswestry
    Shropshire
    সচিব
    Brook House Osbaston
    SY10 8HT Oswestry
    Shropshire
    British3699700001
    COOKSLEY, Graeme Roy
    Chamer Russweg 19
    6300 Zug
    Switzerland
    সচিব
    Chamer Russweg 19
    6300 Zug
    Switzerland
    New Zealander126903810001
    HORN, Nigel David
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    সচিব
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    British109926660001
    ISAACSON, Kirk Jeffrey, Mr.
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    সচিব
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    Other123425810001
    ISAACSON, Kirk Jeffrey, Mr.
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    সচিব
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    Other123425810001
    JOHNSON, Robin Simon
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    সচিব
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    British11498320001
    JONES, Stephen Philip
    11 Pownall Avenue
    Bramhall
    SK7 2HE Stockport
    Cheshire
    সচিব
    11 Pownall Avenue
    Bramhall
    SK7 2HE Stockport
    Cheshire
    British39173700002
    LEEK, Marcus
    7 Gloster Drive
    CV8 2TU Kenilworth
    Warwickshire
    সচিব
    7 Gloster Drive
    CV8 2TU Kenilworth
    Warwickshire
    British115960470001
    WALDER, Stephen
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Oracle Parkway
    Berkshire
    সচিব
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Oracle Parkway
    Berkshire
    British169959800001
    ABDO, Ashley
    63 West Ranch Trail
    CO80465 Morrison
    Colorado
    Usa
    পরিচালক
    63 West Ranch Trail
    CO80465 Morrison
    Colorado
    Usa
    American90157130001
    ALEXANDER, Neil Brough
    Brook House Osbaston
    SY10 8HT Oswestry
    Shropshire
    পরিচালক
    Brook House Osbaston
    SY10 8HT Oswestry
    Shropshire
    British3699700001
    APPLETON, Colin Arthur
    15 The Coppice
    Cuddington
    CW8 2XF Northwich
    Cheshire
    পরিচালক
    15 The Coppice
    Cuddington
    CW8 2XF Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish19964370001
    BAILEY, James R
    1000 Rock Ridge Lane
    Loveland
    Colorado
    80537
    Usa
    পরিচালক
    1000 Rock Ridge Lane
    Loveland
    Colorado
    80537
    Usa
    American69700010001
    BAKER, Jeremy David
    16 Bonville Chase
    WA14 4QA Altrincham
    Cheshire
    পরিচালক
    16 Bonville Chase
    WA14 4QA Altrincham
    Cheshire
    British51244270001
    BUTCHER, Steve John
    Lower Laithe Cottage
    Providence Lane, Oakworth
    BD22 7QS Keighley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Lower Laithe Cottage
    Providence Lane, Oakworth
    BD22 7QS Keighley
    West Yorkshire
    United KingdomBritish203318870001
    CALLAGHAN, Stephen James
    The Grove
    SL1 1QP Slough
    6-8
    Berkshire
    পরিচালক
    The Grove
    SL1 1QP Slough
    6-8
    Berkshire
    EnglandBritish87418990003
    COOKSLEY, Graeme Roy
    Chamer Russweg 19
    6300 Zug
    Switzerland
    পরিচালক
    Chamer Russweg 19
    6300 Zug
    Switzerland
    New Zealander126903810001
    COOKSLEY, Graeme
    19 Charmer Fussweg
    Zug
    6300
    Switzerland
    পরিচালক
    19 Charmer Fussweg
    Zug
    6300
    Switzerland
    New Zealander122786180001
    DOBIE, Timothy Arthur Ross
    1 St Andrews Road
    Brockhall Village Old Langho
    BB6 8BP Blackburn
    Lancashire
    পরিচালক
    1 St Andrews Road
    Brockhall Village Old Langho
    BB6 8BP Blackburn
    Lancashire
    EnglandBritish97704830001
    DOBSON, Melvyn John
    42 Ravens Wood
    Chorley New Road Heaton
    BL1 5TL Bolton
    পরিচালক
    42 Ravens Wood
    Chorley New Road Heaton
    BL1 5TL Bolton
    British45852970001
    DURKIN, Ivan Paul
    11 Stapleford Close
    BL8 2UG Bury
    Lancashire
    পরিচালক
    11 Stapleford Close
    BL8 2UG Bury
    Lancashire
    British51244360001
    EARHART, Stephen
    Brittens Lane
    Salford
    MK17 8BE Milton Keynes
    1
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Brittens Lane
    Salford
    MK17 8BE Milton Keynes
    1
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United States133153450001
    FOULKES, John Harold
    Cank Farmhouse
    Welford Road
    NN6 8AH Chapel Brampton
    Northamptonshire
    পরিচালক
    Cank Farmhouse
    Welford Road
    NN6 8AH Chapel Brampton
    Northamptonshire
    British1657980007
    GILDART, Steven
    12 Ennerdale Road
    Astley Tyldesley
    M29 7AR Manchester
    পরিচালক
    12 Ennerdale Road
    Astley Tyldesley
    M29 7AR Manchester
    British51244420001
    GILES, Peter Hardwick
    Arden House Lamb Lane
    Ashley
    WA14 3QG Altrincham
    Cheshire
    পরিচালক
    Arden House Lamb Lane
    Ashley
    WA14 3QG Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish35521860001
    GRADDEN, Amanda Jane
    Flat 2 10a Market Mews
    W1J 7BZ London
    পরিচালক
    Flat 2 10a Market Mews
    W1J 7BZ London
    EnglandBritish77425910003
    GREENOUGH, Michael
    711 Pintail Court
    Granbury
    Texas 76049
    Usa
    পরিচালক
    711 Pintail Court
    Granbury
    Texas 76049
    Usa
    Canadian123427350001
    HAYES, Laurence
    15 Heald Cottages
    Judith Street Lowerfold
    OL12 7HS Rochdale
    Lancashire
    পরিচালক
    15 Heald Cottages
    Judith Street Lowerfold
    OL12 7HS Rochdale
    Lancashire
    British51244430001
    HIRANO, Michael
    139 Eagle Canyon Circle
    PO BOX 1925
    CO80540 Lyons
    Colorado
    Usa
    পরিচালক
    139 Eagle Canyon Circle
    PO BOX 1925
    CO80540 Lyons
    Colorado
    Usa
    American90157180001
    HOLLENBECK, David Arthur
    5166 Buckingham Road
    CO80301 Boulder
    Colorado
    Usa
    পরিচালক
    5166 Buckingham Road
    CO80301 Boulder
    Colorado
    Usa
    American90157320001
    HORN, Nigel David
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    British109926660001
    ISAACSON, Kirk Jeffrey, Mr.
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    পরিচালক
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    UsaOther123425810001
    JONES, Stephen Philip
    11 Pownall Avenue
    Bramhall
    SK7 2HE Stockport
    Cheshire
    পরিচালক
    11 Pownall Avenue
    Bramhall
    SK7 2HE Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish39173700002

    ANKER SYSTEMS এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Oracle Parkway
    Berkshire
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Oracle Parkway
    Berkshire
    England
    না
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    নিবন্ধিত দেশUnited Kingdom (England And Wales)
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর6273940
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    ANKER SYSTEMS এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২১ অক্টো, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ নভে, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Burdale Financial Limited
    ব্যবসায়
    • ০২ নভে, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১২ জুন, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture (the "agreement")
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ জানু, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ ফেব, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the finance documents (including the agreement)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Commerzbank Ag London Branchas Trustee for the Beneficiaries (As Defined Inschedule 1)
    ব্যবসায়
    • ০৯ ফেব, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ মার্চ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ আগ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ আগ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Co-Operative Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ আগ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ ফেব, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of adherence
    তৈরি করা হয়েছে ১২ মে, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ মে, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a facility letter DATED13TH april 1992 the composite debenture dated 26TH april 1990 and any other security documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The charged assets as defined in the original charge see form 395 ref M563C.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Fbg Holdings (UK) Limitedpreviously Elders Ixl Holdings (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ১৪ মে, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ জানু, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Second supplemental deed
    তৈরি করা হয়েছে ১২ মে, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ মে, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a facility letter DATED13 april 1992 the composite debenture dated 26 april 1990 or any other security document (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The charges and assignments contained inclause 2 of the original debenture DATED26 april 1990.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Fbg Holdings (UK) Limitedpreviously Elders Ixl Holdings (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ১৪ মে, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ জানু, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ এপ্রি, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ এপ্রি, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from theriva group PLC and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the finance documents as defined
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    See form 395 ref M90. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Co-Operative Bank Plcmilneas Agent and Trustee for Itself the Banks and Mr
    ব্যবসায়
    • ৩০ এপ্রি, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ ফেব, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental deed
    তৈরি করা হয়েছে ১২ আগ, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ আগ, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a facility to the dated 23RD april 1990 and any other security document (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (See form 395- ref M135 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Fbg Holdings (U.K.) Limited
    ব্যবসায়
    • ২০ আগ, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৬ জানু, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ মে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ মে, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from riva group PLC to the chargee under each of the finance documents as defined
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (See doc M148 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Co-Operative Bank PLC.
    ব্যবসায়
    • ২৯ মে, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ ফেব, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantees & mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ এপ্রি, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ মে, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility letter and this charge and any other security document
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (See doc M228 for full details). A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Elders Ixl Holdings (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ মে, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৬ জানু, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ নভে, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ নভে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from hugin sweda group (as defined) under the terms of each of the finance documents and/or the swedish loan agreements as defined to the chargee.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All dividends paid or payable after the date of the debenture and all or any of the shares and all stocks, shares, securities (and the dividends or interest thereon) rights, money or property. (See form m 395 ref m 849C for full details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Co-Operative Bank Plcined)(As Agent for and on Behalf of the Banks, as Def
    ব্যবসায়
    • ৩০ নভে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ ফেব, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১১ সেপ, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ সেপ, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £133,000.00 and all other monies due or to become due from the and alistair scott petrie and barbara ann petrie company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    1, the farthings, marcham abingdon, oxfordshire. T/n:- on 60470. and all fixtures thereon and additions thereto.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ সেপ, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৫ আগ, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ জানু, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ ফেব, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed amd floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital. With all buildings, fixtures, fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ ফেব, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৫ আগ, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২০ জুন, ১৯৮০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ জুন, ১৯৮০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. And all fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ জুন, ১৯৮০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৫ আগ, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0