NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামNEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01370566
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (2524) /

    NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Brooks House
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Warwickshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    SWISH BUILDING PRODUCTS LIMITED ০৫ মার্চ, ১৯৯৮০৫ মার্চ, ১৯৯৮
    BREVILLE EUROPE LIMITED৩১ ডিসে, ১৯৭৮৩১ ডিসে, ১৯৭৮
    DROWLEN LIMITED২৫ মে, ১৯৭৮২৫ মে, ১৯৭৮

    NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১০

    NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ২৬ সেপ, ২০১৩ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    6 পৃষ্ঠা4.68

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    5 পৃষ্ঠা4.71

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ২৭ সেপ, ২০১২ তারিখে

    LRESSP

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    ৩১ মে, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Adrian Egerton Darling এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ৩১ মে, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Jan-Feie Zwiers-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৬ মার্চ, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Robert Leslie Nash এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৬ মার্চ, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে John Mcfaull এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৬ মার্চ, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Paul Thomas Moss-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    বার্ষিক রিটার্ন ৩০ সেপ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৭ অক্টো, ২০১১

    ২৭ অক্টো, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 25,866,666.7
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    1 পৃষ্ঠাAA

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    1 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩০ সেপ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    ২৮ সেপ, ২০১০ তারিখে John Mcfaull-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২৮ সেপ, ২০১০ তারিখে Robert Leslie Nash-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২৮ সেপ, ২০১০ তারিখে Mr Adrian Egerton Darling-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২৭ সেপ, ২০১০ তারিখে Karen Roberts-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH03

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ১৩ জানু, ২০১০ তারিখে Robert Leslie Nash-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১৩ জানু, ২০১০ তারিখে Mr Adrian Egerton Darling-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১৩ জানু, ২০১০ তারিখে John Mcfaull-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১৩ জানু, ২০১০ তারিখে Karen Roberts-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    1 পৃষ্ঠাAA

    NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    ROBERTS, Karen Dawn
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    সচিব
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    British126457090001
    MOSS, Paul Thomas
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    পরিচালক
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    EnglandBritish167898270001
    ZWIERS, Jan-Feie
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    England
    পরিচালক
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    England
    NetherlandsDutch169623550001
    BOND, Sarah Caroline
    Hillside
    37 Rise End, Middleton
    DE4 4LS Wirksworth
    Derbyshire
    সচিব
    Hillside
    37 Rise End, Middleton
    DE4 4LS Wirksworth
    Derbyshire
    British90181180006
    CHAPMAN, Christopher John
    5 The Willows
    Walmley
    B76 2PX Sutton Coldfield
    West Midlands
    সচিব
    5 The Willows
    Walmley
    B76 2PX Sutton Coldfield
    West Midlands
    British50769680003
    LOWE, Tracey
    149 Smalley Drive
    Oakwood
    DE21 2SQ Derby
    Derbyshire
    সচিব
    149 Smalley Drive
    Oakwood
    DE21 2SQ Derby
    Derbyshire
    British86697030001
    PERKINS, Michael William
    38 Cubbington Road
    CV32 7AB Leamington Spa
    Warwickshire
    সচিব
    38 Cubbington Road
    CV32 7AB Leamington Spa
    Warwickshire
    British30958650001
    STRATTON, Malcolm
    Flat 40
    Manor Park Court, Uttoxeter New Road
    DE22 3NG Derby
    Derbyshire
    সচিব
    Flat 40
    Manor Park Court, Uttoxeter New Road
    DE22 3NG Derby
    Derbyshire
    British30601260018
    STRATTON, Malcolm
    White Rose Grange Hollington Road
    Stubwood
    ST14 5HY Uttoxeter
    Staffordshire
    সচিব
    White Rose Grange Hollington Road
    Stubwood
    ST14 5HY Uttoxeter
    Staffordshire
    British30601260002
    DARLING, Adrian Egerton
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    পরিচালক
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish13813980005
    DAVIES, Michael Thomas
    Dadlington House Farm
    Shenton Lane
    CV13 6JD Dadlington
    Warwickshire
    পরিচালক
    Dadlington House Farm
    Shenton Lane
    CV13 6JD Dadlington
    Warwickshire
    British50770000002
    EDWARDS, Mark John
    The Glen
    35 Hazelwood Road
    DE56 4DP Duffield
    Derby
    পরিচালক
    The Glen
    35 Hazelwood Road
    DE56 4DP Duffield
    Derby
    United KingdomBritish56562210001
    GODDARD, David Peter
    The Hollies
    Ivy House Lane
    HP4 2PP Berkhamsted
    Hertfordshire
    পরিচালক
    The Hollies
    Ivy House Lane
    HP4 2PP Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish8828350002
    HANRAHAN, Shaun Patrick
    19 Wollaton Vale
    Wollaton
    NG8 2PD Nottingham
    পরিচালক
    19 Wollaton Vale
    Wollaton
    NG8 2PD Nottingham
    British49298590002
    MCFAULL, John
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    পরিচালক
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    British83628430003
    NASH, Robert Leslie
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    পরিচালক
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish83397580001
    PURCHASE, Roger
    8 Moorfield Avenue
    Knowle
    B93 9RE Solihull
    West Midlands
    পরিচালক
    8 Moorfield Avenue
    Knowle
    B93 9RE Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish49298600001
    SIMPSON, Kenneth
    Copton Ash Cottage
    Sheepy Road, Twycross
    CV9 3PG Atherstone
    Warwickshire
    পরিচালক
    Copton Ash Cottage
    Sheepy Road, Twycross
    CV9 3PG Atherstone
    Warwickshire
    British27376570002
    STRATTON, Malcolm
    Flat 40
    Manor Park Court, Uttoxeter New Road
    DE22 3NG Derby
    Derbyshire
    পরিচালক
    Flat 40
    Manor Park Court, Uttoxeter New Road
    DE22 3NG Derby
    Derbyshire
    British30601260018
    NEWMOND ADMINISTRATION LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    কর্পোরেট পরিচালক
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    57363930002
    NEWMOND ADMINISTRATION LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    কর্পোরেট পরিচালক
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    57363930002
    NEWMOND MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    কর্পোরেট পরিচালক
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    57363780002
    NEWMOND MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    কর্পোরেট পরিচালক
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    57363780002
    WESTMINSTER SECURITIES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    কর্পোরেট পরিচালক
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    33480800001
    WILLIAMS MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    কর্পোরেট পরিচালক
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    6125640001

    NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Guarantee and debenture made between the company and the royal bank of scotland PLC as agent and trustee for the secured parties (as defined) pursuant to the intercreditor agreement (as defined)
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ ডিসে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ ডিসে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined) including the guarantee and debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ মার্চ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ ফেব, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ মার্চ, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee as agent and trustee for itself and each of the finance parties (as therein defined) (or any of them) under each or any of the finance documents (as therein defined) on any account whatsoever provided that no obligation or liability shall be included in the definition of "secured liabilities" to the extent that, if it were included, supplemental debenture or the debenture (or any part thereof) would constitute unlawful financial assistance within the meaning of sections 151 and 152 of the companies act 1985
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Morgan Grenfell & Co Limited
    ব্যবসায়
    • ১৬ মার্চ, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Accession agreement relating to a debenture dated 4/12/96
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ ডিসে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জানু, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each chargor (as defined) to the finance parties or any of them under each or any of the finance documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Morgan Grenfell & Co. Limited,as Agent for the Chargors
    ব্যবসায়
    • ০৯ জানু, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২১ জানু, ২০১৪ভেঙে গেছে
    ২৭ সেপ, ২০১২ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    অভ্যাসকারী
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Timothy Gerard Walsh
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    অভ্যাসকারী
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0