MSQ HOLDINGS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামMSQ HOLDINGS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01382912
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    MSQ HOLDINGS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • হেড অফিসের কার্যক্রম (70100) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    MSQ HOLDINGS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    c/o MSQ PARTNERS LIMITED
    90 Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    MSQ HOLDINGS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    COUTTS HOLDINGS LIMITED১৪ ডিসে, ২০০৪১৪ ডিসে, ২০০৪
    COUTTS HOLDINGS PLC.০৪ মে, ২০০৪০৪ মে, ২০০৪
    C.A. COUTTS HOLDINGS PLC১১ এপ্রি, ১৯৯৬১১ এপ্রি, ১৯৯৬
    ESSEX HOLDINGS LIMITED০৯ আগ, ১৯৭৮০৯ আগ, ১৯৭৮

    MSQ HOLDINGS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে২৮ ফেব, ২০১৭

    MSQ HOLDINGS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    পূর্ণ হিসাব ২৮ ফেব, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    20 পৃষ্ঠাAA

    ০৬ ফেব, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা 10 Rathbone Place London W1T 1HP England থেকে C/O Browne Jacobson Llp 6 Bevis Marks London EC3A 7BA এ পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা C/O Msq Partners Limited 90 Tottenham Court Road London W1T 4TJ এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD04

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত পরিদর্শন স্থান 10 Rathbone Place London W1T 1HP এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD03

    পূর্ণ হিসাব ২৯ ফেব, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    21 পৃষ্ঠাAA

    ২২ সেপ, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 0.20
    3 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Cancel share prem a/c and capital redemption reserve 21/09/2016
    RES13
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    বার্ষিক রিটার্ন ০৬ ফেব, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৪ মার্চ, ২০১৬

    ২৪ মার্চ, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 4,043,722.2
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ২৮ ফেব, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৬ ফেব, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৬ ফেব, ২০১৫

    ০৬ ফেব, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 4,043,722.2
    SH01

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত পরিদর্শন স্থান 10 Rathbone Place London W1T 1HP এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    AD03

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা 10 Rathbone Place London W1T 1HP এ পরিবর্তন করা হয়েছে

    AD02

    অডিট ছাড় সহায়ক হিসাব ২৮ ফেব, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    29 পৃষ্ঠাPARENT_ACC

    legacy

    1 পৃষ্ঠাAGREEMENT2

    legacy

    3 পৃষ্ঠাGUARANTEE2

    সমিতির এবং সংবিধির নথি

    12 পৃষ্ঠাMA

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ পরিবর্তনের রেজুলেশন

    RES01
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Various agreements as listed 16/07/2014
    RES13

    চার্জ 12 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    MSQ HOLDINGS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    SHAH, Ashish
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    সচিব
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    164776860001
    REID, Peter David
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    পরিচালক
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    EnglandBritishChief Executive147274580002
    YARDLEY, Daniel John
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    পরিচালক
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer180507300001
    ALEXANDER, Charles Stuart
    24 Waveney Close
    E1W 2JL London
    সচিব
    24 Waveney Close
    E1W 2JL London
    British7666350001
    BRIGDEN, Colin John
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    সচিব
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    147343420001
    CLARKE, Martin John
    105 Congleton Road
    SK11 7XD Macclesfield
    Cheshire
    সচিব
    105 Congleton Road
    SK11 7XD Macclesfield
    Cheshire
    BritishAccountant53461320002
    WINFIELD, Bruce Malcolm
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    সচিব
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    British147948820001
    ALEXANDER, Charles Stuart
    24 Waveney Close
    E1W 2JL London
    পরিচালক
    24 Waveney Close
    E1W 2JL London
    BritishChartered Accountant7666350001
    BECKETT, John Douglas Hamilton
    Littlewick Lodge
    Littlewick Green
    SL6 3QU Maidenhead
    Berks
    পরিচালক
    Littlewick Lodge
    Littlewick Green
    SL6 3QU Maidenhead
    Berks
    BritishSemi-Retired Consultantant7666360001
    BELL, Patrick Charles
    Coles Barn
    Belchamp Otten
    CO10 7BG Sudbury
    Suffolk
    পরিচালক
    Coles Barn
    Belchamp Otten
    CO10 7BG Sudbury
    Suffolk
    United KingdomBritishDirector71758630001
    BURNS, Graeme Ian, Mr.
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    পরিচালক
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    United KingdomBritishAccountant75720570001
    CAHN, Christopher Charles
    39 Anchorage Point
    Cuba Street
    E14 8NF London
    পরিচালক
    39 Anchorage Point
    Cuba Street
    E14 8NF London
    BritishDirector85328320001
    CUBBON, James Henry
    The Coach House
    Hammer Lane, Grayshott
    GU26 6JD Hindhead
    Surrey
    পরিচালক
    The Coach House
    Hammer Lane, Grayshott
    GU26 6JD Hindhead
    Surrey
    EnglandBritishDirector47485650002
    ESSEX, Charles Edward Oliver
    Elm Green Farm
    Danbury
    CM3 4DW Chelmsford
    Essex
    পরিচালক
    Elm Green Farm
    Danbury
    CM3 4DW Chelmsford
    Essex
    BritishSales Representative7666370001
    ESSEX, Norman Arthur
    Elm Green Farm
    Danbury
    CM3 4DW Chelmsford
    Essex
    পরিচালক
    Elm Green Farm
    Danbury
    CM3 4DW Chelmsford
    Essex
    BritishCompany Director7666380001
    ESSEX, Robert Thomas Tickler
    21 Rylett Road
    W12 9SS London
    পরিচালক
    21 Rylett Road
    W12 9SS London
    EnglandBritishCompany Director7666390002
    ESSEX, William Alexander Wells
    Potash Cottage
    Strethall
    CB11 4XJ Saffron Walden
    Essex
    পরিচালক
    Potash Cottage
    Strethall
    CB11 4XJ Saffron Walden
    Essex
    BritishMagazine Editor7666400001
    FOWLER, Robert Edward
    42 Foord Road
    Lenham
    ME17 2QN Maidstone
    Kent
    পরিচালক
    42 Foord Road
    Lenham
    ME17 2QN Maidstone
    Kent
    United KingdomBritishDirector26408910001
    HARRIS, Graeme Richard
    35 Allerton Road
    N16 5UF London
    পরিচালক
    35 Allerton Road
    N16 5UF London
    EnglandBritishDirector56342040002
    HIGSON, Alexander
    21 Straightsmouth
    SE10 9LB London
    পরিচালক
    21 Straightsmouth
    SE10 9LB London
    BritishExecutive Recruitment7666410001
    MIDDLETON, Arthur Jeremy Barritt
    Corbar Hall
    Corbar Road
    SK17 6TF Buxton
    পরিচালক
    Corbar Hall
    Corbar Road
    SK17 6TF Buxton
    EnglandBritishCompany Director72455560001
    PARRY, Roger George
    27 Edwardes Square
    W8 6HH London
    পরিচালক
    27 Edwardes Square
    W8 6HH London
    United KingdomBritishExec Chairman41614380002
    PENN, John Robert
    The Willows
    Wellington Hill
    IG10 4AH Loughton
    Essex
    পরিচালক
    The Willows
    Wellington Hill
    IG10 4AH Loughton
    Essex
    United KingdomEnglishNone7147450002
    SAYSELL, Richard Geoffrey
    43 Manor Avenue
    Brockley
    SE4 1PE London
    পরিচালক
    43 Manor Avenue
    Brockley
    SE4 1PE London
    BritishDirector50920320002
    SMITH, Anthony Michael
    9 Culverden Down
    TN4 9SB Tunbridge Wells
    Kent
    পরিচালক
    9 Culverden Down
    TN4 9SB Tunbridge Wells
    Kent
    BritishDirector26408890003
    STERN, Nigel Duncan
    Flat 3, 27 Adolphus Road
    N4 2AT London
    পরিচালক
    Flat 3, 27 Adolphus Road
    N4 2AT London
    BritishDirector58083200002
    WHITEHORN, William Elliott
    31 Dents Road
    SW11 6JA London
    পরিচালক
    31 Dents Road
    SW11 6JA London
    United KingdomBritishDirector46878420002
    WINFIELD, Bruce Malcolm
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    পরিচালক
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    United KingdomBritishAccountant147948820001
    WRIGHT, Dean Anthony
    c/o Msq Partners Limited
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    পরিচালক
    c/o Msq Partners Limited
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector159138180001

    MSQ HOLDINGS LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    না
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    নিবন্ধিত দেশUnited Kingdom
    আইনি কর্তৃপক্ষUk (England And Wales)
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House (England And Wales)
    নিবন্ধন নম্বর07745643
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    MSQ HOLDINGS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ জুল, ২০১৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ জুল, ২০১৪
    বকেয়া
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Nvm Private Equity Limited
    ব্যবসায়
    • ২১ জুল, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ জুল, ২০১৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ জুল, ২০১৪
    বকেয়া
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Description of all registered intellectual property rights subject to this security can be found in schedule 5 of the debenture.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC Acting as Agent for National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ জুল, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ সেপ, ২০১৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ অক্টো, ২০১৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Notification of addition to or amendment of charge.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    ব্যবসায়
    • ০৪ অক্টো, ২০১৩একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ০২ সেপ, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Hong kong law share charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ সেপ, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ সেপ, ২০১২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The charged assets meaning the shares and derivative assets and includes all rights benefits and sums now or in the future accruing as a result of or in connection with any of the shares or the derivative assets see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    ব্যবসায়
    • ১৯ সেপ, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০২ সেপ, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Supplemental debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ ফেব, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ২০১২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ২৩ ফেব, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০২ সেপ, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    New york law stock pledge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ ফেব, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ ফেব, ২০১২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and the other obligors to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Right title and interest in the pledged shares and additional collateral and any certificates and instruments see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১৭ ফেব, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০২ সেপ, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Share charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ ফেব, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ ফেব, ২০১২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All interest in the existing shares, any additional shares, any derived assets and any dividends see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    ব্যবসায়
    • ১৪ ফেব, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০২ সেপ, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ ডিসে, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ ডিসে, ২০১১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ ডিসে, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০২ সেপ, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Share mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২০ জানু, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ ফেব, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All right title and interest in the securities being the original securities and additional securities including dividends,. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Secured Parties(As Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ০১ ফেব, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ ডিসে, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Share charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ জানু, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ ফেব, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the company's interest in the shares being 100 ordinary shares of £1.00 each in the company and related rights,. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ০১ ফেব, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ ডিসে, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Cession and pledge in security
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ নভে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ নভে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company formerly k/a coutts holdings limited to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All of the shares and ceded rights. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Acting as Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১৭ নভে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ ডিসে, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ নভে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ নভে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১৭ নভে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ ডিসে, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Share pledge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ নভে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ নভে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company formerly k/a coutts holdings limited, the borrower or other obligors and their subsidiaries to the chargee and future pledgees on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The existing share in the nominal amount of 25,000 euro in the pledged company being citigate group holdings gmbh as well as any and all other shares in the pledged company which the pledgor may acquire in the future by contribution or otherwise and the security collateral. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১৭ নভে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ ডিসে, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Share pledge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ নভে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ নভে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company formerly k/a coutts holdings limited, the borrower or other obligors and their subsidiaries to the chargee and future pledgees on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The existing share in the nominal amount of 25,000 euro in the pledged company being citigate gmbh as well as any and all other shares in the pledged company which the pledgor may acquire in the future by contribution or otherwise and the security collateral. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১৭ নভে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ ডিসে, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Share pledge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ নভে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ নভে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company formerly k/a coutts holdings limited, the borrower or other obligors and their subsidiaries to the chargee and future pledgees on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The existing share in the aggregate nominal amount of 20,000 euro in the pledged company being hoffmann schalt werbeagentur gmbh as well as any and all other shares in the pledged company which the pledgor may acquire in the future by contribution or otherwise and the security collateral. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১৭ নভে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ ডিসে, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Pledge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ নভে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ নভে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The right, title and interest in and to its pledged stock and a senior, first priority lien in all of the pledgor's right, title and interest in the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১৭ নভে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ ডিসে, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Share pledge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ নভে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ নভে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The existing shares and related rights and any additional shares and related rights. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১৭ নভে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ ডিসে, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ অক্টো, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ অক্টো, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ ফেব, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ মার্চ, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property known as bakery premises forming part of the borough of chelmsford's widford industrial estate at robyohns road chelmsford and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ মার্চ, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0