CLOSE NUMBER 12 LIMITED
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
কোম্পানির নাম | CLOSE NUMBER 12 LIMITED |
---|---|
কোম্পানির স্থিতি | বাতিল |
আইনি ফর্ম | প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি |
কোম্পানি নম্বর | 01387401 |
এখতিয়ার | ইংল্যান্ড/ওয়েলস |
সৃষ্টির তারিখ | |
বন্ধের তারিখ |
সংক্ষিপ্তসার
সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছে | না |
---|---|
চার্জ রয়েছে | হ্যাঁ |
দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছে | হ্যাঁ |
নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণ | না |
CLOSE NUMBER 12 LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?
- অন্যান্য ব্যবসা সহায়তা পরিষেবা কার্যক্রম ন.এ.সি. (82990) / প্রশাসনিক এবং সহায়ক পরিষেবা কার্যক্রম
CLOSE NUMBER 12 LIMITED কোথায় অবস্থিত?
নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | The Thomas Cook Business Park Coningsby Road PE3 8SB Peterborough Cambs England |
---|---|
ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | না |
CLOSE NUMBER 12 LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?
কোম্পানির নাম | থেকে | পর্যন্ত |
---|---|---|
MYTRAVEL AVIATION LEASING LIMITED | ০৩ মার্চ, ২০০৪ | ০৩ মার্চ, ২০০৪ |
OMICRON EQUIPMENT LEASING (ORANGE) LIMITED | ১১ ডিসে, ২০০৩ | ১১ ডিসে, ২০০৩ |
LLOYDS EQUIPMENT LEASING LIMITED | ০৬ সেপ, ১৯৭৮ | ০৬ সেপ, ১৯৭৮ |
CLOSE NUMBER 12 LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?
শেষ হিসাব | |
---|---|
শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে | ৩০ সেপ, ২০১২ |
CLOSE NUMBER 12 LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?
বার্ষিক রিটার্ন |
|
---|
CLOSE NUMBER 12 LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?
তারিখ | বর্ণনা | দলিল | প্রকার | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট | 1 পৃষ্ঠা | GAZ2 | ||||||||||||||
সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন | 6 পৃষ্ঠা | 4.71 | ||||||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ০৬ সেপ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 4 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র | 3 পৃষ্ঠা | 4.70 | ||||||||||||||
স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ | 1 পৃষ্ঠা | 600 | ||||||||||||||
রেজুলেশনগুলি Resolutions | 1 পৃষ্ঠা | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র Company name changed mytravel aviation leasing LIMITED\certificate issued on 16/07/13 | 3 পৃষ্ঠা | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি | 16 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||||||
পরিচালক হিসাবে Ms Shirley Bradley-এর নিয়োগ | 2 পৃষ্ঠা | AP01 | ||||||||||||||
পরিচালক হিসাবে Nigel John Arthur-এর নিয়োগ | 2 পৃষ্ঠা | AP01 | ||||||||||||||
পরিচালক হিসাবে Michelle Macmahon এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ০৬ সেপ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 4 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||||||
পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি | 16 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||||||
পরিচালক হিসাবে Shirley Bradley এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||||||
পরিচালক হিসাবে Michelle Louise Macmahon-এর নিয়োগ | 2 পৃষ্ঠা | AP01 | ||||||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ০৬ সেপ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 3 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||||||
পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি | 16 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||||||
পরিচালক হিসাবে Julia Seary এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||||||
পরিচালক হিসাবে Ms Shirley Bradley-এর নিয়োগ | 2 পৃষ্ঠা | AP01 | ||||||||||||||
পরিচালক হিসাবে David Hallisey এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||||||
পরিচালক হিসাবে Julia Louise Seary-এর নিয়োগ | 2 পৃষ্ঠা | AP01 | ||||||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ০৬ সেপ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 4 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||||||
পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি | 13 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||||||
০৬ নভে, ২০০৯ তারিখে Mr David Michael William Hallisey-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||||||||||||||
২৭ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Ms Shirley Bradley-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | CH03 | ||||||||||||||
CLOSE NUMBER 12 LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?
নাম | নিয়োগ করা হয়েছে | পদত্যাগের তারিখ | ভূমিকা | ঠিকানা | কোম্পানি পরিচয় | বাসস্থানের দেশ | জাতীয়তা | জন্ম তারিখ | পেশা | নম্বর |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRADLEY, Shirley | সচিব | Coningsby Road PE3 8SB Peterborough The Thomas Cook Business Park Cambs England | British | 65475670001 | ||||||
ARTHUR, Nigel John | পরিচালক | Coningsby Road PE3 8SB Peterborough The Thomas Cook Business Park Cambs England | England | English | Company Director | 175689210001 | ||||
BRADLEY, Shirley | পরিচালক | Coningsby Road PE3 8SB Peterborough The Thomas Cook Business Park Cambs England | England | British | Company Director | 65475670001 | ||||
THOMAS COOK GROUP MANAGEMENT SERVICES LIMITED | কর্পোরেট পরিচালক | Coningsby Road PE3 8SB Peterborough The Thomas Cook Business Park Cambs | 63592630007 | |||||||
BLACK, Nicola Suzanne | সচিব | Springfield 24 Drovers Way CM23 4GF Bishops Stortford Hertfordshire | British | 52160130002 | ||||||
HATCHER, Michael Roger | সচিব | Hunyani Ardleigh Road Little Bromley CO11 2QA Manningtree Essex | British | 6759000002 | ||||||
MASLEN, Frederick Charles Archibald | সচিব | 69 Hayes Hill Hayes BR2 7HN Bromley Kent | British | 3770350001 | ||||||
MCMAHON, Gregory Joseph | সচিব | Hollin Grove 5 Holly Grove Dobcross OL3 5JQ Oldham Lancashire | British | 49723980004 | ||||||
SLATTERY, Sharon Noelle, Mrs. | সচিব | 176 Blagdon Road KT3 4AL New Malden Surrey | Irish | 45487120004 | ||||||
STAFFORD, Paul Andrew | সচিব | 85 Roman Road IG1 2NZ Ilford Essex | British | Company Secretary | 48252270001 | |||||
ANDERSON, Ian Henry | পরিচালক | 31 Carrwood WA16 8NE Knutsford Cheshire | England | British | Director Of Group Treasury | 45953600001 | ||||
BRADLEY, Shirley | পরিচালক | Coningsby Road PE3 8SB Peterborough The Thomas Cook Business Park Cambs England | England | British | Company Director | 65475670001 | ||||
CUMMING, Andrew John | পরিচালক | 305 Mountjoy House Barbican EC2Y 8BP London | United Kingdom | British | Banker | 46297770002 | ||||
DAVIES, John Anthony | পরিচালক | Westmead Stables Weedon HP22 4NN Aylesbury Buckinghamshire | British | Banker | 32423210001 | |||||
DAVIES, John Thomas | পরিচালক | 2 Hearn Close Tylers Green HP10 8JT Penn Buckinghamshire | British | Banker | 2501430001 | |||||
FOAD, Allan Robert | পরিচালক | 19 Dukes Orchard DA5 2DU Bexley Kent | British | Banker | 40761160001 | |||||
FULLELOVE, William Roy | পরিচালক | 10 Ennismore Avenue GU1 1SP Guildford Surrey | British | Banker | 46128130001 | |||||
GREEN, Michael Jonathan | পরিচালক | 109 Hampstead Way NW11 7LR London | England | British | Banker | 141461000001 | ||||
HALLISEY, David Michael William | পরিচালক | Coningsby Road PE3 8SB Peterborough The Thomas Cook Business Park Cambs England | England | British | Solicitor | 1919030001 | ||||
HARRISON, David Henry Arnold | পরিচালক | Woodcote Lodge West Horsley KT24 6ET Leatherhead Surrey | Uk | British | Banker | 8949580001 | ||||
KING, Roger Steuart | পরিচালক | 9 Kingfisher House No 6 Melbury Road W14 8LN London | United States Citizen | Credit Director | 79713690002 | |||||
MACMAHON, Michelle Louise | পরিচালক | Coningsby Road PE3 8SB Peterborough The Thomas Cook Business Park Cambs England | United Kingdom | British | Company Director | 158871950001 | ||||
MILES, Peter Bernard | পরিচালক | Brentwood House Winchester Road GU32 1JS West Meon Hampshire | British | Banker | 41327480001 | |||||
MILES, Peter Bernard | পরিচালক | Brentwood House Winchester Road GU32 1JS West Meon Hampshire | British | Banker | 41327480001 | |||||
MOORE, Alan Edward | পরিচালক | Flat 2, 20 Wigmore Street W1U 2RQ London | British | Deputy Group Chief Executive | 71480200001 | |||||
OLDHAM, Theresa Amanda | পরিচালক | 9 Hill Rise WA14 4QB Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | Solicitor | 58400630001 | ||||
PRITCHARD, David Peter | পরিচালক | 17 Thorney Crescent SW11 3TT London | England | British | Bank Director | 57244610001 | ||||
RIDING, Frederick Michael Peter | পরিচালক | York House Clifton Down Road BS8 4AG Clifton Bristol | British | Banker | 76317830002 | |||||
RODGER, Peter Robert Charles | পরিচালক | 16 Links Road Flackwell Heath HP10 9LY High Wycombe Buckinghamshire | United Kingdom | British | Head Of Group Tax | 29785680001 | ||||
SEARY, Julia Louise | পরিচালক | Coningsby Road PE3 8SB Peterborough The Thomas Cook Business Park Cambs England | United Kingdom | British | Legal Director | 158190160001 | ||||
SEGGINS, Roger Russell | পরিচালক | Marronwood 4 Kelvedon Avenue KT12 5ED Walton On Thames Surrey | British | Banker | 46846030003 | |||||
VOWLES, Anthony Brian | পরিচালক | Hopgardens Hopgarden Lane TN13 1PX Sevenoaks Kent | British | Director | 75134410001 |
CLOSE NUMBER 12 LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?
শ্রেণীবিন্যাস | তারিখ | স্থিতি | বিস্তারিত | |
---|---|---|---|---|
Deed of covenant | তৈরি করা হয়েছে ০৫ জুন, ১৯৮৭ ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জুন, ১৯৮৭ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ £22,986,400 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever, and the terms of a financial agreement d/d 31/3/85 and an agreement supplemental thereto d/d 24/3/87 and this charge | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ All the co.'s rights, title, interest and benefit present and future in and under a) M.V. "ironsbridge" (reg as above) b) the earnings and insurances of the vessel and any compensation payable in respect of requisition for title or other compulsory aquisition of the vessel. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Statutory mortgage | তৈরি করা হয়েছে ০৫ জুন, ১৯৮৭ ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জুন, ১৯৮৭ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current regulated by a financial agrement d/d 21/3/85 on an agreement supplemental thereto d/d 24/3/87 and a deed of covenant d/d 5/6/87 | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ 64/64TH shares of and in M.V. "ironbridge" reg in the name of the company at the port of london, official number : 712847. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Financial agreement | তৈরি করা হয়েছে ২১ মার্চ, ১৯৮৫ ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ এপ্রি, ১৯৮৫ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ £22,986,400 due from the company to the chargee and any other monies due under the terms of the charge & a building agreement dated 21/3/84. | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ An interest rights & title under the building contract. (For full details see doc M25). | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Shipowners agremeent | তৈরি করা হয়েছে ২১ মার্চ, ১৯৮৫ ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ এ প্রি, ১৯৮৫ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and a financial agreement dated 21.3.85. | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ Any monies payable to the company out of the proceeds of sale of or of insurance claims in respect of the vessel under construction under the building agreement. The vessel under construction. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Deed of covenant | তৈরি করা হয়েছে ১৮ জুন, ১৯৮২ ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ জুল, ১৯৮২ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ For further security £7,950,814 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a financial agreement dated 11/02/81 as amended by a supplemental financial agreement dated 18/6/82 secured by a charge dated 18/6/82. | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ The mortkgaged premises (being the ship the insurances the earnings of the ship, the requisition compensation all as defined in the said deed of covenant. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Statutory mortgage | তৈরি করা হয়েছে ১৮ জুন, ১৯৮২ ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ জুল, ১৯৮২ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from the company to the chargee on account current under the terms of a financial agreement dated 11/2/81 as amended by a supplemental financial agreement dated 18/6/82 and deed of covenant of even date herewith | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ 64/64TH shares in M.V. "patricia" registered at london official no 399094. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Financial agreement | তৈরি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ১৯৮১ ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ১৯৮১ |