CLOSE NUMBER 12 LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCLOSE NUMBER 12 LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01387401
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    CLOSE NUMBER 12 LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য ব্যবসা সহায়তা পরিষেবা কার্যক্রম ন.এ.সি. (82990) / প্রশাসনিক এবং সহায়ক পরিষেবা কার্যক্রম

    CLOSE NUMBER 12 LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    The Thomas Cook Business Park
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    Cambs
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    CLOSE NUMBER 12 LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    MYTRAVEL AVIATION LEASING LIMITED০৩ মার্চ, ২০০৪০৩ মার্চ, ২০০৪
    OMICRON EQUIPMENT LEASING (ORANGE) LIMITED১১ ডিসে, ২০০৩১১ ডিসে, ২০০৩
    LLOYDS EQUIPMENT LEASING LIMITED০৬ সেপ, ১৯৭৮০৬ সেপ, ১৯৭৮

    CLOSE NUMBER 12 LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০১২

    CLOSE NUMBER 12 LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    CLOSE NUMBER 12 LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    6 পৃষ্ঠা4.71

    বার্ষিক রিটার্ন ০৬ সেপ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৯ সেপ, ২০১৩

    ০৯ সেপ, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100,000
    SH01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন

    LRESSP

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed mytravel aviation leasing LIMITED\certificate issued on 16/07/13
    3 পৃষ্ঠাCERTNM
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name১৬ জুল, ২০১৩

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ১৬ জুল, ২০১৩

    RES15
    change-of-name১৬ জুল, ২০১৩

    রেজোলিউশন দ্বারা নাম পরিবর্তন

    NM01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    16 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Ms Shirley Bradley-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Nigel John Arthur-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Michelle Macmahon এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৬ সেপ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    16 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Shirley Bradley এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Michelle Louise Macmahon-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৬ সেপ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    16 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Julia Seary এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Ms Shirley Bradley-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে David Hallisey এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Julia Louise Seary-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৬ সেপ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    ০৬ নভে, ২০০৯ তারিখে Mr David Michael William Hallisey-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২৭ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Ms Shirley Bradley-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    CLOSE NUMBER 12 LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BRADLEY, Shirley
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    England
    সচিব
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    England
    British65475670001
    ARTHUR, Nigel John
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    England
    পরিচালক
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    England
    EnglandEnglishCompany Director175689210001
    BRADLEY, Shirley
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    England
    পরিচালক
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    England
    EnglandBritishCompany Director65475670001
    THOMAS COOK GROUP MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    কর্পোরেট পরিচালক
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    63592630007
    BLACK, Nicola Suzanne
    Springfield
    24 Drovers Way
    CM23 4GF Bishops Stortford
    Hertfordshire
    সচিব
    Springfield
    24 Drovers Way
    CM23 4GF Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British52160130002
    HATCHER, Michael Roger
    Hunyani Ardleigh Road
    Little Bromley
    CO11 2QA Manningtree
    Essex
    সচিব
    Hunyani Ardleigh Road
    Little Bromley
    CO11 2QA Manningtree
    Essex
    British6759000002
    MASLEN, Frederick Charles Archibald
    69 Hayes Hill
    Hayes
    BR2 7HN Bromley
    Kent
    সচিব
    69 Hayes Hill
    Hayes
    BR2 7HN Bromley
    Kent
    British3770350001
    MCMAHON, Gregory Joseph
    Hollin Grove
    5 Holly Grove Dobcross
    OL3 5JQ Oldham
    Lancashire
    সচিব
    Hollin Grove
    5 Holly Grove Dobcross
    OL3 5JQ Oldham
    Lancashire
    British49723980004
    SLATTERY, Sharon Noelle, Mrs.
    176 Blagdon Road
    KT3 4AL New Malden
    Surrey
    সচিব
    176 Blagdon Road
    KT3 4AL New Malden
    Surrey
    Irish45487120004
    STAFFORD, Paul Andrew
    85 Roman Road
    IG1 2NZ Ilford
    Essex
    সচিব
    85 Roman Road
    IG1 2NZ Ilford
    Essex
    BritishCompany Secretary48252270001
    ANDERSON, Ian Henry
    31 Carrwood
    WA16 8NE Knutsford
    Cheshire
    পরিচালক
    31 Carrwood
    WA16 8NE Knutsford
    Cheshire
    EnglandBritishDirector Of Group Treasury45953600001
    BRADLEY, Shirley
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    England
    পরিচালক
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    England
    EnglandBritishCompany Director65475670001
    CUMMING, Andrew John
    305 Mountjoy House
    Barbican
    EC2Y 8BP London
    পরিচালক
    305 Mountjoy House
    Barbican
    EC2Y 8BP London
    United KingdomBritishBanker46297770002
    DAVIES, John Anthony
    Westmead Stables
    Weedon
    HP22 4NN Aylesbury
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Westmead Stables
    Weedon
    HP22 4NN Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishBanker32423210001
    DAVIES, John Thomas
    2 Hearn Close
    Tylers Green
    HP10 8JT Penn
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    2 Hearn Close
    Tylers Green
    HP10 8JT Penn
    Buckinghamshire
    BritishBanker2501430001
    FOAD, Allan Robert
    19 Dukes Orchard
    DA5 2DU Bexley
    Kent
    পরিচালক
    19 Dukes Orchard
    DA5 2DU Bexley
    Kent
    BritishBanker40761160001
    FULLELOVE, William Roy
    10 Ennismore Avenue
    GU1 1SP Guildford
    Surrey
    পরিচালক
    10 Ennismore Avenue
    GU1 1SP Guildford
    Surrey
    BritishBanker46128130001
    GREEN, Michael Jonathan
    109 Hampstead Way
    NW11 7LR London
    পরিচালক
    109 Hampstead Way
    NW11 7LR London
    EnglandBritishBanker141461000001
    HALLISEY, David Michael William
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    England
    পরিচালক
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    England
    EnglandBritishSolicitor1919030001
    HARRISON, David Henry Arnold
    Woodcote Lodge
    West Horsley
    KT24 6ET Leatherhead
    Surrey
    পরিচালক
    Woodcote Lodge
    West Horsley
    KT24 6ET Leatherhead
    Surrey
    UkBritishBanker8949580001
    KING, Roger Steuart
    9 Kingfisher House
    No 6 Melbury Road
    W14 8LN London
    পরিচালক
    9 Kingfisher House
    No 6 Melbury Road
    W14 8LN London
    United States CitizenCredit Director79713690002
    MACMAHON, Michelle Louise
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    England
    পরিচালক
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    England
    United KingdomBritishCompany Director158871950001
    MILES, Peter Bernard
    Brentwood House
    Winchester Road
    GU32 1JS West Meon
    Hampshire
    পরিচালক
    Brentwood House
    Winchester Road
    GU32 1JS West Meon
    Hampshire
    BritishBanker41327480001
    MILES, Peter Bernard
    Brentwood House
    Winchester Road
    GU32 1JS West Meon
    Hampshire
    পরিচালক
    Brentwood House
    Winchester Road
    GU32 1JS West Meon
    Hampshire
    BritishBanker41327480001
    MOORE, Alan Edward
    Flat 2, 20 Wigmore Street
    W1U 2RQ London
    পরিচালক
    Flat 2, 20 Wigmore Street
    W1U 2RQ London
    BritishDeputy Group Chief Executive71480200001
    OLDHAM, Theresa Amanda
    9 Hill Rise
    WA14 4QB Altrincham
    Cheshire
    পরিচালক
    9 Hill Rise
    WA14 4QB Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritishSolicitor58400630001
    PRITCHARD, David Peter
    17 Thorney Crescent
    SW11 3TT London
    পরিচালক
    17 Thorney Crescent
    SW11 3TT London
    EnglandBritishBank Director57244610001
    RIDING, Frederick Michael Peter
    York House
    Clifton Down Road
    BS8 4AG Clifton
    Bristol
    পরিচালক
    York House
    Clifton Down Road
    BS8 4AG Clifton
    Bristol
    BritishBanker76317830002
    RODGER, Peter Robert Charles
    16 Links Road
    Flackwell Heath
    HP10 9LY High Wycombe
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    16 Links Road
    Flackwell Heath
    HP10 9LY High Wycombe
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishHead Of Group Tax29785680001
    SEARY, Julia Louise
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    England
    পরিচালক
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    England
    United KingdomBritishLegal Director158190160001
    SEGGINS, Roger Russell
    Marronwood 4 Kelvedon Avenue
    KT12 5ED Walton On Thames
    Surrey
    পরিচালক
    Marronwood 4 Kelvedon Avenue
    KT12 5ED Walton On Thames
    Surrey
    BritishBanker46846030003
    VOWLES, Anthony Brian
    Hopgardens
    Hopgarden Lane
    TN13 1PX Sevenoaks
    Kent
    পরিচালক
    Hopgardens
    Hopgarden Lane
    TN13 1PX Sevenoaks
    Kent
    BritishDirector75134410001

    CLOSE NUMBER 12 LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Deed of covenant
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ জুন, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জুন, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £22,986,400 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever, and the terms of a financial agreement d/d 31/3/85 and an agreement supplemental thereto d/d 24/3/87 and this charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the co.'s rights, title, interest and benefit present and future in and under a) M.V. "ironsbridge" (reg as above) b) the earnings and insurances of the vessel and any compensation payable in respect of requisition for title or other compulsory aquisition of the vessel.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ জুন, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ৩০ ডিসে, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Statutory mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ জুন, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জুন, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current regulated by a financial agrement d/d 21/3/85 on an agreement supplemental thereto d/d 24/3/87 and a deed of covenant d/d 5/6/87
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    64/64TH shares of and in M.V. "ironbridge" reg in the name of the company at the port of london, official number : 712847.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ জুন, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৭ এপ্রি, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Financial agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২১ মার্চ, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ এপ্রি, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £22,986,400 due from the company to the chargee and any other monies due under the terms of the charge & a building agreement dated 21/3/84.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    An interest rights & title under the building contract. (For full details see doc M25).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ এপ্রি, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ৩০ ডিসে, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Shipowners agremeent
    তৈরি করা হয়েছে ২১ মার্চ, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ এপ্রি, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and a financial agreement dated 21.3.85.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any monies payable to the company out of the proceeds of sale of or of insurance claims in respect of the vessel under construction under the building agreement. The vessel under construction.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    ব্যবসায়
    • ০৪ এপ্রি, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ৩০ ডিসে, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of covenant
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ জুন, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ জুল, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    For further security £7,950,814 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a financial agreement dated 11/02/81 as amended by a supplemental financial agreement dated 18/6/82 secured by a charge dated 18/6/82.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The mortkgaged premises (being the ship the insurances the earnings of the ship, the requisition compensation all as defined in the said deed of covenant.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ জুল, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    Statutory mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ জুন, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ জুল, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on account current under the terms of a financial agreement dated 11/2/81 as amended by a supplemental financial agreement dated 18/6/82 and deed of covenant of even date herewith
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    64/64TH shares in M.V. "patricia" registered at london official no 399094.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ জুল, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    Financial agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ১৯৮১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ১৯৮১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (I) all the rights, benefits and titles under a building contract dated 12 march 1980 (ii) all monies payable by the company in respect of the insurances effected by the builder under the contract.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ ফেব, ১৯৮১একটি চার্জের নিবন্ধন
    Delivery order
    তৈরি করা হয়েছে ১১ ফেব, ১৯৮১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ১৯৮১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The said ship no. 530 as she is constructed and all the said appurtenances and components.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank LTD.
    ব্যবসায়
    • ২৩ ফেব, ১৯৮১একটি চার্জের নিবন্ধন
    Bond and assignation
    তৈরি করা হয়েছে ১১ ফেব, ১৯৮১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ১৯৮১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a financial agreement dated 11 february 1981
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (I) all the rights, benefits and titles under a building contract dated 12 march 1980 (ii) all monies payable by the company in respect of the insurances effected by the builder under the contract.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ ফেব, ১৯৮১একটি চার্জের নিবন্ধন

    CLOSE NUMBER 12 LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২৭ আগ, ২০১৩ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ১৮ মে, ২০১৪ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Peter James Greaves
    Cornwall Court 19 Cornwall St
    B3 2DT Birmingham
    অভ্যাসকারী
    Cornwall Court 19 Cornwall St
    B3 2DT Birmingham
    Timothy Gerard Walsh
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    অভ্যাসকারী
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0